Buscador CIF Logo

Actos BORME 4finance Spain Financial Services Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera 4finance Spain Financial Services Sa

Actos BORME 4finance Spain Financial Services Sa - A86521309

Tenemos registrados 28 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para 4finance Spain Financial Services Sa con CIF A86521309

🔙 Perfil de 4finance Spain Financial Services Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de 4finance Spain Financial Services Sa

14 de Diciembre de 2023
Revocaciones. Apoderado: MARTIN BELTRAN JESUS. Datos registrales. T 37257 , F 21, S 8, H M 544749, I/A 55 ( 5.12.23).

24 de Noviembre de 2023
Revocaciones. Apoderado: POLO DE LARA BUSCA ESPERANZA MACARENA. Nombramientos. Auditor: PKF ATTESTSERVICIOS EMPRESARIALES SL. Datos registrales. T 37257 , F 20, S 8, H M 544749, I/A 54 (17.11.23).

22 de Mayo de 2023
Nombramientos. Apoderado: BARTOLOVICA IVETA. Datos registrales. T 37257 , F 20, S 8, H M 544749, I/A 53 (12.05.23).

03 de Febrero de 2023
Nombramientos. Apoderado: MARTIN BELTRAN JESUS. Datos registrales. T 37257 , F 20, S 8, H M 544749, I/A 52 (27.01.23).

19 de Octubre de 2022
Revocaciones. Apoderado: TRONCO CANTALEJO VANESA. Nombramientos. Apo.Sol.: RAFAEL ORTIZ JORGE. Datosregistrales. T 37257 , F 20, S 8, H M 544749, I/A 51 (12.10.22).

21 de Junio de 2022
Nombramientos. Apoderado: REDONDO PINO IRENE. Datos registrales. T 37257 , F 19, S 8, H M 544749, I/A 50 (14.06.22).

20 de Mayo de 2022
Revocaciones. Apoderado: ADRADOS VERDEJO MARIA AUXILIADORA. Apo.Sol.: NARVAEZ MOTTA CLAUDIA YANIRI.Nombramientos. Apo.Man.Soli: ORTEGA RODRIGUEZ GONZALO. Apo.Sol.: SAN MIGUEL SAEZ NURIA. Apo.Man.Soli:FERNANDEZ-TRUJILLO GONZALEZ NADIA. Datos registrales. T 37257 , F 16, S 8, H M 544749, I/A 49 (12.05.22).

11 de Abril de 2022
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: METOCHKIN ANTON. Nombramientos. Adm. Unico: CEVERE ALISA. Datos registrales. T37257 , F 16, S 8, H M 544749, I/A 48 ( 4.04.22).

13 de Diciembre de 2021
Revocaciones. Apoderado: GOMEZ DIAZ JIMENEZ MARIA. Datos registrales. T 37257 , F 16, S 8, H M 544749, I/A 47 ( 2.12.21).

02 de Julio de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: CEVERE ALISA. Datos registrales. T 37257 , F 13, S 8, H M 544749, I/A 46 (25.06.21).

04 de Junio de 2021
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GOLDFINCH PAUL. Nombramientos. Adm. Unico: METOCHKIN ANTON. Datos registrales. T37257 , F 13, S 8, H M 544749, I/A 44 (28.05.21).

Revocaciones. Apoderado: SANTILLAN GUSTAVO ALEJANDRO. Datos registrales. T 37257 , F 13, S 8, H M 544749, I/A 45(28.05.21).

21 de Enero de 2021
Cambio de domicilio social. C/ ALBASANZ 14, PLANTA BAJA (MADRID). Datos registrales. T 37257 , F 13, S 8, H M 544749, I/A43 (14.01.21).

11 de Enero de 2021
Ceses/Dimisiones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL.Datos registrales. T 37257 , F 12, S 8, H M 544749, I/A 42 ( 3.01.21).

07 de Julio de 2020
Cambio de domicilio social. C/ ORENSE 34 - 5ª PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 37257 , F 12, S 8, H M 544749, I/A 41(30.06.20).

03 de Julio de 2020
Nombramientos. Apoderado: TRONCO CANTALEJO VANESA. Datos registrales. T 37257 , F 12, S 8, H M 544749, I/A 40(26.06.20).

23 de Junio de 2020
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 37257 , F 11, S 8, H M 544749, I/A 39 (16.06.20).

20 de Mayo de 2020
Revocaciones. Apoderado: MUÑOZ CESPEDES SILVIA;VELASCO CALLE CARLOS. Datos registrales. T 37257 , F 11, S 8, H M544749, I/A 38 (12.05.20).

19 de Noviembre de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: NARVAEZ MOTTA CLAUDIA YANIRI;PALACIOS ACEÑA MARIA VICTORIA. Datos registrales. T 37257, F 9, S 8, H M 544749, I/A 36 (12.11.19).

Revocaciones. Apoderado: CAMPO OLLEROS MONICA. Apo.Man.Soli: CLEMENTE BEJARANO GIOVANI FRANCISCO.Nombramientos. Apo.Man.Soli: ASO FERRER ANGELA;LOPEZ DORREGO ANA;CAMPO OLLEROS MONICA. Datos registrales.T 37257 , F 10, S 8, H M 544749, I/A 37 (12.11.19).

14 de Enero de 2019
Revocaciones. Apoderado: CRESPO MARTIN-ALBO SERGIO;GONZALEZ RUIZ OSCAR;RICO CONTRERA RAFAEL;CERQUEIRASANCHEZ MARTA. Datos registrales. T 37257 , F 8, S 8, H M 544749, I/A 35 ( 4.01.19).

07 de Noviembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: SANTILLAN GUSTAVO ALEJANDRO. Datos registrales. T 37257 , F 6, S 8, H M 544749, I/A 34(30.10.18).

09 de Agosto de 2018
Revocaciones. Apoderado: VAJDA GUERRERO MARIA ELENA;VAJDA GUERRERO MARIA ELENA. Apo.Sol.: VAJDA GUERREROELENA. Apoderado: BAÑO SANCHEZ OSCAR;VAJDA GUERRERO MARIA ELENA;MONREAL CANTO HUGO JULIO.Nombramientos. Apoderado: CERQUEIRA SANCHEZ MARTA;NAVIO LARIO SONIA. Apo.Man.Soli: CLEMENTE BEJARANOGIOVANI FRANCISCO. Datos registrales. T 37257 , F 3, S 8, H M 544749, I/A 33 ( 1.08.18).

20 de Febrero de 2018
Revocaciones. Apoderado: MURILLO MARTINEZ JESSICA;MOYA VINAGRE MARIA;MATEOS GHOSH ARACELIMARIA;HERNANDEZ GARCIA AINARA;ADRADOS VERDEJO MARIA AUXILIADORA;POLO DE LARA BUSCA ESPERANZAMACARENA;VAJDA GUERRERO MARIA ELENA;CRESPO MARTIN-ALBO SERGIO;PALOMO LULL BEATRIZ;MUÑOZ CESPEDESSILVIA;REINALDO CAMPOS DANIEL;RICO CONTRERA RAFAEL;VELASCO CALLE CARLOS;URBINA SANCHEZ RAFAEL.Apo.Man.Soli: BAÑO SANCHEZ OSCAR;AMARILLA GARCIA IGNACIO. Apo.Sol.: CAMPO OLLEROS MONICA;RODRIGUEZVALENCIA RUTH. Nombramientos. Apoderado: BAÑO SANCHEZ OSCAR;CRESPO MARTIN-ALBO SERGIO;POLO DE LARABUSCA ESPERANZA MACARENA;VAJDA GUERRERO MARIA ELENA;MONREAL CANTO HUGO JULIO;GONZALEZ RUIZOSCAR;GOMEZ DIAZ JIMENEZ MARIA;CAMPO OLLEROS MONICA;RODRIGUEZ VALENCIA RUTH;PALOMO LULLBEATRIZ;HERNANDEZ GARCIA AINARA;MUÑOZ CESPEDES SILVIA;REINALDO CAMPOS DANIEL;RICO CONTRERARAFAEL;URBINA SANCHEZ RAFAEL;VELASCO CALLE CARLOS;MOYA VINAGRE MARIA;ADRADOS VERDEJO MARIA

19 de Diciembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GARCIA CASADO JOSE MARIA. Nombramientos. Adm. Unico: GOLDFINCH PAUL. Datosregistrales. T 33735 , F 83, S 8, H M 544749, I/A 31 (12.12.17).

28 de Junio de 2017
Revocaciones. Apoderado: ARDERIUS SALVADOR BEATRIZ;SOBRECUEVA GUTIERREZ CARMEN;HENARES MARTINEZIVAN;VELA RUIZ MARIA DEL CARMEN;HENARES MARTINEZ IVAN. Nombramientos. Apo.Man.Soli: BAÑO SANCHEZOSCAR;AMARILLA GARCIA IGNACIO. Apo.Sol.: CAMPO OLLEROS MONICA;RODRIGUEZ VALENCIA RUTH. Datos registrales. T33735 , F 81, S 8, H M 544749, I/A 30 (19.06.17).

16 de Marzo de 2017
Revocaciones. Apo.Man.Soli: BARAHONA GARCIA MIGUEL. Apoderado: ROALES NIETO-SANCHEZ LEOPOLDO. Datosregistrales. T 33735 , F 81, S 8, H M 544749, I/A 28 ( 9.03.17).

Nombramientos. Apo.Sol.: VAJDA GUERRERO ELENA. Datos registrales. T 33735 , F 81, S 8, H M 544749, I/A 29 ( 9.03.17).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información