Actos BORME de A. Pazos De Lusco Sl
10 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: GUIMERA GIRON SALVADOR;ALEN TRESANDI SERGIO. Apo.Manc.: JIMENEZ AGUILARMANUEL. Datos registrales. T 4134, L 4134, F 102, S 8, H PO 41666, I/A 37 (30.10.23).
31 de Marzo de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: JIMENEZ AGUILAR MANUEL. Apo.Manc.: JIMENEZ AGUILAR MANUEL;GOMEZ VILCHESFRANCISCO-JAVIER;GARZON MORENO LORENZO;MEJIAS BERNAL JUAN DE DIOS;JIMENEZ AGUILAR MANUEL;GARZONMORENO LORENZO. Apo.Sol.: JIMENEZ AGUILAR MANUEL;GOMEZ VILCHES FRANCISCO-JAVIER;GOMEZ VILCHESFRANCISCO-JAVIER;ACEDO MOLINA JOSE;ROSADO MOLINA CARMEN;CLAVIJO GARCIA MANUEL JESUS;MATEOS POMARSALVE;USERO ROBLES IRENE. Datos registrales. T 4134, L 4134, F 98, S 8, H PO 41666, I/A 36 (24.03.23).
27 de Febrero de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: GROSSE MAC DOUGALL JORGE A. Nombramientos. Consejero: SANCHEZ MORAL CESARTOMAS. Datos registrales. T 4134, L 4134, F 95, S 8, H PO 41666, I/A 33 (17.02.23).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GROSSE MAC DOUGALL JORGE A.;GROSSE MAC DOUGALL JORGE-ALBERTO. Datosregistrales. T 4134, L 4134, F 96, S 8, H PO 41666, I/A 34 (17.02.23).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ-GORDON LOPEZ DE CARRIZOSA MAURICIO;REBUELTA DEL PEDREROGONZALEZ PEDRO;SANCHEZ MORAL CESAR TOMAS. Datos registrales. T 4134, L 4134, F 98, S 8, H PO 41666, I/A 35(17.02.23).
20 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: ARTASONA LARROSA ENRIQUE;ALEN TRESANDI SERGIO. Apo.Manc.: ARTASONA LARROSAENRIQUE;JIMENEZ AGUILAR MANUEL;ALEN TRESANDI SERGIO. Datos registrales. T 4134, L 4134, F 95, S 8, H PO 41666, I/A32 ( 8.10.21).
03 de Agosto de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: GROSSE MAC DOUGALL JORGE-ALBERTO;JIMENEZ AGUILAR MANUEL;GOMEZ VILCHESFRANCISCO-JAVIER;MEJIAS BERNAL JUAN DE DIOS;GARZON MORENO LORENZO. Apo.Sol.: ROSADO MOLINACARMEN;CLAVIJO GARCIA MANUEL JESUS;MATEOS POMAR SALVE;USERO ROBLES IRENE. Datos registrales. T 4134, L4134, F 93, S 8, H PO 41666, I/A 31 (23.07.21).
01 de Octubre de 2019Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2015 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 4134, L 4134, F 93, S 8, H PO 41666, I/A 30 (25.09.19).
14 de Julio de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.290.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.298.524,00 Euros. Datos registrales. T 4134, L 4134, F93, S 8, H PO 41666, I/A 29 ( 6.07.16).
28 de Junio de 2016Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GONZALEZ BYASS S.A. Datos registrales. T 4134, L 4134, F 90, S 8, H PO41666, I/A 22 (20.06.16).
Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/8. Otros conceptos: Se modifica el art铆culo 14 de los Estatutosrelativo al cierre del ejercicio social. Datos registrales. T 4134, L 4134, F 90, S 8, H PO 41666, I/A 23 (20.06.16).
Revocaciones. Apoderado: LOUREIRO VARELA CARLOS FRANCISCO. Datos registrales. T 4134, L 4134, F 90, S 8, H PO41666, I/A 24 (20.06.16).
Nombramientos. Apo.Sol.: MURILLO SANROMA ENRIQUE;SUAREZ PERDIGONES PEDRO;MURILLO SANROMAENRIQUE;SUAREZ PERDIGONES PEDRO;MEJIAS BERNAL JUAN DE DIOS;GARZON MORENO LORENZO. Apo.Manc.: MURILLOSANROMA ENRIQUE;MURILLO SANROMA ENRIQUE;SUAREZ PERDIGONES PEDRO;SUAREZ PERDIGONES PEDRO;GARZONMORENO LORENZO;MEJIAS BERNAL JUAN DE DIOS;SUAREZ PERDIGONES PEDRO;MEJIAS BERNAL JUAN DE DIOS;GARZONMORENO LORENZO. Apo.Sol.: CLAVIJO GARCIA MANUEL JESUS. Apo.Manc.: MEJIAS BERNAL JUAN DE DIOS;GARZONMORENO LORENZO. Apo.Sol.: MATEOS POMAR SALVE;USERO ROBLES IRENE. Datos registrales. T 4134, L 4134, F 90, S 8, HPO 41666, I/A 25 (20.06.16).
Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ MARTIN JUAN MANUEL;BELLIDO PEREZ FRANCISCA. Datos registrales. T 4134, L 4134,F 91, S 8, H PO 41666, I/A 26 (20.06.16).
Nombramientos. Apoderado: GUIMERA GIRON SALVADOR. Datos registrales. T 4134, L 4134, F 92, S 8, H PO 41666, I/A 27(20.06.16).
Nombramientos. Apo.Sol.: GRANADOS CORONA CRISTINA;ROMERO GARCIA-DELGADO MARIA. Datos registrales. T 4134, L4134, F 92, S 8, H PO 41666, I/A 28 (20.06.16).
27 de Junio de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LOPEZ ALONSO ELISEO. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ-GORDON LOPEZ DECARRIZOSA MAURICIO;REBUELTA DEL PEDRERO GONZALEZ PEDRO;GROSSE MAC DOUGALL JORGE A. Apo.Man.Soli:GONZALEZ-GORDON LOPEZ DE CARRIZOSA MAURICIO;REBUELTA DEL PEDRERO GONZALEZ PEDRO;GROSSE MACDOUGALL JORGE A. Presidente: GONZALEZ-GORDON LOPEZ DE CARRIZOSA MAURICIO. SecreNoConsj: GRANADOS CORONACRISTINA. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datosregistrales. T 3268, L 3268, F 158, S 8, H PO 41666, I/A 21 (17.06.16).
13 de Mayo de 2016Revocaciones. Auditor: EVIDENTIA AUDITORES SLP. Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.508.524,00 Euros. Resultante Suscrito:2.008.524,00 Euros. Datos registrales. T 3268, L 3268, F 158, S 8, H PO 41666, I/A 20 ( 5.05.16).
17 de Febrero de 2016Nombramientos. Auditor: EVIDENTIA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3268, L 3268, F 157, S 8, H PO 41666, I/A 19 (5.02.16).
28 de Diciembre de 2015Revocaciones. Apo.Manc.: GONZALEZ MITTELBRUNN PEDRO;DIZ VARELA VICENTE MANUEL. Datos registrales. T 3268, L3268, F 157, S 8, H PO 41666, I/A 18 (17.12.15).
02 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: RICO RAPOSO MARIO. Datos registrales. T 3268, L 3268, F 157, S 8, H PO 41666, I/A 16(24.11.15).
Nombramientos. Adm. Unico: LOPEZ ALONSO ELISEO. Datos registrales. T 3268, L 3268, F 157, S 8, H PO 41666, I/A 17(25.11.15).
03 de Enero de 2013Fe de erratas: SENTENCIA FIRME DICTADA POR LA SECCION 1潞 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA ENFECHA 30 DE MAYO DE 2012. Datos registrales. T 3268, L 3268, F 157, S 8, H PO 41666, I/A 15 (20.12.12).
23 de Mayo de 2011Nombramientos. Auditor: QUALITY MANAGEMENT AUDITORES DE CUENTAS SL. Datos registrales. T 3268, L 3268, F 156, S 8,H PO 41666, I/A 14 ( 9.05.11).
21 de Octubre de 2010Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: RICO RAPOSO MARIO. Nombramientos. Adm. Unico: LOUREIRO VARELA CARLOSFRANCISCO. Datos registrales. T 3268, L 3268, F 156, S 8, H PO 41666, I/A 13 ( 8.10.10).
14 de Junio de 2010Nombramientos. Apoderado: LOUREIRO VARELA CARLOS FRANCISCO. Datos registrales. T 3268, L 3268, F 156, S 8, H PO41666, I/A 12 ( 2.06.10).
27 de Mayo de 2009Nombramientos. Auditor: GONZALEZ TENORIO PABLO. Datos registrales. T 3268, L 3268, F 155, S 8, H PO 41666, I/A 11(15.05.09).