Actos BORME de Ab Azucarera Iberia Sl
13 de Noviembre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: NOBLE CHARLES. Datos registrales. T 41413 , F 110, S 8, H M 74579, I/A 191 ( 3.11.23).
10 de Octubre de 2023Ampliacion del objeto social. Prestación de servicios agrícolas a los cultivadores de remolacha azucarera que incluyen, con carácterenunciativo y no limitativo, el asesoramiento agronómico, los servicios de recolección, siembra, alquiler de maquinaria agrícola, gestiónde transporte de remolacha. Datos registrales. T 41413 , F 109, S 8, H M 74579, I/A 190 ( 3.10.23).
18 de Julio de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: HIDALGO LOPEZ JAVIER. Apo.Sol.: MARTI RODRIGUEZ PATRICIA. Otros conceptos: Revocadala facultad 5 del poder autorizado por el notario don Andres Dominguez Nafría el día 12 de mayo de 2014, número 1773 de suprotocolo, causante de la inscripción 118ª, otorgado a favor de don Miguel Angel Sanroman Montero, quedando el resto de la escriturainalterable en todos sus términos. Revocada la facultad 5 del poder autorizado por el notario don Luis J. Ramallo García, día 12 dejunio de 2002, número 664 de protocolo, inscripción 27ª, otorgado a favor de don Juan José Isacelaya Rodríguez y don Alfonso MorenoBotija, quedando el resto de la escritura inalterable. Revocada la facultad 7 del poder autorizado por el notario don Andres DominguezNafría el día 18 de diciembre de 2013, número 5031 de su protocolo, causante de la inscripción 108ª, otorgado a favor de donFrancisco José Aguilocho Ceballos, quedando el resto de la escritura inalterable. Revocada la facultad 7 del poder autorizado por elnotario don Luis J. Ramallo el día 7 de mayo de 2001, número 399 de su protocolo, causante de la inscripción 18ª, otorgado a favor dedon Javier Batrina Navarro, quedando el resto de la escritura inalterable en todos sus términos. Datos registrales. T 41413 , F 107, S8, H M 74579, I/A 187 (11.07.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: LLORENTE CLEMENTE OLIVIA. Datos registrales. T 41413 , F 108, S 8, H M 74579, I/A 188(11.07.23).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ CARRASCOSA ALMENARA FRANCISCO DE PAULA. Datos registrales. T 41413 , F108, S 8, H M 74579, I/A 189 (11.07.23).
19 de Junio de 2023Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 41413 , F 107, S 8, H M 74579, I/A 186 (12.06.23).
23 de Enero de 2023Nombramientos. Consejero: KENWARD PAUL ROBERT. Presidente: RIVERO XIMENES JUAN LUIS. Datos registrales. T 41413 ,F 107, S 8, H M 74579, I/A 185 (16.01.23).
02 de Diciembre de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: CARR MARK IAN. Presidente: CARR MARK IAN. Datos registrales. T 41413 , F 107, S 8, H M74579, I/A 184 (25.11.22).
28 de Noviembre de 2022Nombramientos. Apoderado: CARRERO HORCAJADA CRISTINA. Datos registrales. T 41413 , F 106, S 8, H M 74579, I/A 183(21.11.22).
01 de Julio de 2022Nombramientos. Apoderado: MORAL GARCIA CATERINA. Datos registrales. T 41413 , F 106, S 8, H M 74579, I/A 182 (24.06.22).
29 de Junio de 2022Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 41413 , F 106, S 8, H M 74579, I/A 181 (22.06.22).
24 de Marzo de 2022Nombramientos. Apoderado: PEREZ RUFIAN AMALIA. Datos registrales. T 41413 , F 104, S 8, H M 74579, I/A 179 (17.03.22).
Revocaciones. Apoderado: SANTOS CARRASCOSA FELIX;SANTOS CARRASCOSA FELIX. Datos registrales. T 41413 , F 105, S8, H M 74579, I/A 180 (17.03.22).
09 de Febrero de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: SANTOS CARRASCOSA FELIX. Secretario: SANTOS CARRASCOSA FELIX. Nombramientos.Consejero: NOBLE CHARLES;SALVO GARCIA LUIS. SecreNoConsj: PEREZ RUFIAN AMALIA. Datos registrales. T 41413 , F 104,S 8, H M 74579, I/A 178 ( 2.02.22).
11 de Octubre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: HACKETT BENJAMIN DENNIS. Datos registrales. T 41413 , F 104, S 8, H M 74579, I/A 177 (4.10.21).
03 de Septiembre de 2021Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 41413 , F 104, S 8, H M 74579, I/A 176 (27.08.21).
16 de Junio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: MARQUES CORBELLA MIREIA;DURAN LABIANO CAROL;SANTOS LORENZO MARIASALOME;FERNANDEZ BURRIEL INES;SALVO GARCIA LUIS. Datos registrales. T 41413 , F 102, S 8, H M 74579, I/A 174 (9.06.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: NAVAS DIAZ ALICIA. Datos registrales. T 41413 , F 102, S 8, H M 74579, I/A 175 ( 9.06.21).
21 de Abril de 2021Nombramientos. Apoderado: SERRANO MOLINA ELISEO;OLIVA FERNANDEZ JAIZKI. Datos registrales. T 34508 , F 48, S 8, H M74579, I/A 170 (14.04.21).
Revocaciones. Apoderado: GOMEZ ELVIRA FRANCISCO JAVIER. Apo.Man.Soli: BAS PARDO ANTONIO. Apo.Manc.: GOMEZELVIRA FRANCISCO JAVIER. Apoderado: OLIVA FERNANDEZ JAIZKI;MARTIN DOMINGUEZ FERNANDO;CORBALAN PORTILLOJUAN. Datos registrales. T 34508 , F 49, S 8, H M 74579, I/A 171 (14.04.21).
Nombramientos. Apoderado: PAULIÑE INUNCIAGA GARAZI. Datos registrales. T 41413 , F 101, S 8, H M 74579, I/A 172(14.04.21).
Nombramientos. Apoderado: SEVILLANO OLLERO MARIA EMILIA. Datos registrales. T 41413 , F 101, S 8, H M 74579, I/A 173(14.04.21).
08 de Febrero de 2021Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ FERNANDEZ CARLOS JAVIER. Datos registrales. T 34508 , F 48, S 8, H M 74579, I/A169 ( 1.02.21).
02 de Febrero de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA-VALDECASAS MORENO CRISTINA;MARTIN GUERRERO ALEJANDRO. Datosregistrales. T 34508 , F 47, S 8, H M 74579, I/A 168 (26.01.21).
24 de Julio de 2020Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 34508 , F 46, S 8, H M 74579, I/A 165 (17.07.20).
Modificaciones estatutarias. 15. Remuneración de los administradores.-. Datos registrales. T 34508 , F 46, S 8, H M 74579, I/A166 (17.07.20).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE SIMON BREZMES SANDRA. Datos registrales. T 34508 , F 46, S 8, H M 74579, I/A 167(17.07.20).
07 de Julio de 2020Nombramientos. Apo.Manc.: PAREDES MENENDEZ JAIRO. Apo.Sol.: PAREDES MENENDEZ JAIRO. Apo.Manc.: RODRIGUEZCIMIANO IRIS. Apo.Sol.: RODRIGUEZ CIMIANO IRIS. Datos registrales. T 34508 , F 45, S 8, H M 74579, I/A 163 (30.06.20).
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTI RODRIGUEZ PATRICIA. Datos registrales. T 34508 , F 45, S 8, H M 74579, I/A 164 (30.06.20).
24 de Febrero de 2020Nombramientos. Apo.Manc.: VELAZQUEZ SANCHEZ MARIA ESTELA. Datos registrales. T 34508 , F 44, S 8, H M 74579, I/A 161(17.02.20).
Revocaciones. Apoderado: JULIANA MARTINEZ DOMINGO;BORQUE PEREZ PEDRO. Datos registrales. T 34508 , F 45, S 8, HM 74579, I/A 162 (17.02.20).
18 de Octubre de 2019Cambio de domicilio social. C/ CARDENAL MARCELO SPINOLA - NUMERO 42 (MADRID). Datos registrales. T 34508 , F 43, S8, H M 74579, I/A 160 (11.10.19).
03 de Julio de 2019Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 34508 , F 43, S 8, H M 74579, I/A 159 (26.06.19).
03 de Junio de 2019Revocaciones. Apoderado: ALONSO JIMENEZ CARLOS J.;JIMENEZ LUQUE MIGUEL. Apo.Man.Soli: MUÑOZ RUIZ ALFONSO.Apoderado: DOMINGUEZ ELIAS PABLO. Apo.Man.Soli: DE LA CALLE GARCIA RAUL;LAMORENA MATA MIGUELANGEL;CAMAZON CARVAJAL JOSE ANTONIOApoderado: QUESADA PEDRAJAS RAFAEL. Apo.Man.Soli: SERRANO MOLINAELISEO;GONZALEZ DIEZ ANGELA;ARROYO LLORENTE BEATRIZ. Apo.Sol.: TORRES HOHR JUAN PEDRO. Datos registrales. T34508 , F 41, S 8, H M 74579, I/A 156 (27.05.19).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ MARTIN IGNACIO;BORONAT GIL MARIA ISABEL;HIDALGO LOPEZJAVIER;NAVARRO MILLAN JOSE;LOPEZ ALONSO PABLO;RODRIGUEZ ALVAREZ IGNACIO RICARDO. Datos registrales. T34508 , F 42, S 8, H M 74579, I/A 157 (27.05.19).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LUCEA QUINTANA AITOR. Datos registrales. T 34508 , F 42, S 8, H M 74579, I/A 158 (27.05.19).
21 de Febrero de 2019Otros conceptos: EL SOCIO UNICO DE LA SOCIEDAD, HA CAMBIADO LA DENOMINACION, SIENDO LA DENOMINACIONACTUAL "ABF IBERIA HOLDING S.L.".- Datos registrales. T 34508 , F 41, S 8, H M 74579, I/A 155 (14.02.19).
26 de Diciembre de 2018Revocaciones. Apoderado: CARAZO MARTINEZ JOSE MARIA;PELAEZ ARIAS CARLOS R. Apo.Man.Soli: PELAEZ ARIASCARLOS. Apoderado: SANCHEZ HOLGADO ALBERTO;CEPERO MOLI DANIEL. Apo.Man.Soli: GESTOSO GONZALEZ DOMINGO.Apo.Manc.: PUERTA VIZCAINO PABLO. Datos registrales. T 34508 , F 40, S 8, H M 74579, I/A 153 (18.12.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: VILLAFAFILA GARCIA ADA;DURAN LABIANO CAROL;MUÑOZ FERNANDEZ EZEQUIEL. Apo.Manc.:VILLAFAFILA GARCIA ADA;DURAN LABIANO CAROL;MUÑOZ FERNANDEZ EZEQUIEL. Datos registrales. T 34508 , F 40, S 8, HM 74579, I/A 154 (18.12.18).
03 de Agosto de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARQUES CORBELLA MIREIA. Datos registrales. T 34508 , F 38, S 8, H M 74579, I/A 150(27.07.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: TORRES HOHR JUAN PEDRO. Datos registrales. T 34508 , F 39, S 8, H M 74579, I/A 151 (27.07.18).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GABANDE SAENZ JAIME. Apoderado: MUÑOZ LOPEZ BEGOÑA. Apo.Man.Soli: GABANDE SAENZJAIME. Datos registrales. T 34508 , F 39, S 8, H M 74579, I/A 152 (27.07.18).
28 de Marzo de 2018Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: ABF COLON PARK SL. Datos registrales. T 34508 , F 36, S 8, H M74579, I/A 147 (20.03.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: NOGUERAS MARTINEZ MARIA ANGELES;CAMARERO LORENZO CARLOS JAVIER. Datosregistrales. T 34508 , F 36, S 8, H M 74579, I/A 148 (20.03.18).
Revocaciones. Apoderado: TRONCOSO ECHEGOYEN FERNANDO;GUZMAN SANCHEZ BARRANCO JESUS MARIA.Apo.Man.Soli: GUZMAN SANCHEZ BARRANCOS JESUS. Apoderado: FABIANI ROMERO JOSE MARIA. Datos registrales. T34508 , F 38, S 8, H M 74579, I/A 149 (20.03.18).
16 de Enero de 2018Nombramientos. Apoderado: DE LA CALLE DELGADO DE ROBLES EDUARDO;LOPEZ GUTIERREZ BEATRIZ;PEREZ RUFIAN
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ FERNANDEZ CARLOS JAVIER;CIFRIAN YAGUE JUAN PABLO;BORRA PEDREROANTONIO Datos registrales. T 34508 , F 35, S 8, H M 74579, I/A 146 ( 9.01.18).
05 de Mayo de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: ARROYO LLORENTE BEATRIZ;MUÑIZ DOMINGUEZ RAFAEL VICENTE;FLOREZ BARO PEDRO.Datos registrales. T 34508 , F 34, S 8, H M 74579, I/A 143 (25.04.17).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: KOHL PEÑA RUTH. Datos registrales. T 34508 , F 34, S 8, H M 74579, I/A 144 (25.04.17).
07 de Marzo de 2017Revocaciones. Apoderado: TORRENTE LOPEZ TERESA. Datos registrales. T 34508 , F 34, S 8, H M 74579, I/A 142 (24.02.17).
26 de Octubre de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: DIEGO MELIVEO LAURA. Datos registrales. T 34508 , F 32, S 8, H M 74579, I/A 140 (19.10.16).
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA GONZALEZ ANA BELEN. Datos registrales. T 34508 , F 33, S 8, H M 74579, I/A 141(19.10.16).
01 de Septiembre de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ LARA SILVIA. Datos registrales. T 34508 , F 30, S 8, H M 74579, I/A 137 (24.08.16).
Revocaciones. Apo.Manc.: OCERANSKY LOSANA SILVIA. Datos registrales. T 34508 , F 31, S 8, H M 74579, I/A 138 (24.08.16).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANTOS LORENZO MARIA SALOME. Datos registrales. T 34508 , F 31, S 8, H M 74579, I/A 139(24.08.16).
25 de Abril de 2016Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 34508 , F 30, S 8, H M 74579, I/A 136 (15.04.16).
22 de Abril de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: DELGADO AZQUETA MANUEL. Datos registrales. T 31618 , F 118, S 8, H M 74579, I/A 134(14.04.16).
Revocaciones. Apoderado: HEREDERO DE VEGA FRANCISCO JAVIER;PELAEZ LOSA ANDRES;HERMOSO DE MENDOZA JOSELUIS;JAURENA BAUDINO ALBERTO. Apo.Man.Soli: RASO GARCIA JUAN MANUEL;VELASCO DOÑORO JOSE LUIS. Apoderado:BLUNDEN PAUL;GARCIA-GUTIERREZ GOMEZ LUIS. Apo.Man.Soli: CHAUSA FERNANDEZ MANUEL. Apoderado: NIETONOGUERAS MANUEL. Apo.Man.Soli: ARIAS SANCHEZ JULIO. Datos registrales. T 34508 , F 30, S 8, H M 74579, I/A 135(15.04.16).
21 de Enero de 2016Revocaciones. Apoderado: SAINZ SEPTIEN OSCAR;CASTELLS CARNER MARCELO. Datos registrales. T 31618 , F 118, S 8, HM 74579, I/A 133 (13.01.16).
04 de Noviembre de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA ZAMARREÑO ANA. Datos registrales. T 31618 , F 115, S 8, H M 74579, I/A 129(27.10.15).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: FUENTES GUIOTE ANGELA. Datos registrales. T 31618 , F 116, S 8, H M 74579, I/A 130(27.10.15).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SERRANO MOLINA ELISEO. Datos registrales. T 31618 , F 117, S 8, H M 74579, I/A 132(27.10.15).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ DIEZ ANGELA. Datos registrales. T 31618 , F 117, S 8, H M 74579, I/A 131 (27.10.15).
27 de Octubre de 2015Modificaciones estatutarias. Nueva redaccion de la totalidad de los estatutos sociales . Datos registrales. T 31618 , F 113, S 8, HM 74579, I/A 128 (19.10.15).
08 de Julio de 2015Revocaciones. Apoderado: GOMEZ ABAD ANTONIO;GOMEZ MIGALLON CARLOS. Apo.Manc.: GRACIA UBEDA MANUEL. Datosregistrales. T 31618 , F 113, S 8, H M 74579, I/A 126 (30.06.15).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ ABAD ANTONIO. Datos registrales. T 31618 , F 113, S 8, H M 74579, I/A 127 (30.06.15).
07 de Mayo de 2015Revocaciones. Apoderado: ZAVALA GARCIA LOIGORRI MARTIN;CIRIZA LALAGUNA DOMINGO. Datos registrales. T 31618 , F112, S 8, H M 74579, I/A 124 (27.04.15).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: KOHL PEÑA RUTH. Datos registrales. T 31618 , F 112, S 8, H M 74579, I/A 125 (27.04.15).
07 de Abril de 2015Revocaciones. Apoderado: SAGRISTA CARNER JAIME;BERNAL ACERO JOSE;PINACHO VALERO JESUS;PALOMAR GARCIAMANUEL;DE VEGA CUBERO MARIA DEL CARMEN;BERNAL ACERO JOSE;CAMPDERA GUTIERREZ ENRIQUE. Datosregistrales. T 31618 , F 112, S 8, H M 74579, I/A 123 (26.03.15).
19 de Diciembre de 2014Nombramientos. Apoderado: FABIANI ROMERO JOSE MARIA;DASTIS LUIS JOSE LUIS;QUESADA GONZALEZ LAURA;DEMIGUEL VILLAR ANA ISABEL;SANCHEZ RIOL JOSE PABLO. Datos registrales. T 31618 , F 110, S 8, H M 74579, I/A 121(10.12.14).
Nombramientos. Apoderado: QUESADA PEDRAJAS RAFAEL. Datos registrales. T 31618 , F 111, S 8, H M 74579, I/A 122(10.12.14).
29 de Septiembre de 2014Nombramientos. Apo.Manc.: OCERANSKY LOSANA SILVIA;PUERTA VIZCAINO PABLO. Datos registrales. T 31618 , F 109, S 8,H M 74579, I/A 120 (19.09.14).
12 de Junio de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: CAMAZON CARVAJAL JOSE ANTONIO;ARIAS SANCHEZ JULIO. Datos registrales. T 31618 , F108, S 8, H M 74579, I/A 119 (29.05.14).
05 de Junio de 2014Revocaciones. Apoderado: GIL COMIN MARIANO JOSE;SOLANAS JIMENO CARLOS;SALAS REVUELTA JOSE VICENTE. Datosregistrales. T 31618 , F 108, S 8, H M 74579, I/A 117 (29.05.14).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANROMAN MONTERO MIGUEL;GUZMAN SANCHEZ BARRANCOS JESUS. Datos registrales. T31618 , F 108, S 8, H M 74579, I/A 118 (29.05.14).
03 de Abril de 2014Revocaciones. Apoderado: REGODON MENA DIEGO. Apo.Man.Soli: LOZANO GARCIA ANGEL. Datos registrales. T 31618 , F107, S 8, H M 74579, I/A 115 (26.03.14).
Revocaciones. Apoderado: GESTOSO GONZALEZ DOMINGO. Datos registrales. T 31618 , F 108, S 8, H M 74579, I/A 116(26.03.14).
02 de Abril de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: GESTOSO GONZALEZ DOMINGO. Datos registrales. T 31618 , F 105, S 8, H M 74579, I/A 111(26.03.14).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LAMORENA MATA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 31618 , F 106, S 8, H M 74579, I/A 112(26.03.14).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: RAMOS ESTEBAN CONRADO. Datos registrales. T 31618 , F 106, S 8, H M 74579, I/A 113(26.03.14).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: TEJERO ARRANZ JORGE. Datos registrales. T 31618 , F 107, S 8, H M 74579, I/A 114 (26.03.14).
31 de Enero de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: AGUILOCHO CEBALLOS FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 27465 , F 65, S 8, H M 74579,I/A 108 (23.01.14).
Nombramientos. Apo.Manc.: SALVO GARCIA LUIS. Datos registrales. T 27465 , F 66, S 8, H M 74579, I/A 109 (23.01.14).
Ceses/Dimisiones. Consejero: BARREIRO SEOANE JOSE;RUIZ GALVEZ PRIEGO EUGENIO. Datos registrales. T 31618 , F 105,S 8, H M 74579, I/A 110 (23.01.14).
08 de Mayo de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE LA CALLE GARCIA RAUL;FALAGAN MAYO FLORENCIO. Datos registrales. T 27465 , F 65, S8, H M 74579, I/A 107 (24.04.13).
01 de Abril de 2013Revocaciones. Apoderado: ZARANDIETA ROMERO JOSE MARIA. Datos registrales. T 27465 , F 64, S 8, H M 74579, I/A 106(14.03.13).
22 de Noviembre de 2012Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 27465 , F 64, S 8, H M 74579, I/A 105 (12.11.12).
08 de Noviembre de 2012Nombramientos. Apoderado: SALVO GARCIA LUIS;MARTIN DOMINGUEZ FERNANDO. Datos registrales. T 27465 , F 63, S 8, HM 74579, I/A 103 (26.10.12).
Nombramientos. Apoderado: CEPERO MOLI DANIEL. Datos registrales. T 27465 , F 64, S 8, H M 74579, I/A 104 (26.10.12).
25 de Septiembre de 2012Nombramientos. Apoderado: MUÑOZ LOPEZ BEGOÑA. Datos registrales. T 27465 , F 61, S 8, H M 74579, I/A 101 (14.09.12).
Nombramientos. Apoderado: NIETO NOGUERAS MANUEL. Datos registrales. T 27465 , F 62, S 8, H M 74579, I/A 102 (14.09.12).
18 de Mayo de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: CARTER KARL LEWIS. Nombramientos. Consejero: HACKETT BENJAMIN DENNIS. Datosregistrales. T 27465 , F 60, S 8, H M 74579, I/A 99 ( 7.05.12).
Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS LOS ARTICULOS 15º Y 16º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T27465 , F 61, S 8, H M 74579, I/A 100 ( 7.05.12).
16 de Marzo de 2012Revocaciones. Apoderado: RUIZ RUIZ ANGEL;JIMENEZ LATORRE JOSE. Datos registrales. T 27465 , F 60, S 8, H M 74579, I/A98 ( 7.03.12).