Buscador CIF Logo

Actos BORME Abante Business Process Outsourcing Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Abante Business Process Outsourcing Sl

Actos BORME Abante Business Process Outsourcing Sl - B35539063

Tenemos registrados 32 Actos BORME del Registro Mercantil de Lugo para Abante Business Process Outsourcing Sl con CIF B35539063

馃敊 Perfil de Abante Business Process Outsourcing Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Lugo

Actos BORME de Abante Business Process Outsourcing Sl

26 de Julio de 2022
Ceses/Dimisiones. Apo.Sol.: GONZALEZ DORADO MONICA. Datos registrales. T 516 , F 142, S 8, H LU 9068, I/A 52 (13.07.22).

Revocaciones. Apo.Sol.: DIEZ GUERRA SUSANA;DIEZ GUERRA SUSANA. Datos registrales. T 516 , F 142, S 8, H LU 9068, I/A53 (13.07.22).

Ceses/Dimisiones. Apo.Sol.: FERNANDEZ MORENO CAROLINA. Datos registrales. T 516 , F 143, S 8, H LU 9068, I/A 54(13.07.22).

03 de Mayo de 2022
Revocaciones. Apoderado: GONZAGA LUCA DE TENA ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS. Datos registrales. T 516 , F 140, S8, H LU 9068, I/A 51 (22.04.22).

27 de Julio de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ DORADO MONICA;DIEZ GUERRA SUSANA. Datos registrales. T 516 , F 142, S 8, H LU9068, I/A 50 (16.07.21).

05 de Abril de 2021
Revocaciones. Apo.Manc.: DE MIGUEL BUENO VICTOR;VAZQUEZ MARTINEZ MERCEDES;ARCEU GARCIA EUGENIO.Apoderado: VAZQUEZ MARTINEZ MERCEDES. Apo.Sol.: DE MIGUEL BUENO VICTOR;VAZQUEZ MARTINEZ MERCEDES.Apo.Manc.: DE MIGUEL BUENO VICTOR;VAZQUEZ MARTINEZ MERCEDES;SANCHEZ RODRIGUEZ ANA;AMARELO OTEROJUAN JOSE;RIVAS CASTA脩AL MEIRA LAURA;FERNANDEZ-ABRIL ICOCHEA CARLOS. Apoderado: OREJON GUILLLEN ISABEL.Apo.Manc.: ARCEU GARCIA EUGENIO;DE MIGUEL BUENO VICTOR;VAZQUEZ MARTINEZ MERCEDES;FERNANDEZ-ABRILICOCHEA CARLOS;OREJON GUILLLEN ISABEL;GONZALEZ DORADO MONICA. Apo.Sol.: ARCEU GARCIA EUGENIO;DE MIGUELBUENO VICTOR;VAZQUEZ MARTINEZ MERCEDES;DIEZ GUERRA SUSANA. Apoderado: FERNANDEZ-ABRIL ICOCHEACARLOS. Apo.Manc.: FERNANDEZ-ABRIL ICOCHEA CARLOS;OREJON GUILLLEN ISABEL;MU脩OZ CABA脩ERO JULIOCESAR;VAZQUEZ MARTINEZ MERCEDES. Datos registrales. T 516 , F 141, S 8, H LU 9068, I/A 49 (18.03.21).

08 de Septiembre de 2020
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: DELOITTE SL;PRICEWATERHAUSECOOPERS AUDITORES SL;KPMGAUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: SICET SERVICIOS INTEGRALES SL. Datos registrales. T 516 , F 141, S 8, H LU9068, I/A 48 (27.08.20).

13 de Febrero de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ARCEU GARCIA EUGENIO. Datos registrales. T 516 , F 140, S 8, H LU 9068, I/A 45 (25.01.19).

Nombramientos. Apoderado: GONZAGA LUCA DE TENA ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS. Datos registrales. T 516 , F 140,S 8, H LU 9068, I/A 46 (30.01.19).

22 de Noviembre de 2018
Nombramientos. Apo.Manc.: FERNANDEZ-ABRIL ICOCHEA CARLOS;OREJON GUILLLEN ISABEL;MU脩OZ CABA脩ERO JULIOCESAR;VAZQUEZ MARTINEZ MERCEDES. Datos registrales. T 454 , F 117, S 8, H LU 9068, I/A 43 (12.11.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: DIEZ GUERRA SUSANA;FERNANDEZ MORENO CAROLINA. Datos registrales. T 454 , F 117, S 8, HLU 9068, I/A 44 (12.11.18).

04 de Enero de 2018
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ-ABRIL ICOCHEA CARLOS. Datos registrales. T 454 , F 116, S 8, H LU 9068, I/A 41(20.12.17).

11 de Mayo de 2017
Revocaciones. Apoderado: FAGINAS SOUTO ALEJANDRO. Apo.Sol.: FRAGA FRAGA ANA MARIA. Apo.Manc.: FRAGA FRAGAANA MARIA;FAGINAS SOUTO ALEJANDRO;FRAGA FRAGA ANA MARIA. Apo.Sol.: FRAGA FRAGA ANA MARIA. Datosregistrales. T 454 , F 116, S 8, H LU 9068, I/A 40 ( 2.05.17).

20 de Enero de 2017
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 454 , F 116, S 8, H LU 9068, I/A 39 (11.01.17).

26 de Octubre de 2016
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHAUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 454 , F 115, S 8, H LU 9068, I/A 38(18.10.16).

06 de Agosto de 2015
Nombramientos. Apo.Manc.: FRAGA FRAGA ANA MARIA;ARCEU GARCIA EUGENIO;DE MIGUEL BUENO VICTOR;VAZQUEZMARTINEZ MERCEDES;FERNANDEZ-ABRIL ICOCHEA CARLOS;OREJON GUILLEN ISABEL;GONZALEZ DORADO MONICA.Datos registrales. T 454 , F 115, S 8, H LU 9068, I/A 36 (28.07.15).

Nombramientos. Apo.Sol.: FRAGA FRAGA ANA MARIA;ARCEU GARCIA EUGENIO;DE MIGUEL BUENO VICTOR;VAZQUEZMARTINEZ MERCEDES;GONZALEZ DORADO MONICA;DIEZ GUERRA SUSANA. Datos registrales. T 454 , F 115, S 8, H LU9068, I/A 37 (28.07.15).

06 de Julio de 2015
Nombramientos. Apoderado: OREJON GUILLLEN ISABEL. Datos registrales. T 454 , F 114, S 8, H LU 9068, I/A 35 (26.06.15).

23 de Julio de 2014
Cambio de domicilio social. AVDA INFANTA ELENA 300 (LUGO). Datos registrales. T 454 , F 114, S 8, H LU 9068, I/A 34(15.07.14).

24 de Marzo de 2014
Revocaciones. Apo.Sol.: DE AZCARRAGA VARELA VICTORIANO. Apo.Manc.: DE AZCARRAGA VARELA VICTORIANO;RIOSCERNADAS ESTELA. Datos registrales. T 454 , F 114, S 8, H LU 9068, I/A 33 (14.03.14).

25 de Septiembre de 2013
Ceses/Dimisiones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor:PRICEWATERHAUSECOOPERS AUDITORES SL. Fe de erratas: Rectificaci贸n de la inscripci贸n 28潞, en el sentido de que se nombraauditor para los ejercicios 2012 a 2014. Datos registrales. T 454 , F 114, S 8, H LU 9068, I/A 32 (13.09.13).

17 de Julio de 2013
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.022.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 438.000,00 Euros. Escisi贸n parcial.Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: ABANTE CLUSTER HOLDING SL. Datos registrales. T 441 , F 162, S 8, H LU 9068, I/A 31 (8.07.13).

10 de Enero de 2013
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 441 , F 162, S 8, H LU 9068, I/A30 (29.12.12).

26 de Julio de 2012
Revocaciones. Apoderado: VAZQUEZ MARTINEZ MERCEDES. Datos registrales. T 441 , F 162, S 8, H LU 9068, I/A 29(13.07.12).

12 de Julio de 2012
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 441 , F 159, S 8, H LU9068, I/A 27 ( 2.07.12).

P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 441 , F 162, S 8, H LU 9068, I/A 28 ( 3.07.12).

27 de Junio de 2012
Nombramientos. Apo.Sol.: FRAGA FRAGA ANA MARIA;DE MIGUEL BUENO VICTOR;DE AZCARRAGA VARELAVICTORIANO;VAZQUEZ MARTINEZ MERCEDES. Datos registrales. T 441 , F 158, S 8, H LU 9068, I/A 23 (12.06.12).

Nombramientos. Apo.Manc.: FRAGA FRAGA ANA MARIA;FAGINAS SOUTO ALEJANDRO;DE MIGUEL BUENO VICTOR;VAZQUEZMARTINEZ MERCEDES;SANCHEZ RODRIGUEZ ANA;DE AZCARRAGA VARELA VICTORIANO;AMARELO OTERO JUANJOSE;RIVAS CASTA脩AL MEIRA LAURA;RIOS CERNADAS ESTELA;FERNANDEZ-ABRIL ICOCHEA CARLOS. Datos registrales. T441 , F 158, S 8, H LU 9068, I/A 24 (12.06.12).

Nombramientos. Apoderado: FAGINAS SOUTO ALEJANDRO. Datos registrales. T 441 , F 158, S 8, H LU 9068, I/A 25 (12.06.12).

Nombramientos. Apoderado: VAZQUEZ MARTINEZ MERCEDES. Datos registrales. T 441 , F 159, S 8, H LU 9068, I/A 26(12.06.12).

31 de Mayo de 2012
Revocaciones. Apoderado: RAFAEL MU脩OZ GARCIA. Apo.Man.Soli: DE MIGUEL BUENO VICTOR;ARCEU GARCIAEUGENIO;RIVAS ANORO JUAN LUIS. Apo.Manc.: FERNANDEZ-FERNANDEZ LOPEZ MARTA;ICHASO CRUCES NURIA;PENARODRIGUEZ JOSE MARIA;ARCEU GARCIA EUGENIO;RIVAS ANORO JUAN LUIS. Apo.Man.Soli: ARCEU GARCIAEUGENIO;RAMIREZ BARRAGAN ANTONIO;PEREZ GARCIA RAFAEL;VAZQUEZ MARTINEZ MERCEDES. Datos registrales. T394 , F 107, S 8, H LU 9068, I/A 21 (22.05.12).

Nombramientos. Apo.Manc.: DE MIGUEL BUENO VICTOR;VAZQUEZ MARTINEZ MERCEDES;ARCEU GARCIA EUGENIO. Datosregistrales. T 394 , F 107, S 8, H LU 9068, I/A 22 (22.05.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n