Buscador CIF Logo

Actos BORME Abentel Telecomunicaciones Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Abentel Telecomunicaciones Sa

Actos BORME Abentel Telecomunicaciones Sa - A41980178

Tenemos registrados 36 Actos BORME del Registro Mercantil de Sevilla para Abentel Telecomunicaciones Sa con CIF A41980178

🔙 Perfil de Abentel Telecomunicaciones Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Sevilla

Actos BORME de Abentel Telecomunicaciones Sa

13 de Octubre de 2022
Otros conceptos: Declarada en situación de insolvencia por cuantía de 6380,37 euros de principal, más 955 euros presupuestadosprovisionalmente para intereses y costas, sin perjuicio de su liquidación y tasación definitivas, insolvencia que se entenderá a todos losefectos como provisional hasta que se conozcan bienes a la ejecutada o se realicen los embargos. Datos registrales. T 6206 , F 57,S 8, H SE 36548,SE , I/ 112 .1.) 4 10 22.

20 de Julio de 2021
Otros conceptos: DESIGNADO DON JUAN PABLO LOPEZ BRAVO VELASCO, con D.N.I. número 50.694.706-S, comorepresentante persona física de "ABENER ENERGIA, S.A.", para el ejercicio del cargo de ésta última como administradora única de"ABENTEL TELECOMUNICACIONES SA".- Datos registrales. T 6206 , F 57, S 8, H SE 36548,SE , I/ 112 .(12.07.21).

19 de Julio de 2021
Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2019 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 6206 , F 57, S 8, H SE 36548,SE , I/ 111 .( 7.07.21).

06 de Septiembre de 2019
Revocaciones. Apo.Manc.: GIRALDEZ ORTIZ JOSE FERNANDO;GIRALDEZ ORTIZ JOSE FERNANDO;FERNANDEZ ROMEROANDRES. Apo.Sol.: GIRALDEZ ORTIZ JOSE FERNANDO;GIRALDEZ ORTIZ JOSE FERNANDO;FERNANDEZ ROMERO ANDRES.Apo.Manc.: FERNANDEZ ROMERO ANDRES. Nombramientos. Apo.Sol.: SANTOS GARCIA JOSE LUIS;POLO GUERREROALVARO;BARRASA RUIZ PABLO. Apo.Man.Soli: PASTOR FERNANDEZ VICTOR MANUEL;FERNANDEZ FUENTES DAVID;RUIZGARCIA CRISTINA. Datos registrales. T 6206 , F 55, S 8, H SE 36548,SE , I/ 109 .(28.08.19).

Declaración de unipersonalidad. Socio único: ABENER ENERGIA SA. Datos registrales. T 6206 , F 57, S 8, H SE 36548,SE , I/110 .(29.08.19).

31 de Agosto de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ABEINSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL SA. Nombramientos. Adm. Unico:ABENER ENERGIA SA. Datos registrales. T 6206 , F 55, S 8, H SE 36548,SE , I/ 108 .(21.08.18).

15 de Enero de 2018
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 6206 , F 54, S 8, H SE 36548,SE , I/ 107 .( 5.01.18).

29 de Mayo de 2017
Revocaciones. Apoderado: TORRES MORAL MANUEL;BOLAÑOS MORA FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: GONZALEZDOMINGUEZ ALFONSO;GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;ALCANTARA FERNANDEZ JOSE RAMON. Apoderado: ALCANTARAFERNANDEZ JOSE RAMON. Apo.Sol.: BENJUMEA ALARCON ALFONSO;ALCANTARA FERNANDEZ JOSE RAMON. Apo.Man.Soli:GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;BENJUMEA ALARCON ALFONSO. Apo.Manc.: GONZALEZ DOMINGUEZALFONSO;BENJUMEA ALARCON ALFONSO;ALCANTARA FERNANDEZ JOSE RAMON;GIRALDEZ GONZALEZ LUIS;TORRESMORAL MANUEL;BOLAÑOS MORA FRANCISCO JAVIER;GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;BENJUMEA ALARCONALFONSO;ALCANTARA FERNANDEZ JOSE RAMON;GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;BENJUMEA ALARCONALFONSO;ALCANTARA FERNANDEZ JOSE RAMON;GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;BENJUMEA ALARCONALFONSO;GIRALDEZ GONZALEZ LUIS;BOLAÑOS MORA FRANCISCO JAVIER;TORRES MORAL MANUEL. Apo.Sol.: GONZALEZDOMINGUEZ ALFONSO. Apo.Manc.: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Otros conceptos:REVOCADOS TODOS LOS PODERES CONFERIDOS A D. ALFONSO GONZALEZ DOMINGUEZ, D. ALFONSO BENJUMEAALARCON, D. JOSE RAMON ALCANTARA FERNANDEZ, D. LUIS GIRALDEZ GONZALEZ, D. MANUEL TORRES MORA y D.FRANCISCO JAVIER BOLAÑOS MORA, CON ANTERIORIDAD AL 27 DE MARZO DE 2017. Datos registrales. T 6206 , F 54, S 8, HSE 36548,SE , I/ 106 .(18.05.17).

03 de Marzo de 2017
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social y web corporativa.-. Cambio de domicilio social. C/ENERGIA SOLAR 1 - CAMPUS PALMAS ALTAS, C.P41014 (SEVILLA). Datos registrales. T 6206 , F 53, S 8, H SE 36548,SE , I/105 .(23.02.17).

21 de Febrero de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: GIRALDEZ ORTIZ JOSE FERNANDO;FERNANDEZ ROMERO ANDRES;GONZALEZ DOMINGUEZALFONSO;GIRALDEZ ORTIZ JOSE FERNANDO. Apo.Manc.: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;GIRALDEZ ORTIZ JOSEFERNANDO;FERNANDEZ ROMERO ANDRES;GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;GIRALDEZ ORTIZ JOSEFERNANDO;FERNANDEZ ROMERO ANDRES. Datos registrales. T 6206 , F 51, S 8, H SE 36548,SE , I/ 104 .( 7.02.17).

03 de Febrero de 2017
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 6206 , F 51, S 8, H SE 36548,SE , I/ 103 .(26.01.17).

22 de Junio de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;SALINAS IÑIGO PURIFICACION;BURGOS DE LA MAZA JOSELUIS;BENJUMEA ALARCON ALFONSO;POLO GUERRERO ALVARO. Presidente: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Secretario:SALINAS IÑIGO PURIFICACION. Nombramientos. Adm. Unico: ABEINSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL SA.Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS todos los artículos de los Estatutos como consecuencia de su adaptación a la Ley deSociedades de Capital.-. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.Datos registrales. T 3650 , F 42, S 8, H SE 36548,SE , I/ 102 .(14.06.16).

03 de Febrero de 2016
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3650 , F 41, S 8, H SE 36548,SE , I/ 101 .(26.01.16).

17 de Octubre de 2014
Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;BENJUMEA ALARCON ALFONSO;GIRALDEZ GONZALEZLUIS;BOLAÑOS MORA FRANCISCO JAVIER;TORRES MORAL MANUEL;HERNANDEZ FERNANDEZ DE PINELO JUANPEDRO;RAMIREZ SANCHEZ PEDRO. Datos registrales. T 3650 , F 41, S 8, H SE 36548,SE , I/ 100 .( 8.10.14).

21 de Julio de 2014
Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ CERRADA JOSE MIGUEL;TORRADO GARRON MANUEL. Datos registrales. T 3650 , F 40, S8, H SE 36548,SE , I/ 99 .(14.07.14).

28 de Marzo de 2014
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;BENJUMEA ALARCON ALFONSO;ALCANTARA FERNANDEZJOSE RAMON. Nombramientos. Apoderado: HIDALGO PEÑA MANUEL. Datos registrales. T 3650 , F 40, S 8, H SE 36548,SE , I/98 .(14.03.14).

14 de Febrero de 2014
Ceses/Dimisiones. Secretario: HOOGSTRAATE MAARTEN. Consejero: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;BURGOS DE LAMAZA JOSE LUIS;POLO GUERRERO ALVARO;CHIRALT SILES VICENTE;HOOGSTRAATE MAARTEN. Presidente: GONZALEZDOMINGUEZ ALFONSO. Revocaciones. Apo.Man.Soli: CHIRALT SILES VICENTE. Nombramientos. Consejero: GONZALEZDOMINGUEZ ALFONSO. Presidente: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Consejero: SALINAS IÑIGO PURIFICACION. Secretario:SALINAS IÑIGO PURIFICACION. Consejero: BURGOS DE LA MAZA JOSE LUIS;BENJUMEA ALARCON ALFONSO;POLOGUERRERO ALVARO. Datos registrales. T 3650 , F 39, S 8, H SE 36548,SE , I/ 97 .( 4.02.14).

05 de Febrero de 2014
Nombramientos. Apo.Sol.: BENJUMEA ALARCON ALFONSO;ALCANTARA FERNANDEZ JOSE RAMON. Apo.Man.Soli:GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;BENJUMEA ALARCON ALFONSO. Apo.Manc.: GONZALEZ DOMINGUEZALFONSO;BENJUMEA ALARCON ALFONSO;ALCANTARA FERNANDEZ JOSE RAMON;GIRALDEZ GONZALEZ LUIS;TORRESMORAL MANUEL;BOLAÑOS MORA FRANCISCO JAVIER;GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;BENJUMEA ALARCONALFONSO;ALCANTARA FERNANDEZ JOSE RAMON;GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;BENJUMEA ALARCONALFONSO;ALCANTARA FERNANDEZ JOSE RAMON. Datos registrales. T 3650 , F 36, S 8, H SE 36548,SE , I/ 96 .(22.01.14).

25 de Julio de 2013
Revocaciones. Apo.Sol.: OLIVEROS CALLE JOSE MANUEL. Datos registrales. T 3650 , F 36, S 8, H SE 36548,SE , I/ 95.(18.07.13).

Nombramientos. Apo.Sol.: BENITO HENRY JUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 3650 , F 35, S 8, H SE 36548,SE , I/ 94.(18.07.13).

01 de Julio de 2013
Ampliación de capital. Suscrito: 600.000,00 Euros. Desembolsado: 600.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 900.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 900.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: MODIFICACION DELARTICULO 5º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 3650 , F 34, S 8, H SE 36548,SE , I/ 93 .(18.06.13).

28 de Diciembre de 2012
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA GONZALEZ ENRIQUE;POZO OJEDA RAMON. Datos registrales. T 3650 , F 34, S 8, H SE36548,SE , I/ 91 .(18.12.12).

Revocaciones. Apoderado: MONTELL GARCIA JOSE LUIS;RUIZ QUESADA TOMAS;EDUARDO GONZALEZ PINELO. Datosregistrales. T 3650 , F 34, S 8, H SE 36548,SE , I/ 92 .(18.12.12).

13 de Agosto de 2012
Nombramientos. Apoderado: ALCANTARA FERNANDEZ JOSE RAMON. Datos registrales. T 3650 , F 33, S 8, H SE 36548,SE , I/90 .( 1.08.12).

19 de Julio de 2012
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3650 , F 33, S 8, H SE 36548,SE , I/ 89 .(10.07.12).

21 de Marzo de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ RAMOS PEDRO FRANCISCO. Datos registrales. T 3650 , F 33, S 8, H SE 36548,SE ,I/ 88 .( 7.03.12).

30 de Agosto de 2011
Revocaciones. Apo.Sol.: BALBOA LINARES SALVADOR;CORREA PORTILLO SANTIAGO. Nombramientos. Apo.Sol.: BALBOALINARES SALVADOR;CORREA PORTILLO SANTIAGO. Apo.Manc.: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;ALCANTARAFERNANDEZ JOSE RAMON. Datos registrales. T 3650 , F 31, S 8, H SE 36548,SE , I/ 84 .(12.08.11).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: MUÑOZ FERNANDEZ MARTIN. Datos registrales. T 3650 , F 31, S 8, H SE 36548,SE , I/ 85.(12.08.11).

Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Presidente: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Consejero:BURGOS DE LA MAZA JOSE LUIS;RODRIGUEZ RAMOS PEDRO FRANCISCO. SecreNoConsj: HOOGSTRAATE MAARTEN.Nombramientos. Consejero: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;BURGOS DE LA MAZA JOSE LUIS;RODRIGUEZ RAMOSPEDRO FRANCISCO;POLO GUERRERO ALVARO;CHIRALT SILES VICENTE;HOOGSTRAATE MAARTEN. Presidente: GONZALEZDOMINGUEZ ALFONSO. Secretario: HOOGSTRAATE MAARTEN. Datos registrales. T 3650 , F 32, S 8, H SE 36548,SE , I/ 87.(12.08.11).

Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3650 , F 32, S 8, H SE 36548,SE, I/ 86 .(12.08.11).

28 de Junio de 2011
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALCANTARA FERNANDEZ JOSE RAMON. Datos registrales. T 3650 , F 29, S 8, H SE 36548,SE ,I/ 83 .(10.06.11).

26 de Enero de 2011
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3650 , F 29, S 8, H SE 36548,SE ,I/ 82 .(13.01.11).

03 de Septiembre de 2010
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ZULUAGA ZILBERMANN ARMANDO. Nombramientos. SecreNoConsj: HOOGSTRAATEMAARTEN. Datos registrales. T 3650 , F 29, S 8, H SE 36548,SE , I/ 81 .(24.08.10).

11 de Enero de 2010
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3650 , F 28, S 8, H SE 36548,SE ,I/ 80 .(23.12.09).

29 de Junio de 2009
Revocaciones. Apoderado: CALLE PAREJA FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Apoderado: MELADO RAMOS FRANCISCO.Datos registrales. T 3650 , F 28, S 8, H SE 36548,SE , I/ 79 .(15.06.09).

15 de Junio de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO;JOSE LUIS BURGOS DE LA MAZA;RODRIGUEZ RAMOSPEDRO FRANCISCO. Presidente: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ DOMINGUEZALFONSO. Presidente: GONZALEZ DOMINGUEZ ALFONSO. Consejero: BURGOS DE LA MAZA JOSE LUIS;RODRIGUEZ RAMOSPEDRO FRANCISCO. Reelecciones. SecreNoConsj: ZULUAGA ZILBERMANN ARMANDO. Datos registrales. T 3650 , F 27, S 8,H SE 36548,SE , I/ 78 .( 1.06.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información