Buscador CIF Logo

Actos BORME Abonos Organicos Sevilla Sociedad Anonima

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Abonos Organicos Sevilla Sociedad Anonima

Actos BORME Abonos Organicos Sevilla Sociedad Anonima - A28146447

Tenemos registrados 29 Actos BORME del Registro Mercantil de Sevilla para Abonos Organicos Sevilla Sociedad Anonima con CIF A28146447

馃敊 Perfil de Abonos Organicos Sevilla Sociedad Anonima
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Sevilla

Actos BORME de Abonos Organicos Sevilla Sociedad Anonima

24 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Auditor: AUDIPUBLIC SL. Datos registrales. T 5088 , F 95, S 8, H SE 47737, I/A 39 (14.12.21).

06 de Septiembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: SABEINO COZAR JOSE RAMON. Secretario: SABEINO COZAR JOSE RAMON. Revocaciones.Apo.Man.Soli: VAZQUEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER;SABEINO COZAR JOSE RAMON;MARTINEZ DE LA ORDEN AGUSTIN.Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ DIAZ JUAN ANTONIO. Secretario: RODRIGUEZ DIAZ JUAN ANTONIO. Reelecciones.Consejero: CARABALLO BELLO JOSE;DE LAS NAVAS SANTAMARIA MIGUEL ANGEL;SOTO FERNANDEZ FRANCISCOMIGUEL;HUARTE AIZPUN FELIX. Presidente: HUARTE GIMENEZ JUAN FELIX. Consejero: HUARTE GIMENEZ JUAN FELIX.Con.Delegado: CARABALLO BELLO JOSE. Vicepresid.: CARABALLO BELLO JOSE. Datos registrales. T 3435 , F 225, S 8, H SE47737, I/A 38 (27.08.21).

29 de Abril de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: VAZQUEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER;RODRIGUEZ DIAZ JUAN ANTONIO. Datos registrales.T 3435 , F 223, S 8, H SE 47737, I/A 36 (14.04.21).

22 de Abril de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ DE LA ORDEN AGUSTIN. Apo.Manc.: VAZQUEZ GOMEZ FRANCISCOJAVIER;RODRIGUEZ DIAZ JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 3435 , F 224, S 8, H SE 47737, I/A 37 (16.04.21).

30 de Diciembre de 2020
Reelecciones. Auditor: MORENO CAMPILLO ANTONIO. Aud.Supl.: CINTADO MOLINA RAFAEL. Datos registrales. T 3435 , F 223,S 8, H SE 47737, I/A 35 (21.12.20).

11 de Diciembre de 2019
Reelecciones. Auditor: MORENO CAMPILLO ANTONIO. Aud.Supl.: CINTADO MOLINA RAFAEL. Datos registrales. T 3435 , F 223,S 8, H SE 47737, I/A 34 (27.11.19).

14 de Octubre de 2019
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ DE LA ORDEN AGUSTIN. Datos registrales. T 3435 , F 222, S 8, H SE 47737, I/A 33 (7.10.19).

02 de Enero de 2019
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: Art铆culo 2 - Objeto social. . Cambio de objeto social. "Art铆culo 2 - Objetosocial. 2.1.- Constituye el objeto de la Sociedad las siguientes actividades: A).- La recogida, transporte, manipulaci贸n, tratamiento,valorizaci贸n y eliminaci贸n de residuos s贸lidos urbanos, residuos industriales, residuos inertes, residuos sanitarios, de lodos, aguasindustrial. Datos registrales. T 3435 , F 222, S 8, H SE 47737, I/A 32 (20.12.18).

04 de Diciembre de 2018
Reelecciones. Auditor: MORENO CAMPILLO ANTONIO. Aud.Supl.: CINTADO MOLINA RAFAEL. Datos registrales. T 3435 , F 221,S 8, H SE 47737, I/A 31 (23.11.18).

01 de Diciembre de 2017
Reelecciones. Auditor: MORENO CAMPILLO ANTONIO. Aud.Supl.: CINTADO MOLINA RAFAEL. Datos registrales. T 3435 , F 221,S 8, H SE 47737, I/A 30 (22.11.17).

02 de Noviembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: SOTO FERNANDEZ FRANCISCO MIGUEL. Datos registrales. T 3435 , F 220, S 8, H SE 47737, I/A28 ( 5.09.17).

26 de Septiembre de 2017
Fe de erratas: Inscripci贸n 28陋 fue designado VICEPRESIDENTE , don JOSE CARABALLO BELL. Datos registrales. T 3435 , F 220,S 8, H SE 47737, I/A 28 ( 5.09.17).

Nombramientos. Vicepresid.: CARABALLO BELLO JOSE. Datos registrales. T 3435 , F 220, S 8, H SE 47737, I/A 28 ( 5.09.17).

Fe de erratas: RECTIFICACION inscripci贸n 28陋, en el sentido de que el VICEPRESIDENTE designado fue DON JOSE CARABALLOBELLO. Datos registrales. T 3435 , F 221, S 8, H SE 47737, I/A 29 (19.09.17).

13 de Septiembre de 2017
Nombramientos. Con.Delegado: CARABALLO BELLO JOSE. Reelecciones. Consejero: CARABALLO BELLO JOSE;DE LAS

02 de Diciembre de 2016
Reelecciones. Auditor: MORENO CAMPILLO ANTONIO. Aud.Supl.: CINTADO MOLINA RAFAEL. Datos registrales. T 3435 , F 219,S 8, H SE 47737, I/A 27 (24.11.16).

11 de Diciembre de 2015
Nombramientos. Auditor: MORENO CAMPILLO ANTONIO. Aud.Supl.: CINTADO MOLINA RAFAEL. Datos registrales. T 3435 , F219, S 8, H SE 47737, I/A 26 ( 1.12.15).

01 de Diciembre de 2014
Nombramientos. Auditor: MORENO CAMPILLO ANTONIO. Aud.Supl.: CINTADO MOLINA RAFAEL. Modificaciones estatutarias.23. Administraci贸n y Representacion: "Retribuci贸n".- . Datos registrales. T 3435 , F 219, S 8, H SE 47737, I/A 25 (18.11.14).

21 de Noviembre de 2013
Ceses/Dimisiones. Aud.Supl.: GOMEZ TINOCO JOSE RAMON. Nombramientos. Aud.Supl.: CINTADO MOLINA RAFAEL.Reelecciones. Auditor: MORENO CAMPILLO ANTONIO. Datos registrales. T 3435 , F 147, S 8, H SE 47737, I/A 24 (12.11.13).

19 de Febrero de 2013
Nombramientos. Consejero: CARABALLO BELLO JOSE. Reelecciones. Consejero: DE LAS NAVAS SANTAMARIA MIGUELANGEL;SOTO FERNANDEZ FRANCISCO MIGUEL;SABEINO COZAR JOSE RAMON;HUARTE AIZPUN FELIX. Presidente: HUARTEGIMENEZ JUAN FELIX. Consejero: HUARTE GIMENEZ JUAN FELIX. Vicepresid.: SOTO FERNANDEZ FRANCISCO MIGUEL.Secretario: SABEINO COZAR JOSE RAMON. Datos registrales. T 3435 , F 146, S 8, H SE 47737, I/A 22 ( 7.02.13).

Nombramientos. Apo.Sol.: CARABALLO BELLO JOSE. Datos registrales. T 3435 , F 147, S 8, H SE 47737, I/A 23 ( 7.02.13).

06 de Abril de 2011
Ceses/Dimisiones. Auditor: CRUZ RODRIGUEZ JOSE MARIA. Aud.Supl.: MORENO CAMPILLO ANTONIO. Nombramientos.Auditor: MORENO CAMPILLO ANTONIO. Aud.Supl.: GOMEZ TINOCO JOSE RAMON. Datos registrales. T 3435 , F 146, S 8, H SE47737, I/A 21 (22.03.11).

20 de Septiembre de 2010
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: CARABALLO MOLINA JOSE FRANCISCO. Consejero: CARABALLO MOLINA JOSE FRANCISCO.SecreNoConsj: SABEINO COZAR JOSE RAMON. Nombramientos. Consejero: DE LAS NAVAS SANTAMARIA MIGUELANGEL;SOTO FERNANDEZ FRANCISCO MIGUEL;SABEINO COZAR JOSE RAMON. Vicepresid.: SOTO FERNANDEZ FRANCISCOMIGUEL. Secretario: SABEINO COZAR JOSE RAMON. Reelecciones. Consejero: HUARTE AIZPUN FELIX. Presidente: HUARTEGIMENEZ JUAN FELIX. Consejero: HUARTE GIMENEZ JUAN FELIX. Datos registrales. T 3435 , F 145, S 8, H SE 47737, I/A 20 (6.09.10).

02 de Marzo de 2010
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: CARABALLO MOLINA JOSE FRANCISCO. Datos registrales. T 3435 , F 144, S 8, H SE 47737,I/A 19 (17.02.10).

22 de Febrero de 2010
Nombramientos. Apo.Manc.: HUARTE GIMENEZ JUAN FELIX;SOTO FERNANDEZ FRANCISCO MIGUEL. Datos registrales. T3435 , F 143, S 8, H SE 47737, I/A 17 ( 9.02.10).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ DE LA ORDEN AGUSTIN. Apo.Manc.: VAZQUEZ GOMEZ FRANCISCOJAVIER;SABEINO COZAR JOSE RAMON. Datos registrales. T 3435 , F 144, S 8, H SE 47737, I/A 18 ( 9.02.10).

09 de Septiembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: GUINEA ELORZA ANTONIO. Datos registrales. T 3435 , F 143, S 8, H SE 47737, I/A 16 (25.08.09).

18 de Febrero de 2009
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: GUINEA ELORZA ANTONIO. Datos registrales. T 3435 , F 142, S 8, H SE 47737, I/A 14 (6.02.09).

Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ DE LA ORDEN AGUSTIN. Datos registrales. T 3435 , F 142, S 8, H SE 47737, I/A 15 (6.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n