Actos BORME de Ac Hotel Cuenca 22 Sl
29 de Agosto de 2018Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 16432 , F 218, S 8, H M 279497, I/A 17 (22.08.18).
24 de Junio de 2016Revocaciones. Apoderado: SAMPER URBANO JUAN JOSE. Nombramientos. Apo.Sol.: CATALAN HEREDEROIGNACIO;MARTINEZ GUINEA LUIS MANUEL. Datos registrales. T 16432 , F 217, S 8, H M 279497, I/A 16 (15.06.16).
19 de Noviembre de 2014Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 117.195,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.005,00 Euros. Datos registrales. T 16432 , F217, S 8, H M 279497, I/A 15 (12.11.14).
02 de Noviembre de 2009Nombramientos. Apoderado: SAMPER URBANO JUAN JOSE. Datos registrales. T 16432 , F 216, S 8, H M 279497, I/A 14(21.10.09).
23 de Enero de 2009Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: AC HOTEL LA LINEA DE LA CONCEPCION SL. Representan: CATALAN DIAZANTONIO;SAMPER URBANO JUAN JOSE;VILLAR PEREZ JUANA MARIA. Presidente: LOPEZ MARTI JUAN MARIA. Vicepresid.: ACHOTELES SA. Consejero: AC DOS BARCELONA SL;TRISTAN IBARLUCEA CARLOS;BARTOLOME BENITO MARCOS;ACHOTELES SA;LOPEZ MARTI JUAN MARIA. Con.Delegado: AC DOS BARCELONA SL. Nombramientos. Adm. Unico: AC DOSBARCELONA SL. Representan: CATALAN DIAZ ANTONIO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n:Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 16432 , F 179, S 8, H M 279497, I/A 12 (13.01.09).
Revocaciones. Apoderado: TRISTAN IBARLUCEA CARLOS. Datos registrales. T 16432 , F 216, S 8, H M 279497, I/A 13(14.01.09).