Buscador CIF Logo

Actos BORME Ac Participacion En Infraestructuras Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Ac Participacion En Infraestructuras Sl

Actos BORME Ac Participacion En Infraestructuras Sl - B85111441

Tenemos registrados 11 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Ac Participacion En Infraestructuras Sl con CIF B85111441

馃敊 Perfil de Ac Participacion En Infraestructuras Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Ac Participacion En Infraestructuras Sl

19 de Octubre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO;LOPEZ PINTO FERNANDEZ DE NAVARRETEVICTORIANO;VELAZQUEZ GOMEZ DAVID;MIRETE FERRER PEDRO MANUEL. Presidente: MIRETE FERRER PEDRO MANUEL.SecreNoConsj: PENDAS AGUIRRE ANGEL FRANCISCO. VsecrNoConsj: TOUBES TORRES PALOMA GUADALUPE.Nombramientos. Liquidador: MELDON INVERSIONES 2008 SL. Representan: LOPEZ-PINTO FERNANDEZ DE NAVARRETEVICTORIANO. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 30681 , F 134, S 8, H M 439073, I/A 16 ( 7.10.15).

08 de Enero de 2015
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 30681 , F 134, S 8, H M 439073, I/A 14 (29.12.14).

Ceses/Dimisiones. Presidente: FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO. Nombramientos. Presidente: MIRETE FERRER PEDROMANUEL. Datos registrales. T 30681 , F 134, S 8, H M 439073, I/A 15 (30.12.14).

03 de Junio de 2013
Ceses/Dimisiones. Secretario: RIVILLA CALLE BLANCA. VsecrNoConsj: VILA ABELLAN GARCIA MARIA ISABEL.Nombramientos. SecreNoConsj: PENDAS AGUIRRE ANGEL FRANCISCO. VsecrNoConsj: TOUBES TORRES PALOMAGUADALUPE. Datos registrales. T 30681 , F 133, S 8, H M 439073, I/A 13 (27.05.13).

27 de Febrero de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: CLAVERIA GARCIA JUAN JOSE;SEGURADO GARCIA ALBERTO. Nombramientos. Consejero:VELAZQUEZ GOMEZ DAVID;MIRETE FERRER PEDRO MANUEL. Datos registrales. T 24412 , F 180, S 8, H M 439073, I/A 11(19.02.13).

Revocaciones. Apoderado: CLAVERIA GARCIA JUAN JOSE;CLAVERIA GARCIA JUAN JOSE;SEGURADO GARCIA ALBERTO.Nombramientos. Apo.Man.Soli: MIRETE FERRER PEDRO MANUEL;VELAZQUEZ GOMEZ DAVID. Datos registrales. T 24412 , F180, S 8, H M 439073, I/A 12 (19.02.13).

25 de Junio de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ DEL VILLAR BOCETA ENRIQUE. Nombramientos. Consejero: SEGURADO GARCIAALBERTO. Datos registrales. T 24412 , F 178, S 8, H M 439073, I/A 9 (14.06.12).

Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ DEL VILLAR BOCETA ENRIQUE. Nombramientos. Apoderado: SEGURADO GARCIAALBERTO. Datos registrales. T 24412 , F 179, S 8, H M 439073, I/A 10 (14.06.12).

02 de Julio de 2010
Nombramientos. VsecrNoConsj: VILA ABELLAN GARCIA MARIA ISABEL. Datos registrales. T 24412 , F 178, S 8, H M 439073, I/A8 (22.06.10).

01 de Julio de 2010
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 7 EL NOMBRAMIENTO COMO PRESIDENTE DE DON ENRIQUESANCHEZ DEL VILLAR BOCETA SIENDO LO CORRECTO DON ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ Datos registrales. T 24412 , F176, S 8, H M 439073, I/A 7 ( 9.03.10).

22 de Marzo de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: ZOIDO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER. Presidente: ZOIDO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER.Revocaciones. Apoderado: ZOIDO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER;ZOIDO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos.Consejero: SANCHEZ DEL VILLAR BOCETA ENRIQUE. Presidente: SANCHEZ DEL VILLAR BOCETA ENRIQUE. Apoderado:SANCHEZ DEL VILLAR BOCETA ENRIQUE. Datos registrales. T 24412 , F 176, S 8, H M 439073, I/A 7 ( 9.03.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n