Actos BORME de A&c Signature Properties Sl
04 de Febrero de 2022Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: ASCHL VEILLON DAVID;CALVET MARTINEZ MOISES. LIQUIDADOR: ASCHL VEILLONDAVID;CALVET MARTINEZ MOISES. Nombramientos. LIQUIDADOR: ASCHL VEILLON DAVID;CALVET MARTINEZ MOISES.Extinci贸n. Datos registrales. T 40613 , F 95, S 8, H B 369363, I/A 7 (26.01.22).
18 de Junio de 2019Fe de erratas: En el BORME no.47/2018 y con referencia 107738 SE RECTIFICA EN CUANTO A LA OMISION DEL NUMERO DEPOLICIA DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, SIENDO EL NUMERO 21. Datos registrales. T 40613 , F 95, S 8, H B 369363, I/A 6(28.02.18).
07 de Marzo de 2018Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: ASCHL VEILLON DAVID;CALVET MARTINEZ MOISES. Cambio de domicilio social. CLFRANCESC CARBONELL ESC.IZQUIERDA P.EN PTA.2 (BARCELONA). Datos registrales. T 40613 , F 95, S 8, H B 369363, I/A 6(28.02.18).
20 de Diciembre de 2017Revocaciones. ADM.UNICO: ALAN ALFRED PLANT. ADM.SOLIDAR.: COLLETTE NIXON. Datos registrales. T 40613 , F 95, S 8,H B 369363, I/A 5 (12.12.17).
09 de Marzo de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 190.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 350.000,00 Euros. Cambio de domicilio social. PZ ADRIANum.4 P.2 PTA.2 (BARCELONA). Datos registrales. T 40613 , F 94, S 8, H B 369363, I/A 4 (29.02.12).
14 de Noviembre de 2011Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: COLLETTE NIXON. Ampliaci贸n de capital. Capital: 40.000,00 Euros. Resultante Suscrito:160.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 9.-TRANSMISION DE PARTICIPACIONES. Otros conceptos:PERDIDA DEL CARACTER DE UNIPERSONAL. Datos registrales. T 40613 , F 93, S 8, H B 369363, I/A 3 (28.10.11).