Buscador CIF Logo

Actos BORME Acciona Facility Services Empleo Social Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Acciona Facility Services Empleo Social Sl

Actos BORME Acciona Facility Services Empleo Social Sl - B85551265

Tenemos registrados 31 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Acciona Facility Services Empleo Social Sl con CIF B85551265

馃敊 Perfil de Acciona Facility Services Empleo Social Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Acciona Facility Services Empleo Social Sl

03 de Agosto de 2023
Cambio de domicilio social. AVDA TENERIFE, NUMERO 4 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES). Datos registrales. T 26151 , F224, S 8, H M 471340, I/A 35 (26.07.23).

18 de Mayo de 2023
Ceses/Dimisiones. Representan: HERVAS RODRIGUEZ-MANZANEQUE ROSA MARIA. Nombramientos. Representan: ZABALALOPEZ-GOMEZ MARIA DEL SOL. Datos registrales. T 26151 , F 224, S 8, H M 471340, I/A 34 (10.05.23).

01 de Marzo de 2023
Ceses/Dimisiones. Representan: SERRANO PEREZ DAVID. Nombramientos. Representan: HERVAS RODRIGUEZ-MANZANEQUE ROSA MARIA. Datos registrales. T 26151 , F 223, S 8, H M 471340, I/A 32 (22.02.23).

Ceses/Dimisiones. Representan: MARTINEZ DE BARTOLOME IZQUIERDO CRISTINA. Nombramientos. Representan:MANRIQUE DE PAULA CESAR. Datos registrales. T 26151 , F 223, S 8, H M 471340, I/A 33 (22.02.23).

14 de Octubre de 2020
Ceses/Dimisiones. Representan: LAPUENTE SASTRE FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Representan: MARTINEZ DEBARTOLOME IZQUIERDO CRISTINA. Datos registrales. T 26151 , F 223, S 8, H M 471340, I/A 31 ( 6.10.20).

28 de Febrero de 2019
Nombramientos. Representan: SERRANO PEREZ DAVID. Datos registrales. T 26151 , F 222, S 8, H M 471340, I/A 30 (21.02.19).

25 de Septiembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Representan: RODRIGUEZ BORGES TOMAS. Nombramientos. Representan: LAPUENTE SASTREFRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 26151 , F 222, S 8, H M 471340, I/A 29 (14.09.18).

13 de Abril de 2018
Revocaciones. Apo.Sol.: CRUZ PALACIOS JUAN MANUEL;GOMEZ HORTIGUELA SAINZ IGNACIO;VEGA PENICHET LOPEZJORGE;DE SANTAMARIA DE PAREDES CASTILLO VICENTE;FIGUEROA GOMEZ DE SALAZAR JOSE JULIO;FERNANDEZVILLAVERDE GUTIERREZ RAIMUNDO;FERRAN HUETE IGNACIO;CALLEJO MARTINEZ ALFONSO;HIDALGO CAMPOSJUAN;HERNANDEZ ONTALBA LUIS;CRUZ PALACIOS JUAN MANUEL. Apoderado: RIBO NIRELLA FRANCESC;MARTI JARNEFRANCISCO JAVIER;HARO MARTINEZ MARIA;BEARDO ANDREU MANUEL;MARI SERRA POL;RODRIGUEZ BORGESTOMAS;CARRASCO DORADO ANTONIO;AMETLLER CUSCO JORDI. Apo.Manc.: MARI SERRA JOAN PAU. Apo.Man.Soli:MIRANDA FERRIS JOSE MARIA. Apoderado: GARCIA ALONSO FERNANDO;GARCIA ALONSO FERNANDO;GARCIA ALONSOFERNANDO;BENEDICTO RODRIGUEZ JUAN. Apo.Man.Soli: HERNANDEZ GARCIA RUTH. Apo.Sol.: CRESPO SASTREFRANCISCO;RAMIREZ OCHOA RAQUEL. Datos registrales. T 26151 , F 222, S 8, H M 471340, I/A 28 ( 6.04.18).

06 de Noviembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: APODERADA GENERAL DE SERVICE SA. Datos registrales. T 26151 , F 220, S 8, H M 471340, I/A27 (27.10.17).

26 de Mayo de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: CRESPO SASTRE FRANCISCO;RAMIREZ OCHOA RAQUEL. Datos registrales. T 26151 , F 219, S 8,H M 471340, I/A 26 (18.05.17).

02 de Diciembre de 2014
Nombramientos. Apo.Sol.: DE UGARTE FIGUERO NAGORE;CAMPILLO ORIVE ANGEL. Datos registrales. T 26151 , F 218, S 8,H M 471340, I/A 24 (24.11.14).

Revocaciones. Apo.Sol.: DEL CAMPO PASTOR JUAN;TERREROS GANCEDO RODRIGUEZ CATALINA. Datos registrales. T26151 , F 219, S 8, H M 471340, I/A 25 (24.11.14).

08 de Abril de 2014
Nombramientos. Apo.Man.Soli: HERNANDEZ GARCIA RUTH. Datos registrales. T 26151 , F 217, S 8, H M 471340, I/A 23(27.03.14).

06 de Noviembre de 2013
Nombramientos. Apoderado: BENEDICTO RODRIGUEZ JUAN. Datos registrales. T 26151 , F 217, S 8, H M 471340, I/A 22(28.10.13).

04 de Noviembre de 2013
Ceses/Dimisiones. Representan: FERRAN HUETE IGNACIO. Nombramientos. Representan: ROLDAN MONTAUD JAVIER.Datos registrales. T 26151 , F 216, S 8, H M 471340, I/A 21 (24.10.13).

09 de Septiembre de 2013
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ DE BARTOLOME IZQUIERDO CRISTINA. Datos registrales. T 26151 , F 216, S 8, H M471340, I/A 20 (30.08.13).

16 de Abril de 2012
Nombramientos. Apoderado: GARCIA ALONSO FERNANDO;GARCIA ALONSO FERNANDO;GARCIA ALONSO FERNANDO.Datos registrales. T 26151 , F 215, S 8, H M 471340, I/A 19 ( 2.04.12).

26 de Marzo de 2012
Nombramientos. Apo.Manc.: MARI SERRA JOAN PAU. Datos registrales. T 26151 , F 214, S 8, H M 471340, I/A 17 (13.03.12).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: MIRANDA FERRIS JOSE MARIA. Datos registrales. T 26151 , F 214, S 8, H M 471340, I/A 18(13.03.12).

24 de Octubre de 2011
Nombramientos. Apoderado: AMETLLER CUSCO JORDI. Datos registrales. T 26151 , F 213, S 8, H M 471340, I/A 16 (11.10.11).

17 de Octubre de 2011
Nombramientos. Apoderado: RIBO NIRELLA FRANCESC. Datos registrales. T 26151 , F 34, S 8, H M 471340, I/A 10 ( 4.10.11).

Nombramientos. Apoderado: MARTI JARNE FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 26151 , F 35, S 8, H M 471340, I/A 11 (4.10.11).

Nombramientos. Apoderado: HARO MARTINEZ MARIA;BEARDO ANDREU MANUEL. Datos registrales. T 26151 , F 35, S 8, H M471340, I/A 12 ( 4.10.11).

Nombramientos. Apoderado: MARI SERRA POL. Datos registrales. T 26151 , F 36, S 8, H M 471340, I/A 13 ( 4.10.11).

Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ BORGES TOMAS. Datos registrales. T 26151 , F 36, S 8, H M 471340, I/A 14 (4.10.11).

Nombramientos. Apoderado: CARRASCO DORADO ANTONIO. Datos registrales. T 26151 , F 213, S 8, H M 471340, I/A 15 (5.10.11).

04 de Enero de 2011
Ampliaci贸n de capital. Capital: 150.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 153.010,00 Euros. Datos registrales. T 26151 , F 34, S 8, HM 471340, I/A 9 (24.12.10).

06 de Septiembre de 2010
Cambio de objeto social. FOMENTO DE EMPLEO E INTEGRACION SOCIO-LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADFISICA, PSIQUICA, SENSORIAL O MENTAL, DESTACANDO PRIORITARIAMENTE LA FORMACION Y EL EMPLEO ASI COMO LAACCESIBILIDAD Y LA SUPERACION DE BARRERAS DECUALQUIER CLASE. PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DEBIENES INMUEBLES Y. Datos registrales. T 26151 , F 34, S 8, H M 471340, I/A 8 (24.08.10).

24 de Agosto de 2010
Ceses/Dimisiones. Representan: CASAMADA BRAGULAT IGNACIO. Nombramientos. Representan: RODRIGUEZ BORGESTOMAS. Datos registrales. T 26151 , F 33, S 8, H M 471340, I/A 7 (13.08.10).

02 de Septiembre de 2009
Ampliacion del objeto social. LA EMPRESA SE CONSTITUYE PARA SU REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO COMO CENTROESPECIAL DE EMPLEO SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 42 DE LA LEY 13/82 DE INTEGRACION SOCIAL DEMINUSVALIDOS. Datos registrales. T 26151 , F 33, S 8, H M 471340, I/A 6 (17.08.09).

20 de Mayo de 2009
Ceses/Dimisiones. Representan: FERNANDEZ-VILLAVERDE GUTIERREZ RAIMUNDO. Nombramientos. Representan: FERRANHUETE IGNACIO. Datos registrales. T 26151 , F 32, S 8, H M 471340, I/A 5 ( 7.05.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n