Buscador CIF Logo

Actos BORME Accorhotels & Community Services Spain Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Accorhotels & Community Services Spain Sl

Actos BORME Accorhotels & Community Services Spain Sl - B83892422

Tenemos registrados 57 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Accorhotels & Community Services Spain Sl con CIF B83892422

🔙 Perfil de Accorhotels & Community Services Spain Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Accorhotels & Community Services Spain Sl

28 de Febrero de 2023
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 35567 , F 148, S 8, H M 344785,I/A 83 (21.02.23).

22 de Febrero de 2022
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA RAMOS LAURA;GIRARD CARINE;EP. BAILLY MAUD ALINE ANTOINETTEJUTTEAU;MANCHERON DENIS GABRIEL RAPHAEL;RAMOS FERNANDEZ CRISTINA;MOUSSIE MARIE;ROBIN THOMASHENRI;RAYMOND ALEX;TRINH ERIC;WAGNER KATIA;MORIN JEAN-JACQUES;BRISSOT SOPHIA;BOISSELIERPIERRE;BEAULIER FABRICE;LAURENT PATRICK. Datos registrales. T 35567 , F 147, S 8, H M 344785, I/A 82 (15.02.22).

15 de Febrero de 2022
Nombramientos. Apoderado: DARDENNE MARC FRANCOIS. Datos registrales. T 35567 , F 145, S 8, H M 344785, I/A 80 (8.02.22).

Revocaciones. Apoderado: BRISSOT SOPHIA;BOISSELIER PIERRE;MORIN JEAN-JACQUES;EP. BAILLY MAUD ALINEANTOINETTE JUTTEAU;TRINH ERIC;ROBIN THOMAS HENRI;GARCIA RAMOS LAURA;RAMOS FERNANDEZ CRISTINA;CABADAPERAL RAUL;PAPAZOGLOU JEAN-BAPTISTE PIERRE;PONT COLINE BENEDICTE;GIRARD CARINE. Datos registrales. T 35567, F 146, S 8, H M 344785, I/A 81 ( 8.02.22).

28 de Enero de 2022
Modificaciones estatutarias. 8. Funcionamiento Junta General.-. Datos registrales. T 35567 , F 141, S 8, H M 344785, I/A 72(21.01.22).

Nombramientos. Apoderado: MANCHERON DENIS GABRIEL RAPHAEL. Datos registrales. T 35567 , F 141, S 8, H M 344785, I/A73 (21.01.22).

Revocaciones. Apoderado: PAPAZOGLOU JEAN BAPTISTE. Datos registrales. T 35567 , F 142, S 8, H M 344785, I/A 74(21.01.22).

Revocaciones. Apoderado: PAPAZOGLOU JEAN BAPTISTE. Datos registrales. T 35567 , F 143, S 8, H M 344785, I/A 75(21.01.22).

Revocaciones. Apo.Sol.: LAMATA GIMENEZ SUSANA. Datos registrales. T 35567 , F 143, S 8, H M 344785, I/A 76 (21.01.22).

Nombramientos. Apoderado: DI TULLIO IAN. Datos registrales. T 35567 , F 143, S 8, H M 344785, I/A 77 (21.01.22).

Nombramientos. Apoderado: GRANGE XAVIER PIERRE. Datos registrales. T 35567 , F 144, S 8, H M 344785, I/A 78 (21.01.22).

Nombramientos. Apoderado: LASSARA JEROME PHILLIPPE. Datos registrales. T 35567 , F 145, S 8, H M 344785, I/A 79(21.01.22).

20 de Mayo de 2021
Revocaciones. Apoderado: MORIN JEAN-JACQUES;BOISSELIER PIERRE;BRISSOT SOPHIA;TRINH ERIC;LARSSONMARIA;WAGNER KATIA;DELGADO JEAN CHARLES;RAMOS FERNANDEZ CRISTINA;GARCIA RAMOS LAURA;MOUSSIEMARIE;PAPAZOGLOU JEAN BAPTISTE;QUEIJA REGIANE;CABADA PERAL RAUL. Nombramientos. Apoderado: BRISSOTSOPHIA;BOISSELIER PIERRE;MORIN JEAN-JACQUES;EP. BAILLY MAUD ALINE ANTOINETTE JUTTEAU;TRINH ERIC;ROBINTHOMAS HENRI;GARCIA RAMOS LAURA;RAMOS FERNANDEZ CRISTINA;CABADA PERAL RAUL;PAPAZOGLOU JEAN-BAPTISTE PIERRE;PONT COLINE BENEDICTE;GIRARD CARINE. Datos registrales. T 35567 , F 139, S 8, H M 344785, I/A 71(13.05.21).

22 de Abril de 2021
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: JEAN CHARLES DELGADO. Nombramientos. Adm. Unico: EP. BAILLY MAUD ALINEANTOINETTE JUTTEAU. Datos registrales. T 35567 , F 135, S 8, H M 344785, I/A 64 (15.04.21).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA FERNANDEZ DE MESA MARIANA. Datos registrales. T 35567 , F 135, S 8, H M 344785, I/A65 (15.04.21).

Nombramientos. Apoderado: ROBIN THOMAS HENRI;PAPAZOGLOU JEAN-BAPTISTE PIERRE. Datos registrales. T 35567 , F135, S 8, H M 344785, I/A 66 (15.04.21).

Nombramientos. Apoderado: SAPPEY DENYS CHRISTIAN JAQUES;PAPAZOGLOU JEAN-BAPTISTE PIERRE. Datos registrales.T 35567 , F 136, S 8, H M 344785, I/A 67 (15.04.21).

Nombramientos. Apoderado: RAMOS FERNANDEZ CRISTINA;PAPAZOGLOU JEAN-BAPTISTE PIERRE. Datos registrales. T35567 , F 138, S 8, H M 344785, I/A 68 (15.04.21).

Revocaciones. Apoderado: RAMOS FERNANDEZ CRISTINA. Datos registrales. T 35567 , F 139, S 8, H M 344785, I/A 69(15.04.21).

Revocaciones. Apo.Sol.: DE LA FERRIERE DIDIER. Datos registrales. T 35567 , F 139, S 8, H M 344785, I/A 70 (15.04.21).

28 de Septiembre de 2020
Nombramientos. Apoderado: RAMOS FERNANDEZ CRISTINA. Datos registrales. T 35567 , F 134, S 8, H M 344785, I/A 62(21.09.20).

Nombramientos. Apoderado: PAPAZOGLOU JEAN BAPTISTE. Datos registrales. T 35567 , F 134, S 8, H M 344785, I/A 63(21.09.20).

08 de Junio de 2020
Nombramientos. Apoderado: DELGADO JEAN CHARLES. Datos registrales. T 35567 , F 132, S 8, H M 344785, I/A 60 ( 1.06.20).

Revocaciones. Apoderado: MORIN JEAN-JACQUES;BOISSELIER PIERRE;JEAN CHARLES DELGADO;SANZ MERINO ROSAANA;GARCIA RAMOS LAURA;CABADA PERAL RAUL;RAMOS FERNANDEZ CRISTINA;TENO YANN LE;CARLOT AMNELI.Nombramientos. Apoderado: MORIN JEAN-JACQUES;BOISSELIER PIERRE;BRISSOT SOPHIA;TRINH ERIC;LARSSONMARIA;WAGNER KATIA;DELGADO JEAN CHARLES;RAMOS FERNANDEZ CRISTINA;GARCIA RAMOS LAURA;MOUSSIEMARIE;PAPAZOGLOU JEAN BAPTISTE;QUEIJA REGIANE;CABADA PERAL RAUL. Datos registrales. T 35567 , F 133, S 8, H M344785, I/A 61 ( 1.06.20).

05 de Junio de 2020
Nombramientos. Apoderado: PAPAZOGLOU JEAN BAPTISTE. Datos registrales. T 35567 , F 131, S 8, H M 344785, I/A 59(29.05.20).

25 de Febrero de 2020
Revocaciones. Apo.Sol.: CLEVENOT AYROLES SYLVIE MARIE JOSE COLETTE;CLEVENOT AYROLES SYLVIE MARIE JOSECOLETTE. Apoderado: CLEVENOT AYROLES SYLVIE MARIE JOSE COLETTE. Datos registrales. T 35567 , F 131, S 8, H M344785, I/A 58 (18.02.20).

23 de Diciembre de 2019
Revocaciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.Datos registrales. T 35567 , F 131, S 8, H M 344785, I/A 57 (16.12.19).

05 de Diciembre de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA RAMOS LAURA;CABADA PERAL RAUL. Datos registrales. T 35567 , F 130, S 8, H M 344785,I/A 56 (28.11.19).

04 de Diciembre de 2019
Revocaciones. Apo.Sol.: ARAQUE MARTINEZ PEDRO CARLOS. Apoderado: ARAQUE MARTINEZ PEDRO CARLOS. Datosregistrales. T 35567 , F 130, S 8, H M 344785, I/A 55 (27.11.19).

05 de Febrero de 2019
Revocaciones. Apoderado: ADEVA MORALES MARIA JESUS;SERAROLS BALLUS MARC. Datos registrales. T 35567 , F 130, S8, H M 344785, I/A 54 (29.01.19).

24 de Diciembre de 2018
Revocaciones. Apoderado: GOMEZ CARRERA ELENA CRISTINA. Nombramientos. Apo.Sol.: PONT COLINEBENEDICTE;THOUET LIONEL JEAN JACQUES CHARLES;RENAULT HERVE JEAN ALAIN;GUIOUILLER LAURENT;DONNARDANTOINE;VASSOUT KEVIN. Datos registrales. T 35567 , F 130, S 8, H M 344785, I/A 53 (14.12.18).

14 de Noviembre de 2018
Revocaciones. Apo.Sol.: DEL BARCO HERNANDEZ JESUS. Datos registrales. T 35567 , F 129, S 8, H M 344785, I/A 52 (5.11.18).

06 de Noviembre de 2018
Revocaciones. Apo.Sol.: SANCHEZ JEAN FRANCOIS. Nombramientos. Apoderado: GOMEZ CARRERA ELENACRISTINA;ALEXANDRE CARDOSO ANTERO. Datos registrales. T 35567 , F 129, S 8, H M 344785, I/A 51 (29.10.18).

05 de Junio de 2018
Nombramientos. Apoderado: RAMOS FERNANDEZ CRISTINA. Datos registrales. T 35567 , F 128, S 8, H M 344785, I/A 50(29.05.18).

04 de Junio de 2018
Revocaciones. Apo.Sol.: SERAROLS BALLUS MARC. Datos registrales. T 35567 , F 128, S 8, H M 344785, I/A 49 (25.05.18).

14 de Mayo de 2018
Cambio de domicilio social. C/ AREQUIPA 1 - 2ª PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 35567 , F 128, S 8, H M 344785, I/A 48( 4.05.18).

23 de Enero de 2018
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 35567 , F 127, S 8, H M 344785, I/A 47 (15.01.18).

21 de Diciembre de 2017
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 43ª EL PODER OTORGADO A CABADA PEAL RAUL, SIENDO OCORRECTO CABADA PERAL RAUL. Datos registrales. T 35567 , F 125, S 8, H M 344785, I/A 43 ( 4.12.17).

19 de Diciembre de 2017
Revocaciones. Apoderado: TERRYN PHILIPPE. Datos registrales. T 35567 , F 127, S 8, H M 344785, I/A 45 ( 5.12.17).

18 de Diciembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: ARAQUE MARTINEZ PEDRO CARLOS. Datos registrales. T 35567 , F 127, S 8, H M 344785, I/A 44 (5.12.17).

Otros conceptos: Rectificación del poder otorgado a Don Juan Carlos Gutiérrez Rodríguez mediante escritura autorizada en Madrid,por la notaria Doña María del Rosario Algora Wesolwski el día 5 de junio de 2017 con el número de protocolo 606, que originó lainscripción 37ª de la hoja registral. Datos registrales. T 35567 , F 127, S 8, H M 344785, I/A 46 ( 7.12.17).

14 de Diciembre de 2017
Revocaciones. Apoderado: MORIN JEAN-JACQUES;BOISSELIER PIERRE;OTMANI LATIFA;CARLOT ANNELI;DELGADO JEANCHARLES;ZANFONI FABIENNE BERNADETTE;ADEVA MORALES MARGARITA;VISUÑA RODRIGUEZ BEATRIZ;MARTINSMARQUES LUIS DELFIM MATIAS;CLEVENOT AYROLES SYLVIE MARIE JOSE COLETTE;ROIG BERASATEGUI JUANMANUEL;LOPES DA SILVA DANIEL JORGE. Nombramientos. Apoderado: MORIN JEAN-JACQUES;BOISSELIER PIERRE;JEANCHARLES DELGADO;CLEVENOT AYROLES SYLVIE MARIE JOSE COLETTE;SANZ MERINO ROSA ANA;GARCIA RAMOSLAURA;CABADA PEAL RAUL;ADEVA MORALES MARIA JESUS;RAMOS FERNANDEZ CRISTINA;SERAROLS BALLUSMARC;TENO YANN LE;CARLOT AMNELI. Datos registrales. T 35567 , F 125, S 8, H M 344785, I/A 43 ( 4.12.17).

14 de Agosto de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA FERNANDEZ DE MESA MARIANA. Datos registrales. T 35567 , F 125, S 8, H M 344785, I/A42 ( 7.08.17).

07 de Agosto de 2017
Pérdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 35567 , F 124, S 8, H M 344785, I/A 41 (28.07.17).

19 de Julio de 2017
Reducción de capital. Importe reducción: 4.381.490,00 Euros. Resultante Suscrito: 618.510,00 Euros. Ampliación de capital.Capital: 13.211.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 13.830.010,00 Euros. Datos registrales. T 19616 , F 222, S 8, H M 344785, I/A 40(12.07.17).

28 de Junio de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: LAMATA GIMENEZ SUSANA. Datos registrales. T 19616 , F 220, S 8, H M 344785, I/A 36 (20.06.17).

Nombramientos. Apo.Sol.: GUTIERREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 19616 , F 221, S 8, H M 344785, I/A 37(20.06.17).

Nombramientos. Apo.Sol.: ARAQUE MARTINEZ PEDRO CARLOS. Datos registrales. T 19616 , F 221, S 8, H M 344785, I/A 38(20.06.17).

Nombramientos. Apo.Sol.: CLEVENOT AYROLES SYLVIE MARIE JOSE COLETTE. Datos registrales. T 19616 , F 222, S 8, H M344785, I/A 39 (20.06.17).

27 de Junio de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: DEL BARCO HERNANDEZ JESUS. Datos registrales. T 19616 , F 218, S 8, H M 344785, I/A 30(19.06.17).

Nombramientos. Apo.Sol.: SERAROLS BALLUS MARC. Datos registrales. T 19616 , F 218, S 8, H M 344785, I/A 31 (19.06.17).

Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ JEAN FRANCOIS. Datos registrales. T 19616 , F 219, S 8, H M 344785, I/A 32 (19.06.17).

Nombramientos. Apo.Sol.: RAMOS FERNANDEZ CRISTINA. Datos registrales. T 19616 , F 219, S 8, H M 344785, I/A 33(19.06.17).

Revocaciones. Apoderado: ZANFONI FABIENNE BERNADETTE. Datos registrales. T 19616 , F 220, S 8, H M 344785, I/A 34(19.06.17).

Nombramientos. Apoderado: GOMEZ CARRERA ELENA CRISTINA. Datos registrales. T 19616 , F 220, S 8, H M 344785, I/A 35(19.06.17).

26 de Junio de 2017
Ampliacion del objeto social. franquiciador de marcas hoteleras, central de compras, centro de Formación excluyendo la formacióneste impartida por una entidad pública o entidad privada autorizada, que imparta cursos previstos en los planes del ministerio deeducacion. Datos registrales. T 19616 , F 217, S 8, H M 344785, I/A 28 (15.06.17).

Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: DELGADO JEAN CHARLES;ZANFONI FABIENNE. Nombramientos. Adm. Unico: JEANCHARLES DELGADO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradorúnico. Datos registrales. T 19616 , F 217, S 8, H M 344785, I/A 29 (15.06.17).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información