Buscador CIF Logo

Actos BORME Aceica Refineria Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Aceica Refineria Sl

Actos BORME Aceica Refineria Sl - B35654193

Tenemos registrados 10 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Aceica Refineria Sl con CIF B35654193

馃敊 Perfil de Aceica Refineria Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Aceica Refineria Sl

18 de Febrero de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: COLLAR FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN;ARIZA CASTRO JOAQUIN. Secretario: COLLARFERNANDEZ MARIA DEL CARMEN. Consejero: SILVA ALCALDE IGNACIO. Presidente: SILVA ALCALDE IGNACIO. Con.Delegado:SILVA ALCALDE IGNACIO. Nombramientos. Liquidador: SILVA ALCALDE IGNACIO. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datosregistrales. T 39139 , F 201, S 8, H M 557419, I/A 11 (11.02.22).

08 de Agosto de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: TOSATO PIERLUIGI. Presidente: TOSATO PIERLUIGI. Con.Delegado: TOSATO PIERLUIGI.Nombramientos. Consejero: SILVA ALCALDE IGNACIO. Presidente: SILVA ALCALDE IGNACIO. Con.Delegado: SILVA ALCALDEIGNACIO. Datos registrales. T 30967 , F 30, S 8, H M 557419, I/A 10 ( 1.08.19).

03 de Septiembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: MATOSES GARCIA-VALDES FERNANDA. Secretario: MATOSES GARCIA-VALDES FERNANDA.Nombramientos. Consejero: ARIZA CASTRO JOAQUIN. Secretario: COLLAR FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN. Datosregistrales. T 30967 , F 30, S 8, H M 557419, I/A 9 (27.08.18).

12 de Marzo de 2018
Modificaciones estatutarias. Se modifican los ARTICULOS 9 Y 14 de los Estatutos.-. Datos registrales. T 30967 , F 29, S 8, H M557419, I/A 8 ( 1.03.18).

08 de Marzo de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: ARROYO PRIETO MANUEL. Presidente: ARROYO PRIETO MANUEL. Con.Delegado: ARROYOPRIETO MANUEL. Nombramientos. Consejero: TOSATO PIERLUIGI. Presidente: TOSATO PIERLUIGI. Con.Delegado: TOSATOPIERLUIGI. Datos registrales. T 30967 , F 27, S 8, H M 557419, I/A 7 ( 1.03.18).

04 de Noviembre de 2016
Modificaciones estatutarias. Se modifican los articulos 14 y 16 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 30967 , F 26, S 8, H

09 de Octubre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: CARBO FERNANDEZ JAIME. Con.Delegado: CARBO FERNANDEZ JAIME. Presidente: CARBOFERNANDEZ JAIME. Nombramientos. Consejero: ARROYO PRIETO MANUEL. Presidente: ARROYO PRIETO MANUEL.Con.Delegado: ARROYO PRIETO MANUEL. Datos registrales. T 30967 , F 24, S 8, H M 557419, I/A 5 ( 2.10.15).

03 de Junio de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: JORDA CASTRO MARIA LUISA. Nombramientos. Consejero: COLLAR FERNANDEZ MARIA DELCARMEN. Datos registrales. T 30967 , F 24, S 8, H M 557419, I/A 4 (25.05.15).

07 de Febrero de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: COLLANTES MOLINERO JOSE MARIA. Secretario: COLLANTES MOLINERO JOSE MARIA.Nombramientos. Consejero: MATOSES GARCIA-VALDES FERNANDA. Secretario: MATOSES GARCIA-VALDES FERNANDA.Datos registrales. T 30967 , F 24, S 8, H M 557419, I/A 3 (30.01.14).

17 de Abril de 2013
Cambio de domicilio social. C/ MARIE CURIE 7 (RIVAS-VACIAMADRID). Datos registrales. T 30967 , F 24, S 8, H M 557419, I/A2 ( 8.04.13).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n