Actos BORME de Aceites La Muralla Sl
12 de Agosto de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: VILLEN JIMENEZ NICOLAS. Secretario: VILLEN JIMENEZ NICOLAS. Nombramientos. Consejero:VILLEN ALONSO IGNACIO. Secretario: VILLEN ALONSO IGNACIO. Apo.Manc.: GIL VILLEN FRANCISCO AURELIO;VILLENALONSO IGNACIO;VILLEN SANCHEZ JORGE TEODORO;VILLEN OTERO MANUEL;RUIZ VILLEN JOSE ANTONIO. Datosregistrales. T 2384 , F 167, S 8, H CO 3586, I/A 18 ( 5.08.22).
24 de Julio de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: VILLEN JIMENEZ CARMEN. Presidente: VILLEN JIMENEZ CARMEN. Consejero: VILLEN JIMENEZNICOLAS. Secretario: VILLEN JIMENEZ NICOLAS. Consejero: VILLEN JIMENEZ CLOTILDE. Vicesecret.: VILLEN JIMENEZCLOTILDE. Consejero: VILLEN OTERO MANUEL;VILLEN JIMENEZ JORGE. Nombramientos. Consejero: RUIZ VILLEN JOSEANTONIO. Presidente: RUIZ VILLEN JOSE ANTONIO. Consejero: VILLEN JIMENEZ NICOLAS. Secretario: VILLEN JIMENEZNICOLAS. Consejero: GIL VILLEN FRANCISCO AURELIO;VILLEN SANCHEZ JORGE TEODORO;VILLEN OTERO MANUEL.Apo.Manc.: GIL VILLEN FRANCISCO AURELIO;VILLEN SANCHEZ JORGE TEODORO;VILLEN JIMENEZ NICOLAS;RUIZ VILLENJOSE ANTONIO. Apo.Man.Soli: VILLEN OTERO MANUEL. Datos registrales. T 2384 , F 165, S 8, H CO 3586, I/A 17 (20.07.20).
18 de Octubre de 2016Nombramientos. Consejero: VILLEN JIMENEZ JORGE. Datos registrales. T 2384 , F 164, S 8, H CO 3586, I/A 15 (10.10.16).
Nombramientos. Apo.Manc.: VILLEN JIMENEZ JORGE. Datos registrales. T 2384 , F 164, S 8, H CO 3586, I/A 16 (10.10.16).
18 de Agosto de 2015Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 71.955,00 Euros. Resultante Suscrito: 982.800,00 Euros. Datos registrales. T 2384 , F162, S 8, H CO 3586, I/A 14 (11.08.15).
06 de Febrero de 2014Revocaciones. Apo.Man.Soli: VILLEN JIMENEZ JORGE. Datos registrales. T 647 , F 95, S 8, H CO 3586, I/A 9 (30.01.14).
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: VILLEN JIMENEZ CARMEN;VILLEN JIMENEZ NICOLAS;VILLEN JIMENEZ CLOTILDE;VILLENJIMENEZ JORGE;VILLEN OTERO MANUEL. Datos registrales. T 647 , F 96, S 8, H CO 3586, I/A 10 (30.01.14).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: VILLEN OTERO MANUEL. Datos registrales. T 647 , F 96, S 8, H CO 3586, I/A 11 (30.01.14).
Nombramientos. Apo.Manc.: VILLEN JIMENEZ CARMEN;VILLEN JIMENEZ CLOTILDE;VILLEN JIMENEZ NICOLAS;VILLENOTERO MANUEL. Datos registrales. T 2384 , F 161, S 8, H CO 3586, I/A 12 (30.01.14).
Ceses/Dimisiones. Consejero: VILLEN JIMENEZ JORGE. Datos registrales. T 2384 , F 162, S 8, H CO 3586, I/A 13 (30.01.14).
23 de Diciembre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: VILLEN JIMENEZ MANUEL. Vicepresid.: VILLEN JIMENEZ MANUEL. Cons.Del.Man: VILLENJIMENEZ MANUEL. Nombramientos. Consejero: VILLEN OTERO MANUEL. Cons.Del.Man: VILLEN OTERO MANUEL.Modificaciones estatutarias. 13. Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 647 , F 95, S 8, H CO 3586, I/A 8(16.12.13).
07 de Marzo de 2011Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: VILLEN JIMENEZ JORGE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: VILLEN JIMENEZ JORGE. Consejero:VILLEN JIMENEZ CARMEN. Presidente: VILLEN JIMENEZ CARMEN. Cons.Del.Man: VILLEN JIMENEZ CARMEN. Consejero:VILLEN JIMENEZ MANUEL. Vicepresid.: VILLEN JIMENEZ MANUEL. Cons.Del.Man: VILLEN JIMENEZ MANUEL. Consejero: VILLENJIMENEZ NICOLAS. Secretario: VILLEN JIMENEZ NICOLAS. Cons.Del.Man: VILLEN JIMENEZ NICOLAS. Consejero: VILLENJIMENEZ CLOTILDE. Vicesecret.: VILLEN JIMENEZ CLOTILDE. Cons.Del.Man: VILLEN JIMENEZ CLOTILDE. Consejero: VILLENJIMENEZ JORGE. Cons.Del.Man: VILLEN JIMENEZ JORGE. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 19.Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 647 , F 93, S 8, H CO 3586, I/A 7 (25.02.11).