Actos BORME de Aceites Montalban Sa
06 de Noviembre de 2023Nombramientos. Cons.Del.Man: JIMENEZ ZURERA RAFAEL;MARQUEZ GONZALEZ ANTONIO;GONZALEZ LOPEZ FRANCISCOJESUS. Datos registrales. T 2351 , F 75, S 8, H CO 31309, I/A 15 (27.10.23).
24 de Octubre de 2023Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: JIMENEZ ZURERA RAFAEL;MARQUEZ GONZALEZ ANTONIO;GONZALEZ LOPEZFRANCISCO JESUS. Reelecciones. Consejero: JIMENEZ ZURERA RAFAEL. Presidente: JIMENEZ ZURERA RAFAEL. Consejero:MARQUEZ GONZALEZ ANTONIO;GONZALEZ LOPEZ FRANCISCO JESUS;RUZ LOPEZ RAFAEL;JIMENEZ MU脩OZANTONIO;GALVEZ LOPEZ ANTONIO. Secretario: GONZALEZ LOPEZ FRANCISCO JESUS. Cambio de objeto social. Lacompraventa de aceituna, aceite y derivados; la intermediaci贸n en dichas operaciones y la extracci贸n, almacenamiento, aderezo ycualquier tipo de manipulaci贸n de dichos productos. Actividades de preparaci贸n posterior a la cosecha. Comercio al por mayor defrutas y hortalizas. Datos registrales. T 2351 , F 74, S 8, H CO 31309, I/A 14 (17.10.23).
17 de Agosto de 2021Reelecciones. Auditor: CVM AUDITORES DE CUENTAS SL. Datos registrales. T 2351 , F 74, S 8, H CO 31309, I/A 13 ( 6.08.21).
16 de Enero de 2018Reelecciones. Auditor: CVM AUDITORES DE CUENTAS SL. Datos registrales. T 2351 , F 74, S 8, H CO 31309, I/A 12 ( 9.01.18).
25 de Octubre de 2017Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: JIMENEZ ZURERA RAFAEL;MARQUEZ GONZALEZ ANTONIO;GONZALEZ LOPEZFRANCISCO JESUS. Reelecciones. Consejero: JIMENEZ ZURERA RAFAEL. Presidente: JIMENEZ ZURERA RAFAEL. Consejero:MARQUEZ GONZALEZ ANTONIO;GONZALEZ LOPEZ FRANCISCO JESUS;RUZ LOPEZ RAFAEL;JIMENEZ MU脩OZANTONIO;GALVEZ LOPEZ ANTONIO. Secretario: GONZALEZ LOPEZ FRANCISCO JESUS. Datos registrales. T 2351 , F 73, S 8,H CO 31309, I/A 10 (18.10.17).
Nombramientos. Cons.Del.Man: JIMENEZ ZURERA RAFAEL;MARQUEZ GONZALEZ ANTONIO;GONZALEZ LOPEZ FRANCISCOJESUS. Datos registrales. T 2351 , F 73, S 8, H CO 31309, I/A 11 (18.10.17).
14 de Noviembre de 2016Ceses/Dimisiones. Secretario: MARQUEZ GONZALEZ ANTONIO. Nombramientos. Secretario: GONZALEZ LOPEZ FRANCISCO
26 de Junio de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 116.530,00 Euros. Resultante Suscrito: 568.459,00 Euros. Ampliaci贸n de capital.Suscrito: 116.530,00 Euros. Desembolsado: 116.530,00 Euros. Resultante Suscrito: 684.989,00 Euros. Resultante Desembolsado:684.989,00 Euros. Datos registrales. T 2243 , F 180, S 8, H CO 31309, I/A 8 (20.06.13).
22 de Febrero de 2013Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 59.003,00 Euros. Desembolsado: 59.003,00 Euros. Resultante Suscrito: 684.989,00 Euros.Resultante Desembolsado: 684.989,00 Euros. Datos registrales. T 2243 , F 179, S 8, H CO 31309, I/A 7 (18.02.13).
14 de Diciembre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: RUZ VALENZUELA ANTONIO. Datos registrales. T 2243 , F 179, S 8, H CO 31309, I/A 6 (10.12.12).
05 de Julio de 2012Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 471.266,00 Euros. Desembolsado: 471.266,00 Euros. Resultante Suscrito: 625.986,00 Euros.Resultante Desembolsado: 625.986,00 Euros. Modificaciones estatutarias. 10. Funcionamiento Junta Gral.-. Datos registrales. T2243 , F 176, S 8, H CO 31309, I/A 5 (26.06.12).
19 de Abril de 2012Nombramientos. Auditor: CARLOS VELASCO AUDITORIAS SL. Datos registrales. T 2243 , F 175, S 8, H CO 31309, I/A 4(10.04.12).
21 de Diciembre de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 94.120,00 Euros. Desembolsado: 94.120,00 Euros. Resultante Suscrito: 154.720,00 Euros.Resultante Desembolsado: 154.720,00 Euros. Datos registrales. T 2243 , F 175, S 8, H CO 31309, I/A 3 (12.12.11).
07 de Noviembre de 2011Nombramientos. Cons.Del.Man: JIMENEZ ZURERA RAFAEL;MARQUEZ GONZALEZ ANTONIO;GONZALEZ LOPEZ FRANCISCOJESUS. Datos registrales. T 2243 , F 174, S 8, H CO 31309, I/A 2 (27.10.11).
22 de Septiembre de 2011Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 9.09.11. Objeto social: La compraventa de aceituna, aceite y derivados; la intermediaci贸n endichas operaciones y la extracci贸n, almacenamiento, aderezo y cualquier tipo de manipulaci贸n de dichos productos. Domicilio: CTRADE MONTALBAN A PUENTE GENIL S/N (MONTALBAN DE CORDOBA). Capital suscrito: 60.600,00 Euros. Desembolsado: 60.600,00Euros. Nombramientos. Consejero: JIMENEZ ZURERA RAFAEL. Presidente: JIMENEZ ZURERA RAFAEL. Consejero: MARQUEZGONZALEZ ANTONIO. Secretario: MARQUEZ GONZALEZ ANTONIO. Consejero: GONZALEZ LOPEZ FRANCISCO JESUS;RUZLOPEZ RAFAEL;RUZ VALENZUELA ANTONIO;JIMENEZ MU脩OZ ANTONIO;GALVEZ LOPEZ ANTONIO. Datos registrales. T 2243, F 171, S 8, H CO 31309, I/A 1 (14.09.11).