Actos BORME de Aceper Sl
07 de Abril de 2021Revocaciones. Apoderado: CONDE IRIONDO DARIO. Datos registrales. T 877 , F 177, S 8, H OR 2948, I/A 24 (25.03.21).
22 de Enero de 2021Otros conceptos: CREACION DEL ARTICULO 2BIS DE LOS ESTATUTOS, RELATIVO A LA WEB CORPORATIVA YMODIFICACION DEL ARTICULO 18 RELATIVO A LA CONVOVATORIA Y CONSTITUCION DE L AJUNTA, REPRESNETACION,ACTAS Y VOTO A DISTANCIA EN LAS JUNTAS. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa:www.aceper.es. Datos registrales. T 877 , F 176, S 8, H OR 2948, I/A 23 ( 4.01.21).
07 de Mayo de 2019Cambio de domicilio social. C/ VIGO 2 - PARQUE TECNOLOXICO DE GALICIA (SAN CIBRAO DAS VI脩AS). Datos registrales. T877 , F 176, S 8, H OR 2948, I/A 22 (22.04.19).
10 de Agosto de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: CONDE RODICIO GIL CARLOS. Nombramientos. Consejero: RUANO MONZON MANUEL-GABRIEL. Datos registrales. T 877 , F 176, S 8, H OR 2948, I/A 21 (31.07.18).
01 de Septiembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: PI脩EL OSORO ANTONIO MARIA. Nombramientos. Consejero: CONDE IRIONDO IGOR. Otrosconceptos: Modificaci贸n del art铆culo 7 de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 814 , F 74, S 8, H OR 2948, I/A 20 (25.08.16).
21 de Enero de 2016Otros conceptos: Modificaci贸n y nueva redacci贸n del art铆culo 5 de los Estatutos Sociales referente al Capital Social, comoconsecuencia de la renumeraci贸n de las participaciones sociales. Datos registrales. T 814 , F 74, S 8, H OR 2948, I/A 19 (11.01.16).
28 de Agosto de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ FREIRE RAMON;GONZALEZ GARCIA JOSE. Secretario: GONZALEZ GARCIA JOSE.Consejero: CONDE RODICIO GIL CARLOS;GUILLEN CHICO FRANCISCO VICENTE;PI脩EL OSORO ANTONIO MARIA. Presidente:PI脩EL OSORO ANTONIO MARIA. Con.Delegado: GONZALEZ GARCIA JOSE. Nombramientos. Consejero: FERNANDEZVAZQUEZ ALBERTO ANTONIO;GONZALEZ GARCIA JOSE;CONDE RODICIO GIL CARLOS;GUILLEN CHICO FRANCISCOVICENTE;PI脩EL OSORO ANTONIO MARIA. Presidente: FERNANDEZ VAZQUEZ ALBERTO ANTONIO. Secretario: GONZALEZGARCIA JOSE. Con.Delegado: GONZALEZ GARCIA JOSE. Datos registrales. T 814 , F 73, S 8, H OR 2948, I/A 18 (18.08.14).
10 de Abril de 2014Ceses/Dimisiones. Presidente: GONZALEZ FREIRE RAMON. Con.Delegado: GONZALEZ FREIRE RAMON. Nombramientos.Presidente: PI脩EL OSORO ANTONIO MARIA. Con.Delegado: GONZALEZ GARCIA JOSE. Datos registrales. T 814 , F 72, S 8, HOR 2948, I/A 16 ( 1.04.14).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 468.186,79 Euros. Resultante Suscrito: 7.742.210,82 Euros. Datos registrales. T 814 , F 72, S 8, HOR 2948, I/A 17 ( 1.04.14).
05 de Mayo de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.042.752,35 Euros. Resultante Suscrito: 7.274.024,03 Euros. Datos registrales. T 401 , F 108, S 8,H OR 2948, I/A 15 (20.04.11).
22 de Octubre de 2009Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ VAZQUEZ ALBERTO ANTONIO. Datos registrales. T 401 , F 107, S 8, H OR 2948, I/A14 ( 8.10.09).