Actos BORME de Aceros Campollano De La Mancha Sociedad Anonima
03 de Agosto de 2023Reelecciones. Consejero: GONZALEZ LOPEZ JULIAN ANTONIO;MARTINEZ SANCHEZ JOSE AGUSTIN;NIETO GIMENEZFERNANDO PEDRO;NIETO GIMENEZ MARIA ASCENSION;NIETO GIMENEZ PEDRO PABLO. Presidente: NIETO GIMENEZFERNANDO PEDRO. Secretario: NIETO GIMENEZ PEDRO PABLO. Con.Delegado: NIETO GIMENEZ FERNANDO PEDRO. Datosregistrales. T 975, L 739, F 22, S 8, H AB 12628, I/A 26 (27.07.23).
10 de Enero de 2022Reelecciones. Auditor: MILLA MARTINEZ Y ASOCIADOS AUDITORES SOCIEDAD LIMI. Datos registrales. T 975, L 739, F 22, S8, H AB 12628, I/A 25 (30.12.21).
31 de Julio de 2019Ceses/Dimisiones. Presidente: NIETO GIMENEZ FERNANDO PEDRO. Con.Delegado: NIETO GIMENEZ FERNANDO PEDRO.Consejero: NIETO GIMENEZ FERNANDO PEDRO;NIETO GIMENEZ MARIA ASCENSION;GONZALEZ LOPEZ JULIANANTONIO;MARTINEZ SANCHEZ JOSE AGUSTIN. Secretario: NIETO GIMENEZ PEDRO PABLO. Consejero: NIETO GIMENEZPEDRO PABLO. Nombramientos. Consejero: NIETO GIMENEZ FERNANDO PEDRO;NIETO GIMENEZ PEDRO PABLO;MARTINEZSANCHEZ JOSE AGUSTIN;GONZALEZ LOPEZ JULIAN ANTONIO;NIETO GIMENEZ MARIA ASCENSION. Presidente: NIETOGIMENEZ FERNANDO PEDRO. Secretario: NIETO GIMENEZ PEDRO PABLO. Con.Delegado: NIETO GIMENEZ FERNANDOPEDRO. Datos registrales. T 975, L 739, F 22, S 8, H AB 12628, I/A 24 (24.07.19).
13 de Diciembre de 2018Reelecciones. Auditor: MILLA MARTINEZ Y ASOCIADOS AUDITORES SOCIEDAD LIMI. Datos registrales. T 975, L 739, F 22, S8, H AB 12628, I/A 23 ( 5.12.18).
12 de Septiembre de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 30.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 285.000,00 Euros. Datos registrales. T 958, L 722,F 200, S 8, H AB 12628, I/A 22 ( 5.09.16).
18 de Noviembre de 2015Nombramientos. Auditor: MILLA MARTINEZ Y ASOCIADOS AUDITORES SOCIEDAD LIMI. Datos registrales. T 958, L 722, F 200,S 8, H AB 12628, I/A 21 ( 9.11.15).
31 de Julio de 2015Reelecciones. Consejero: NIETO GIMENEZ FERNANDO PEDRO. Presidente: NIETO GIMENEZ FERNANDO PEDRO. Consejero:NIETO GIMENEZ PEDRO PABLO. Secretario: NIETO GIMENEZ PEDRO PABLO. Consejero: MARTINEZ SANCHEZ JOSEAGUSTIN;GONZALEZ LOPEZ JULIAN ANTONIO;NIETO GIMENEZ MARIA ASCENSION. Con.Delegado: NIETO GIMENEZFERNANDO PEDRO. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 7 bis.- Conflicto de Inter茅s.- El socio no podr谩 ejercitar el derecho devoto correspondiente a sus acciones cuando se trate de adoptar un acuerdo que tenga por objeto: a) autorizarle a transmitir accionessujetas a una restricci贸n legal o estatutarias, b) excluirle de la Sociedad. Las H.- Instrucciones al 贸rgano de administraci贸n.-En ning煤ncaso la Junta podr谩 impartir instrucciones al 贸rgano de administraci贸n ni someter a su autorizaci贸n asuntos de gesti贸n ARTICULO 9潞.-JUNTAS GENERALES. ... B.- Clases: Las juntas generales podr谩n ser Ordinarias o Extraordinarias. Es ordinaria ARTICULO 11 bis.-Facultades indelegables.- El Consejo de Administraci贸n no podr谩 delegar en ning煤n caso las siguientes facultades: a) La supervisi贸ndel efectivo funcionamiento de las comisiones que hubiera constituido y de la actuaci贸n de los 贸rganos delegados y de los directivosque hubiera E.- Organizaci贸n y funcionamiento.- El Consejo de Administraci贸n deber谩 reunirse, al menos, una vez al trimestre. Datosregistrales. T 919, L 683, F 53, S 8, H AB 12628, I/A 20 (24.07.15).
05 de Mayo de 2014Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 105.000,00 Euros. Desembolsado: 105.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 315.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 315.000,00 Euros. Datos registrales. T 919, L 683, F 53, S 8, H AB 12628, I/A 19 (24.04.14).
08 de Agosto de 2012Nombramientos. Auditor: ALTAIR CONSULTORES DE NEGOCIO SOCIEDAD LIMITADA PR. Datos registrales. T 919, L 683, F53, S 8, H AB 12628, I/A 18 (30.07.12).
30 de Julio de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: AVENDA脩O MONTOYA ANDRES. Revocaciones. Apoderado: AVENDA脩O MONTOYA ANDRES.Datos registrales. T 919, L 683, F 53, S 8, H AB 12628, I/A 17 (19.07.12).
22 de Junio de 2012Modificaciones estatutarias. ARTICULO 9潞.- JUNTAS GENERALES. ... B.- Clases: Las juntasgenerales podr谩n ser Ordinarias oExtraordinarias. Es ordinaria la que debe reunirse, necesariamente, dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para censurarla gesti贸nsocial, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio. Datos registrales. T 897, L 661, F 23, S 8, H AB 12628, I/A 16(13.06.12).
21 de Junio de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: NU脩EZ TENDERO JUAN ASENSIO. Reelecciones. Consejero: NIETO GIMENEZ FERNANDOPEDRO. Presidente: NIETO GIMENEZ FERNANDO PEDRO. Consejero: NIETO GIMENEZ PEDRO PABLO. Secretario: NIETOGIMENEZ PEDRO PABLO. Consejero: MARTINEZ SANCHEZ JOSE AGUSTIN;GONZALEZ LOPEZ JULIAN ANTONIO;NIETOGIMENEZ MARIA ASCENSION. Con.Delegado: NIETO GIMENEZ FERNANDO PEDRO. Consejero: AVENDA脩O MONTOYAANDRES. Datos registrales. T 897, L 661, F 23, S 8, H AB 12628, I/A 15 (10.06.11).
18 de Octubre de 2010Revocaciones. Apo.Sol.: NU脩EZ TENDERO JUAN ASENSIO. Datos registrales. T 897, L 661, F 23, S 8, H AB 12628, I/A 14 (6.10.10).
28 de Junio de 2010Nombramientos. Apoderado: AVENDA脩O MONTOYA ANDRES. Datos registrales. T 839, L 603, F 153, S 8, H AB 12628, I/A 13(17.06.10).
05 de Mayo de 2010Revocaciones. Apo.Sol.: NU脩EZ TENDERO JUAN ASENSIO. Datos registrales. T 839, L 603, F 153, S 8, H AB 12628, I/A 12(26.04.10).
13 de Noviembre de 2009Nombramientos. Auditor: MILLA MARTINEZ Y ASOCIADOS AUDITORES SOCIEDAD LIMI. Datos registrales. T 839, L 603, F 153,S 8, H AB 12628, I/A 11 ( 4.11.09).