Actos BORME de Acierta Product & Position Sa
23 de Agosto de 2022Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: KALA STUDIO SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 8086, L 5379, F 173, S8, H V 103103, I/A 16 (16.08.22).
13 de Junio de 2022Nombramientos. Apoderado: URQUIOLA REYES DANESSA VICTORIA. Datos registrales. T 8086, L 5379, F 172, S 8, H V103103, I/A 15 ( 3.06.22).
07 de Julio de 2021Reelecciones. Consejero: FERNANDEZ PONS JACOBO JOSE;ARNAU VAZQUEZ BRUNO ENRIQUE;GUILLEN GORBETOMAS;COMIN CLAVIJO MARIO. Presidente: GUILLEN GORBE TOMAS. Secretario: FERNANDEZ PONS JACOBO JOSE.Con.Delegado: ARNAU VAZQUEZ BRUNO ENRIQUE. Datos registrales. T 8086, L 5379, F 172, S 8, H V 103103, I/A 13 (30.06.21).
25 de Septiembre de 2018Cambio de domicilio social. C/ CIUDAD DE SEVILLA 42 (PATERNA). Datos registrales. T 8086, L 5379, F 172, S 8, H V 103103,I/A 12 (18.09.18).
02 de Julio de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: COMIN CLAVIJO MARIO;ARNAU VAZQUEZ BRUNO ENRIQUE;FERNANDEZ PONS JACOBOJOSE. Con.Delegado: ARNAU VAZQUEZ BRUNO ENRIQUE. Secretario: FERNANDEZ PONS JACOBO JOSE. Consejero: GUILLENGORBE TOMAS. Presidente: GUILLEN GORBE TOMAS. Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ PONS JACOBO JOSE;ARNAUVAZQUEZ BRUNO ENRIQUE;GUILLEN GORBE TOMAS;COMIN CLAVIJO MARIO. Presidente: GUILLEN GORBE TOMAS.Secretario: FERNANDEZ PONS JACOBO JOSE. Con.Delegado: ARNAU VAZQUEZ BRUNO ENRIQUE. Datos registrales. T 8086, L5379, F 171, S 8, H V 103103, I/A 11 (25.06.15).
21 de Enero de 2013Nombramientos. Consejero: COMIN CLAVIJO MARIO. Datos registrales. T 8086, L 5379, F 171, S 8, H V 103103, I/A 10(14.01.13).
20 de Noviembre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ CLAR LUCAS. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 172.344,00 Euros. Desembolsado:172.344,00 Euros. Resultante Suscrito: 243.044,00 Euros. Resultante Desembolsado: 243.044,00 Euros. Cambio de domiciliosocial. C/ BORRULL 26 BAJO (VALENCIA). Datos registrales. T 8086, L 5379, F 170, S 8, H V 103103, I/A 9 ( 9.11.12).
05 de Noviembre de 2012Nombramientos. Auditor: EUDITA CJC AUDITORES SLP. Datos registrales. T 8086, L 5379, F 170, S 8, H V 103103, I/A 8(24.10.12).
21 de Mayo de 2010Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 7.480,00 Euros. Desembolsado: 7.480,00 Euros. Resultante Suscrito: 70.700,00 Euros. ResultanteDesembolsado: 70.700,00 Euros. Datos registrales. T 8086, L 5379, F 169, S 8, H V 103103, I/A 7 (12.05.10).
22 de Abril de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: GUILLEN GORBE TOMAS;FERNANDEZ PONS JACOBO;MARTINEZ CLAR LUCAS;ARNAUVAZQUEZ BRUNO. Presidente: GUILLEN GORBE TOMAS. Secretario: FERNANDEZ PONS JACOBO. Con.Delegado: ARNAUVAZQUEZ BRUNO. Nombramientos. Consejero: ARNAU VAZQUEZ BRUNO ENRIQUE;FERNANDEZ PONS JACOBOJOSE;GUILLEN GORBE TOMAS;MARTINEZ CLAR LUCAS. Presidente: GUILLEN GORBE TOMAS. Secretario: FERNANDEZ PONSJACOBO JOSE. Con.Delegado: ARNAU VAZQUEZ BRUNO ENRIQUE. Datos registrales. T 8086, L 5379, F 169, S 8, H V 103103,I/A 6 (13.04.10).
20 de Febrero de 2009Nombramientos. Apoderado: ARNAU VAZQUEZ BRUNO ENRIQUE. Datos registrales. T 8086, L 5379, F 169, S 8, H V 103103, I/A5 (11.02.09).