Actos BORME de Acresol Sociedad Anonima
03 de Mayo de 2023Nombramientos. Apoderado: MORENO GARCIA NURIA. Datos registrales. T 3849 , F 166, S 8, H A 22156, I/A 31 (21.04.23).
22 de Julio de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: PIQUERES LOPEZ DOLORES. Secretario: PIQUERES LOPEZ DOLORES. Nombramientos.Consejero: COVES SELVA GASPAR. Secretario: COVES SELVA GASPAR. Datos registrales. T 3849 , F 166, S 8, H A 22156, I/A30 (18.07.22).
03 de Noviembre de 2021Ceses/Dimisiones. Apoderado: COVES SELVA GASPAR. Datos registrales. T 3849 , F 166, S 8, H A 22156, I/A 29 (25.10.21).
12 de Agosto de 2021Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: COVES SELVA SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: COVES SELVAGASPAR. Secretario: COVES SELVA GASPAR. Nombramientos. Consejero: PIQUERES LOPEZ DOLORES. Secretario:PIQUERES LOPEZ DOLORES. Datos registrales. T 3849 , F 165, S 8, H A 22156, I/A 28 ( 4.08.21).
24 de Agosto de 2020Modificación de poderes. Apo.Sol.: ADSUAR LLEDO JUAN RAMON. Datos registrales. T 3476 , F 181, S 8, H A 22156, I/A 27(13.08.20).
18 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: COVES COVES ASUNCION. Datos registrales. T 3476 , F 181, S 8, H A 22156, I/A 26 ( 6.08.20).
05 de Diciembre de 2019Nombramientos. Apoderado: SALA DOLO SERGIO. Datos registrales. T 3476 , F 36, S 8, H A 22156, I/A 25 (27.11.19).
10 de Abril de 2019Nombramientos. Apoderado: RUBI MONTES JAIME. Datos registrales. T 3476 , F 20, S 8, H A 22156, I/A 24 ( 2.04.19).
30 de Enero de 2019Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: COVES SELVA JOSE MARIA. Nombramientos. Con.Delegado: COVES SELVA JOSE MARIA.Reelecciones. Consejero: COVES SELVA JOSE MARIA;COVES SELVA GASPAR. Secretario: COVES SELVA GASPAR. Consejero:COVES SELVA VICENTE. Presidente: COVES SELVA VICENTE. Datos registrales. T 3476 , F 20, S 8, H A 22156, I/A 23 (22.01.19).
22 de Junio de 2018Ceses/Dimisiones. Apo.Sol.: DURA BROTONS MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 3476 , F 20, S 8, H A 22156, I/A 22(14.06.18).
27 de Junio de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: DURA BROTONS MIGUEL ANGEL;COVES COVES VICENTE;COVES PIQUERES GASPAR;ADSUARLLEDO JUAN RAMON;RUIZ SAEZ ANGEL;COVES COVES ASUNCION;CARRATALA ASENSI ASTRID MARIA. Datos registrales. T3476 , F 18, S 8, H A 22156, I/A 21 (19.06.17).
27 de Febrero de 2013Ceses/Dimisiones. Presidente: COVES SELVA JOSE MARIA. Con.Delegado: COVES SELVA VICENTE. Nombramientos.Apoderado: COVES SELVA VICENTE. Presidente: COVES SELVA VICENTE. Con.Delegado: COVES SELVA JOSE MARIA.Reelecciones. Consejero: COVES SELVA JOSE MARIA;COVES SELVA GASPAR. Secretario: COVES SELVA GASPAR. Consejero:COVES SELVA VICENTE. Datos registrales. T 3476 , F 17, S 8, H A 22156, I/A 20 (19.02.13).
15 de Noviembre de 2011Reelecciones. Auditor: APLEM CONSULTING SLP. Datos registrales. T 3476 , F 17, S 8, H A 22156, I/A 19 ( 3.11.11).
20 de Septiembre de 2010Modificaciones estatutarias. Artículo 29º.- Retribución. Artículo 31º.- El Consejo. Otros conceptos: Artículo 27º.- Duración de loscargos. Datos registrales. T 1614 , F 112, S 8, H A 22156, I/A 18 ( 9.09.10).