Buscador CIF Logo

Actos BORME Acteon Siglo Xxi Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Acteon Siglo Xxi Sa

Actos BORME Acteon Siglo Xxi Sa - A97043772

Tenemos registrados 37 Actos BORME del Registro Mercantil de Valencia para Acteon Siglo Xxi Sa con CIF A97043772

馃敊 Perfil de Acteon Siglo Xxi Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Valencia

Actos BORME de Acteon Siglo Xxi Sa

14 de Junio de 2021
Cambio de domicilio social. C/ VALL D'AIORA 3 (VALENCIA). Datos registrales. T 10950, L 8228, F 150, S 8, H V 75525, I/A 30 (7.06.21).

25 de Noviembre de 2019
Otros conceptos: DECLARACION DE CAMBIO DE ACCIONISTA UNICO, SIENDO EL NUEVO ACCIONISTA UNICO: BRETALPROPERTIES S.L. Datos registrales. T 46941 , F 12, S 8, H B 494139, I/A 43 (18.11.19).

Cambio de domicilio social. CL MALLORCA Num.351 (BARCELONA). Datos registrales. T 46941 , F 12, S 8, H B 494139, I/A 44(18.11.19).

07 de Noviembre de 2019
Revocaciones. ADM.UNICO: HI PARTNERS HOLDCO VALUE ADDED SA. REPR.143 RRM: HERNANDEZ PUERTOLAS PAVIAALEJANDRO. Nombramientos. ADM.UNICO: LOPEZ SEIJAS AMANCIO. Datos registrales. T 46941 , F 12, S 8, H B 494139, I/A41 (28.10.19).

Revocaciones. APOD.MANCOMU: ACIN FERRER JUAN RAMON;PEREZ MAYORGA MANUEL;PAMBLANCO ARAZOCARLOS;REGAS BRUGAROLA RAMON JUAN JOSE. APODERAD.SOL: INVERSIONES NARON 2003 SL. APOD.SOL/MAN:CARRASCOSA CENDAN SERGIO;RIUS PALAU MARIA MONTSERRAT;KLEIN SANTAMARIA FELIPE;ANDREA PATRICIASCHRODER;PEREZ ABAD TORNOS PEDRO;CULUBRET CANAL ILONA;GOMEZ DE CADI脩ANOS MAURE CARMEN.APOD.MANCOMU: PE脩A GARRIGA JOSEP ORIOL;GONZAGA RULLAN JANER LUIS;HORMIGO MU脩OZ JOAQUIN;PICASASMARATS LUIS;GONZALEZ FUSTER JOAN JOSEP;LLOBET AZNAR ORIOL;SOLANO MOLINS JOAQUIM;SIMON DAVID AUSTINDAVIES;PANAYOT KOSTADINOV VASILEV;JEAN FRANCOIS PASCAL EMMANUEL BOSSY;SOLVEIG DIANAHOFFMANN;CABALLERO MARTINEZ JOSE GABRIEL;PIERRE YVES LEFEBVRE;ELENA PIAIA;PAGES SERRA LAIA;MARTAROCH DOROTA. Datos registrales. T 46941 , F 12, S 8, H B 494139, I/A 42 (28.10.19).

07 de Agosto de 2019
Modificaciones estatutarias. ELIMINACION DEL ARTICULO 18 BIS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 46941, F 11, S 8, H B 494139, I/A 40 (30.07.19).

08 de Julio de 2019
Revocaciones. APOD.MANCOMU: CABALLERO MARTINEZ JOSE GABRIEL;PIERRE YVES LEFEBVRE. APOD.SOL/MAN:CARRASCOSA CENDAN SERGIO;FISAS PUJOL SOLIANO SANTIAGO;RIUS PALAU MARIA MONTSERRAT;ANDREA PATRICIASCHRODER;PEREZ ABAD TORNOS PEDRO;CULUBRET CANAL ILONA. APOD.MANCOMU: KLEIN SANTAMARIA FELIPE;PICASASMARATS LUIS;GONZALEZ FUSTER JOAN JOSEP;LLOBET AZNAR ORIOL;SIMON DAVID AUSTIN DAVIES;PANAYOTKOSTADINOV VASILEV;NOVOA BERREDO DANIEL ARMANDO;JEAN FRANCOIS PASCAL EMMANUEL BOSSY;SOLVEIG DIANA

03 de Julio de 2019
Fe de erratas: En el BORME no.167/2018 y con referencia 355992 RECTIFICADO EL ERROR EN EL ORDEN DE LOS APELLIDOSDEL APODERADO NOMBRADO JOSE GABRIEL MARTINEZ CABALLERO, SIENDO SU NOMBRE CORRECTO JOSE GABRIELCABALLERO MARTINEZ. Datos registrales. T 45634 , F 212, S 8, H B 494139, I/A 38 (22.08.18).

30 de Agosto de 2018
Revocaciones. APODERAD.SOL: LOPEZ RODRIGUEZ SEBASTIAN. APOD.SOL/MAN: CARRASCOSA CENDAN SERGIO;FISAS

06 de Febrero de 2018
Otros conceptos: EMISION DEL TITULO MULTIPLE REPRESENTATIVO DE LAS 13.130.257 ACCIONES NOMINATIVASREPRESENTATIVAS DE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD. Datos registrales. T 45634 , F 205, S 8, H B494139, I/A 28 N (30.01.18).

Modificaciones estatutarias. MODIFICACION ARTICULO 7 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y ADICION ARTICULOS 9 BIS Y 18BIS A LOS MISMOS. Datos registrales. T 45634 , F 210, S 8, H B 494139, I/A 37 (30.01.18).

18 de Agosto de 2017
Revocaciones. APODERAD.SOL: ABBA HOTELES SA. Datos registrales. T 45634 , F 210, S 8, H B 494139, I/A 36 ( 8.08.17).

27 de Junio de 2017
Nombramientos. APODERAD.SOL: INVERSIONES NARON 2003 SL. Datos registrales. T 45634 , F 209, S 8, H B 494139, I/A 35(20.06.17).

25 de Abril de 2017
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: CARRASCOSA CENDAN SERGIO;FISAS PUJOL SOLIANO SANTIAGO;LOPEZ RODRIGUEZSEBASTIAN. Datos registrales. T 45634 , F 206, S 8, H B 494139, I/A 33 (12.04.17).

Nombramientos. APOD.SOL/MAN: CARRASCOSA CENDAN SERGIO;FISAS PUJOL SOLIANO SANTIAGO;LOPEZ RODRIGUEZSEBASTIAN. Datos registrales. T 45634 , F 208, S 8, H B 494139, I/A 34 (12.04.17).

23 de Marzo de 2017
Revocaciones. APODERAD.SOL: ACIN FERRER JUAN RAMON. Datos registrales. T 45634 , F 206, S 8, H B 494139, I/A 32(15.03.17).

07 de Marzo de 2017
Modificaciones estatutarias. ART. 28 : FIJACION DEL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, INICIANDOSE EL DIA 1 DEENERO Y FINALIZANDO EL 31 DE DICIEMBRE DE CADA A脩O. Datos registrales. T 45634 , F 206, S 8, H B 494139, I/A 31(27.02.17).

13 de Diciembre de 2016
Otros conceptos: DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: HI PARTNERS HOLDCO VALUE ADDED SL. Datosregistrales. T 45634 , F 206, S 8, H B 494139, I/A 30 ( 1.12.16).

24 de Noviembre de 2016
Cambio de domicilio social. AV DE SARRIA, NUM. 102-106 P.11 (BARCELONA). Datos registrales. T 45634 , F 205, S 8, H B494139, I/A 29 (15.11.16).

25 de Octubre de 2016
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 661.200,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:13.130.257,00 Euros. Desembolsado: 13.130.257,00 Euros. Resultante Suscrito: 13.130.257,00 Euros. Resultante Desembolsado:13.130.257,00 Euros. Datos registrales. T 7062, L 4365, F 42, S 8, H V 75525, I/A 28 (18.10.16).

19 de Octubre de 2016
Nombramientos. Apo.Manc.: ACIN FERRER JUAN RAMON;PEREZ MAYORGA MANUEL;PAMBLANCO ARAZO CARLOS;REGASBRUGAROLA RAMON JUAN JOSE. Datos registrales. T 7062, L 4365, F 41, S 8, H V 75525, I/A 27 (11.10.16).

04 de Octubre de 2016
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ RODRIGUEZ SEBASTIAN. Datos registrales. T 7062, L 4365, F 39, S 8, H V 75525, I/A 21(27.09.16).

Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/6. Datos registrales. T 7062, L 4365, F 40, S 8, H V 75525, I/A 22(27.09.16).

Nombramientos. Apoderado: ACIN FERRER JUAN RAMON. Datos registrales. T 7062, L 4365, F 40, S 8, H V 75525, I/A 23(27.09.16).

Revocaciones. Apoderado: ACIN FERRER JUAN RAMON;PAMBLANCO ARAZO CARLOS. Datos registrales. T 7062, L 4365, F40, S 8, H V 75525, I/A 24 (27.09.16).

Nombramientos. Apoderado: ABBA HOTELES SA. Datos registrales. T 7062, L 4365, F 40, S 8, H V 75525, I/A 25 (27.09.16).

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MI脩ON ORTIZ JERONIMO;IRACULIS MIGUEL ANDRES. Nombramientos. Adm. Unico: HIPARTNERS HOLDCO VALUE ADDED SL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios aAdministrador 煤nico. Modificados los art铆culos 10, 17 y 18 de los Estatutos Sociales de conformidad con el cambio del 贸rgano deadministraci贸n. Datos registrales. T 7062, L 4365, F 41, S 8, H V 75525, I/A 26 (27.09.16).

26 de Junio de 2014
Revocaciones. Apoderado: PEREZ MAYORGA MANUEL. Datos registrales. T 7062, L 4365, F 38, S 8, H V 75525, I/A 19(19.06.14).

30 de Mayo de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: IRACULIS MIGUEL ANDRES;MI脩ON SUSO ROBERTO;MI脩ON ORTIZ JERONIMO;IRACULISGARMENDIA ANA. Cons.Del.Sol: IRACULIS MIGUEL ANDRES;MI脩ON ORTIZ JERONIMO. Presidente: IRACULIS MIGUELANDRES. Secretario: MI脩ON ORTIZ JERONIMO. Nombramientos. Adm. Solid.: MI脩ON ORTIZ JERONIMO;IRACULIS MIGUELANDRES. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradoressolidarios. Articulo 10 de estatutos modificado. Articulo 15 estatutos modificado. Articulo 17 estatutos modificado. Articulo 19 estatutosmodificado. Modificado el articulo 25 estatutos sociales. Articulo 27 estatutos modificado. Otros conceptos: Se acuerda que lasecci贸n segunda del t铆tulo III pase a llamarse "del organo de administraci贸n" y eliminar los art铆culos 20, 21, 22, 23, 24 y 26 de losEstatutos sociales. Datos registrales. T 7062, L 4365, F 38, S 8, H V 75525, I/A 17 (23.05.14).

17 de Marzo de 2014
Nombramientos. Apoderado: PAMBLANCO ARAZO CARLOS. Datos registrales. T 6800, L 4104, F 127, S 8, H V 75525, I/A 16(10.03.14).

09 de Mayo de 2013
Nombramientos. Apoderado: PEREZ MAYORGA MANUEL. Datos registrales. T 6800, L 4104, F 127, S 8, H V 75525, I/A 15 (2.05.13).

11 de Octubre de 2012
Nombramientos. Apoderado: ACIN FERRER JUAN RAMON. Datos registrales. T 6800, L 4104, F 126, S 8, H V 75525, I/A 13 (2.10.12).

Revocaciones. Apoderado: PEREZ MAYORGA MANUEL. Datos registrales. T 6800, L 4104, F 127, S 8, H V 75525, I/A 14 (2.10.12).

14 de Agosto de 2012
Revocaciones. Apo.D.Gral.: ALCODORI FUSTER MANUEL. Datos registrales. T 6800, L 4104, F 125, S 8, H V 75525, I/A 11 (3.08.12).

Nombramientos. Apoderado: PEREZ MAYORGA MANUEL. Datos registrales. T 6800, L 4104, F 126, S 8, H V 75525, I/A 12 (3.08.12).

04 de Agosto de 2009
Otros conceptos: Proceder a declarar la nulidad de los titulos multiples representativos de la acciones y su correspondiente falta devalor y proceder a la emisi贸n e impresi贸n de nuevos t铆tulos m煤ltiples. Datos registrales. T 6800, L 4104, F 123, S 8, H V 75525, I/A 8(24.07.09).

09 de Junio de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANSINENEA URBISTONDO GABRIEL;UNCETA URBISTONDO JOSE IGNACIO. Otrosconceptos: Como consecuencia de determinados ceses el Consejo de Administraci贸n fijada en CUATRO miembros. Datosregistrales. T 6800, L 4104, F 125, S 8, H V 75525, I/A 10 (29.05.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n