Actos BORME de Activos Singulares Hoteleros Sl
26 de Abril de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: DE SANTIAGO BONAFE ABIUD. Datos registrales. T 39882 , F 4, S 8, H M 602919, I/A 16 (19.04.21).
26 de Noviembre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: BERROZPE SANCHEZ JOSE CARLOS. Nombramientos. Consejero: MINNAERTMATHIEU;PERUYERO BLANCO RODRIGO;MARTINS CARLOS. Vicepresid.: MINNAERT MATHIEU. Vicesecret.: PERUYEROBLANCO RODRIGO. Datos registrales. T 33493 , F 14, S 8, H M 602919, I/A 13 (19.11.19).
Revocaciones. Apoderado: PEREZ RAMOS JOSE;ORTIZ BLANCO JOSE;PEREZ RAMOS JOSE;ORTIZ BLANCOJOSE;BERROZPE SANCHEZ CARLOS JOSE. Apo.Man.Soli: AMIGO GOMEZ LUIS JOSE. Apo.Manc.: ORTIZ BLANCO JOSE.Apoderado: DE SANTIAGO BONAFE ABIUD;BERROZPE SANCHEZ CARLOS JOSE. Datos registrales. T 39882 , F 1, S 8, H M602919, I/A 14 (19.11.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINS CARLOS;DE SANTIAGO BONAFE ABIUD;FERNANDEZ-MARCOTE CASTRILLEJO MANUEL-CESAR. Datos registrales. T 39882 , F 1, S 8, H M 602919, I/A 15 (19.11.19).
12 de Junio de 2019Nombramientos. Apoderado: DE SANTIAGO BONAFE ABIUD. Datos registrales. T 33493 , F 11, S 8, H M 602919, I/A 11 (5.06.19).
Nombramientos. Apoderado: BERROZPE SANCHEZ CARLOS JOSE. Datos registrales. T 33493 , F 12, S 8, H M 602919, I/A 12 (5.06.19).
11 de Junio de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: AGH NORTE GNAMMA INTEGRAL SPRING SL. Representan: GOMEZ-TEMBLEQUE ROMILLOANTONIO. Nombramientos. Consejero: GOMEZ-TEMBLEQUE ROMILLO ANTONIO;MABRY PATRICK THOMAS;BERROZPESANCHEZ JOSE CARLOS. Presidente: MABRY PATRICK THOMAS. Secretario: GOMEZ-TEMBLEQUE ROMILLO ANTONIO.Modificaciones estatutarias. Creaci贸n de un art铆culo el 21 bis. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 33493 , F 10, S 8, H M 602919, I/A 10 ( 4.06.19).
07 de Marzo de 2019Cambio de domicilio social. C/ ALCALA 54 - 2潞 IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 33493 , F 10, S 8, H M 602919, I/A 9(28.02.19).
05 de Marzo de 2019Ceses/Dimisiones. Representan: PEREZ RAMOS JOSE. Nombramientos. Representan: GOMEZ-TEMBLEQUE ROMILLOANTONIO. Datos registrales. T 33493 , F 10, S 8, H M 602919, I/A 8 (26.02.19).
02 de Noviembre de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GRUPO AVINTIA SL. Representan: MARTIN JIMENEZ ANTONIO. Nombramientos. Adm. Unico:AVINTIA GRUPO HOTELERO SL. Representan: PEREZ RAMOS JOSE. Datos registrales. T 33493 , F 9, S 8, H M 602919, I/A 7
14 de Julio de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: AMIGO GOMEZ LUIS JOSE. Apo.Manc.: ORTIZ BLANCO JOSE. Datos registrales. T 33493 , F 9,S 8, H M 602919, I/A 6 ( 6.07.16).
10 de Junio de 2016Revocaciones. Apoderado: GARCIA ACEVEDO ALONSO JESUS. Datos registrales. T 33493 , F 9, S 8, H M 602919, I/A 5 (2.06.16).
08 de Junio de 2016Nombramientos. Apoderado: PEREZ RAMOS JOSE;ORTIZ BLANCO JOSE;BERROZPE SANCHEZ CARLOS JOSE. Datosregistrales. T 33493 , F 8, S 8, H M 602919, I/A 4 (30.05.16).
21 de Abril de 2016Cambio de domicilio social. C/ EMISORA 20 (POZUELO DE ALARCON). Datos registrales. T 33493 , F 8, S 8, H M 602919, I/A 3(13.04.16).
27 de Mayo de 2015Nombramientos. Apoderado: GARCIA ACEVEDO ALONSO JESUS;PEREZ RAMOS JOSE;ORTIZ BLANCO JOSE. Datosregistrales. T 33493 , F 5, S 8, H M 602919, I/A 2 (19.05.15).
26 de Mayo de 2015Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 26.03.15. Objeto social: La tenencia, adquisici贸n, posesi贸n, disfrute, administraci贸n yrentabilizaci贸n, construcci贸n, compra y venta, administraci贸n y explotaci贸n de establecimientos de hosteler铆a (como cafeter铆as, bares,restaurantes y similares) y tur铆sticos (como hoteles, complejos de "aparthoteles", urbanizaciones... Domicilio: C/ CARPINTEROS 10, 2&PLANTA (VILLAVICIOSA DE ODON). Capital: 15.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GRUPO AVINTIASL. Nombramientos. Adm. Unico: GRUPO AVINTIA SL. Representan: MARTIN JIMENEZ ANTONIO. Datos registrales. T 33493 , F1, S 8, H M 602919, I/A 1 (19.05.15).