Buscador CIF Logo

Actos BORME Activos Singulares Hoteleros Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Activos Singulares Hoteleros Sl

Actos BORME Activos Singulares Hoteleros Sl - B87253837

Tenemos registrados 16 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Activos Singulares Hoteleros Sl con CIF B87253837

馃敊 Perfil de Activos Singulares Hoteleros Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Activos Singulares Hoteleros Sl

26 de Abril de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: DE SANTIAGO BONAFE ABIUD. Datos registrales. T 39882 , F 4, S 8, H M 602919, I/A 16 (19.04.21).

26 de Noviembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: BERROZPE SANCHEZ JOSE CARLOS. Nombramientos. Consejero: MINNAERTMATHIEU;PERUYERO BLANCO RODRIGO;MARTINS CARLOS. Vicepresid.: MINNAERT MATHIEU. Vicesecret.: PERUYEROBLANCO RODRIGO. Datos registrales. T 33493 , F 14, S 8, H M 602919, I/A 13 (19.11.19).

Revocaciones. Apoderado: PEREZ RAMOS JOSE;ORTIZ BLANCO JOSE;PEREZ RAMOS JOSE;ORTIZ BLANCOJOSE;BERROZPE SANCHEZ CARLOS JOSE. Apo.Man.Soli: AMIGO GOMEZ LUIS JOSE. Apo.Manc.: ORTIZ BLANCO JOSE.Apoderado: DE SANTIAGO BONAFE ABIUD;BERROZPE SANCHEZ CARLOS JOSE. Datos registrales. T 39882 , F 1, S 8, H M602919, I/A 14 (19.11.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINS CARLOS;DE SANTIAGO BONAFE ABIUD;FERNANDEZ-MARCOTE CASTRILLEJO MANUEL-CESAR. Datos registrales. T 39882 , F 1, S 8, H M 602919, I/A 15 (19.11.19).

12 de Junio de 2019
Nombramientos. Apoderado: DE SANTIAGO BONAFE ABIUD. Datos registrales. T 33493 , F 11, S 8, H M 602919, I/A 11 (5.06.19).

Nombramientos. Apoderado: BERROZPE SANCHEZ CARLOS JOSE. Datos registrales. T 33493 , F 12, S 8, H M 602919, I/A 12 (5.06.19).

11 de Junio de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: AGH NORTE GNAMMA INTEGRAL SPRING SL. Representan: GOMEZ-TEMBLEQUE ROMILLOANTONIO. Nombramientos. Consejero: GOMEZ-TEMBLEQUE ROMILLO ANTONIO;MABRY PATRICK THOMAS;BERROZPESANCHEZ JOSE CARLOS. Presidente: MABRY PATRICK THOMAS. Secretario: GOMEZ-TEMBLEQUE ROMILLO ANTONIO.Modificaciones estatutarias. Creaci贸n de un art铆culo el 21 bis. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 33493 , F 10, S 8, H M 602919, I/A 10 ( 4.06.19).

07 de Marzo de 2019
Cambio de domicilio social. C/ ALCALA 54 - 2潞 IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 33493 , F 10, S 8, H M 602919, I/A 9(28.02.19).

05 de Marzo de 2019
Ceses/Dimisiones. Representan: PEREZ RAMOS JOSE. Nombramientos. Representan: GOMEZ-TEMBLEQUE ROMILLOANTONIO. Datos registrales. T 33493 , F 10, S 8, H M 602919, I/A 8 (26.02.19).

02 de Noviembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GRUPO AVINTIA SL. Representan: MARTIN JIMENEZ ANTONIO. Nombramientos. Adm. Unico:AVINTIA GRUPO HOTELERO SL. Representan: PEREZ RAMOS JOSE. Datos registrales. T 33493 , F 9, S 8, H M 602919, I/A 7

14 de Julio de 2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: AMIGO GOMEZ LUIS JOSE. Apo.Manc.: ORTIZ BLANCO JOSE. Datos registrales. T 33493 , F 9,S 8, H M 602919, I/A 6 ( 6.07.16).

10 de Junio de 2016
Revocaciones. Apoderado: GARCIA ACEVEDO ALONSO JESUS. Datos registrales. T 33493 , F 9, S 8, H M 602919, I/A 5 (2.06.16).

08 de Junio de 2016
Nombramientos. Apoderado: PEREZ RAMOS JOSE;ORTIZ BLANCO JOSE;BERROZPE SANCHEZ CARLOS JOSE. Datosregistrales. T 33493 , F 8, S 8, H M 602919, I/A 4 (30.05.16).

21 de Abril de 2016
Cambio de domicilio social. C/ EMISORA 20 (POZUELO DE ALARCON). Datos registrales. T 33493 , F 8, S 8, H M 602919, I/A 3(13.04.16).

27 de Mayo de 2015
Nombramientos. Apoderado: GARCIA ACEVEDO ALONSO JESUS;PEREZ RAMOS JOSE;ORTIZ BLANCO JOSE. Datosregistrales. T 33493 , F 5, S 8, H M 602919, I/A 2 (19.05.15).

26 de Mayo de 2015
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 26.03.15. Objeto social: La tenencia, adquisici贸n, posesi贸n, disfrute, administraci贸n yrentabilizaci贸n, construcci贸n, compra y venta, administraci贸n y explotaci贸n de establecimientos de hosteler铆a (como cafeter铆as, bares,restaurantes y similares) y tur铆sticos (como hoteles, complejos de "aparthoteles", urbanizaciones... Domicilio: C/ CARPINTEROS 10, 2&PLANTA (VILLAVICIOSA DE ODON). Capital: 15.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GRUPO AVINTIASL. Nombramientos. Adm. Unico: GRUPO AVINTIA SL. Representan: MARTIN JIMENEZ ANTONIO. Datos registrales. T 33493 , F1, S 8, H M 602919, I/A 1 (19.05.15).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n