Actos BORME de Adabar Inversiones Sicav Sa
17 de Agosto de 2023Otros conceptos: En certificado notarial se hace constar que: La fusión transfronteriza por absorción de la Sdad. española "ADABARINVERSIONES SICAV SA" (la Sdad. Absorbida) por el compartimento "PROTEA UCITS II - NAO PATRIMONIO GLOBAL (elCompartimento Absorbente) de la Sdad. "PROTEA UCIT II" (la Sdad. Absorbente) se ha llevado a cabo de conformidad con lodispuesto en la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan lasdisposiciones legales, disposiciones legales reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva.Datos registrales. T 33741 , F 71, S 8, H M 298022, I/A 29-M ( 9.08.23).
07 de Marzo de 2023Otros conceptos: Con fecha 15 de febrero de 2023, ha quedado inserto en la página web corporativa de la Sociedad Gestora"www.bankinter.es", el Proyecto Común de Fusión de fecha 30 de junio de 2022 de "ADABAR INVERSIONES SICAV SA" (SociedadAbsorbida) y "PROTEA UCITS II" (Sociedad Absorbente) extendiéndose la nota a que se refiere el Artículo 32 LME. Datosregistrales. T 17370 , F 123, S 8, H M 298022, I/A 1M (28.02.23).
08 de Octubre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: LLORET MARTINEZ PILAR. Presidente: LLORET MARTINEZ PILAR. Cons.Del.Sol: LLORETMARTINEZ PILAR. Nombramientos. Consejero: JIMENEZ RUIZ NESTOR. Presidente: SERRATOSA LUJAN PABLO. Datosregistrales. T 33741 , F 71, S 8, H M 298022, I/A 29 ( 1.10.21).
12 de Agosto de 2021Reelecciones. Consejero: LLORET MARTINEZ PILAR. Presidente: LLORET MARTINEZ PILAR. Cons.Del.Sol: LLORET MARTINEZPILAR. Datos registrales. T 33741 , F 70, S 8, H M 298022, I/A 28 ( 5.08.21).
03 de Noviembre de 2020Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Consejero: GARCIA MARGAIX RICARDO. Datosregistrales. T 33741 , F 70, S 8, H M 298022, I/A 27 (26.10.20).
21 de Septiembre de 2020Ceses/Dimisiones. Secretario: SAMAYOA PEÑALVER IRENE. Ent. Gestora: MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC SA.EntidDeposit: BANCA MARCH SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL EN MADRID. Cancelaciones de oficio de nombramientos.Consejero: GARCIA MARGAIX RICARDO. Nombramientos. SecreNoConsj: MARTIN NIETO AGUSTIN. Ent. Gestora: BANKINTERGESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D. EntidDeposit: BANKINTER SOCIEDAD ANONIMA. Apoderado: BANKINTERGESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D. Modificaciones estatutarias. Modificados los artículos 1º, 3º, 9º y 13º.Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 29 (MADRID). Datos registrales. T 33741 , F 68, S 8, H M 298022, I/A26 (14.09.20).
01 de Junio de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA RODRIGUEZ EMILIO. Nombramientos. Consejero: SERRATOSA LUJAN PABLO. Datosregistrales. T 33741 , F 68, S 8, H M 298022, I/A 25 (25.05.20).
08 de Octubre de 2019Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: DAMBORENEA AGORRIA IÑIGO. Nombramientos. Secretario: SAMAYOA PEÑALVER IRENE.Datos registrales. T 33741 , F 68, S 8, H M 298022, I/A 24 ( 1.10.19).
28 de Mayo de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ ROSELLO IGNACIO. Nombramientos. Consejero: GARCIA RODRIGUEZ EMILIO. Datosregistrales. T 33741 , F 67, S 8, H M 298022, I/A 23 (21.05.19).
23 de Agosto de 2017Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 33741 , F 67, S 8, H M 298022, I/A 22 (16.08.17).
19 de Octubre de 2016Nombramientos. Cons.Del.Sol: LLORET MARTINEZ PILAR. Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Consejero: LLORETMARTINEZ PILAR;LOPEZ ROSELLO IGNACIO. Datos registrales. T 33741 , F 67, S 8, H M 298022, I/A 21 (10.10.16).
25 de Septiembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: CARRASCOSA MONTOYA ANTONIO. Nombramientos. Consejero: GARCIA MARGAIX RICARDO.Modificaciones estatutarias. modificación del artículo 5º de los estatutos.. Otros conceptos: Aumento de las cifras del capitalsocial inicial y estatutario máximo de la sociedad. De 2.404.050 euros el capital inicial y 24.040.500 euros el capital estatutario máximo,quedan fijadas en 7.000.000 euros y en 70.000.000 euros, respectivamente. Datos registrales. T 17370 , F 134, S 8, H M 298022, I/A20 (17.09.15).
12 de Agosto de 2013Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 17370 , F 134, S 8, H M 298022, I/A 19 ( 1.08.13).
03 de Junio de 2013Nombramientos. Con.Delegado: LLORET MARTINEZ PILAR. Datos registrales. T 17370 , F 133, S 8, H M 298022, I/A 18(27.05.13).
30 de Octubre de 2012Modificaciones estatutarias. 13. Funcionamiento Junta Gral.-. Datos registrales. T 17370 , F 133, S 8, H M 298022, I/A 17(19.10.12).
17 de Octubre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: DEL BARRIO ARRIBAS ANDRES;DAMBORENEA AGORRIA IÑIGO;DE VENA HEDROSA JOSEJULIO. Presidente: DEL BARRIO ARRIBAS ANDRES. Secretario: DAMBORENEA AGORRIA IÑIGO. Nombramientos.SecreNoConsj: DAMBORENEA AGORRIA IÑIGO. Consejero: LLORET MARTINEZ PILAR. Presidente: LLORET MARTINEZ PILAR.Consejero: CARRASCOSA MONTOYA ANTONIO;LOPEZ ROSELLO IGNACIO. Datos registrales. T 17370 , F 132, S 8, H M298022, I/A 16 ( 4.10.11).
13 de Abril de 2011Modificaciones estatutarias. 7. . Datos registrales. T 17370 , F 132, S 8, H M 298022, I/A 15 ( 4.04.11).
31 de Diciembre de 2010Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 17370 , F 132, S 8, H M 298022, I/A 14 (21.12.10).
05 de Octubre de 2009Reelecciones. Auditor: BGT AUDITORES SL. Datos registrales. T 17370 , F 131, S 8, H M 298022, I/A 13 (23.09.09).