Actos BORME de Adesis Netlife Sl
22 de Noviembre de 2019Extinci贸n. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la inscripci贸n 26陋 la publicaci贸n de la extinci贸n de la sociedad. Datos registrales. T35295 , F 105, S 8, H M 246035, I/A 26 (14.11.19).
21 de Noviembre de 2019Otros conceptos: Ha quedado inscrita en el Registro de Barcelona la fusi贸n por absorci贸n de la sociedad GFT IT CONSULTING SL(absorbente) y ADESIS NETLIFE SL(absorbida) y caus贸 la inscripci贸n 62陋, al folio 97 del tomo 45199 hoja B-258788. Lo que participaa efectos previstos en el art. 233.2. Datos registrales. T 35295 , F 105, S 8, H M 246035, I/A 26 (14.11.19).
01 de Octubre de 2019Otros conceptos: Nota marginal del cierre provisional de la hoja registral, por plazo de seis meses, de conformidad con lopreceptuado en el art铆culo 231 del Reglamento del Registro Mercantil. Datos registrales. T 35295 , F 105, S 8, H M 246035, I/A 25-M(24.09.19).
12 de Marzo de 2019Nombramientos. Apo.Manc.: CA脩AS CABELLO EDUARDO. Datos registrales. T 35295 , F 104, S 8, H M 246035, I/A 25 ( 5.03.19).
16 de Julio de 2018Revocaciones. Apo.Manc.: VALLEJO SUAREZ DE PUGA GUILLERMO. Datos registrales. T 35295 , F 104, S 8, H M 246035, I/A24 ( 9.07.18).
04 de Abril de 2018Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 35295 , F 104, S 8, H M 246035, I/A 23 (26.03.18).
24 de Noviembre de 2016Nombramientos. Apoderado: VICENTE RAYA SARA. Datos registrales. T 30220 , F 63, S 8, H M 246035, I/A 22 (17.11.16).
03 de Noviembre de 2016Revocaciones. Apo.Manc.: LUNA GOMEZ JESUS. Datos registrales. T 30220 , F 63, S 8, H M 246035, I/A 21 (26.10.16).
28 de Julio de 2016Modificaciones estatutarias. 25. Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 30220 , F 63, S 8, H M 246035, I/A 20(20.07.16).
02 de Febrero de 2016Nombramientos. Apo.Manc.: DE OBES VICENTE FRANCISCO JAVIER;VILLORO LACOSTA DAVID;VICENTE RAYA SARA.Apo.Sol.: VILLORO LACOSTA DAVID. Datos registrales. T 30220 , F 62, S 8, H M 246035, I/A 19 (26.01.16).
25 de Enero de 2016Cambio de domicilio social. C/ ORDU脩A, NUMERO 1 (MADRID). Datos registrales. T 30220 , F 61, S 8, H M 246035, I/A 18(15.01.16).
29 de Septiembre de 2015Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GFT IBERIA HOLDING SAU. Ceses/Dimisiones. Presidente: RUIZ DE VILLASUAREZ GONZALO. Secretario: LUNA GOMEZ JESUS. Consejero: RUIZ DE VILLA SUAREZ GONZALO;VALLEJO SUAREZ DEPUGA GUILLERMO;LUNA GOMEZ JESUS. Cons.Del.Man: RUIZ DE VILLA SUAREZ GONZALO;VALLEJO SUAREZ DE PUGAGUILLERMO;LUNA GOMEZ JESUS. Consejero: LAVIN DELGADO MANUEL. Cons.Del.Man: LAVIN DELGADO MANUEL;LUNAGOMEZ JESUS;RUIZ DE VILLA SUAREZ GONZALO;VALLEJO SUAREZ DE PUGA GUILLERMO;LAVIN DELGADO MANUEL;LUNAGOMEZ JESUS;RUIZ DE VILLA SUAREZ GONZALO;VALLEJO SUAREZ DE PUGA GUILLERMO;LAVIN DELGADO MANUEL.Nombramientos. Adm. Mancom.: ERES CAPDEVILA CARLOS;DE OBES VICENTE FRANCISCO JAVIER. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 30220 , F59, S 8, H M 246035, I/A 15 (21.09.15).
Nombramientos. Apo.Manc.: RODRIGUEZ PELAEZ GUILLERMO;DIAZ GORINA JOSEP MARIA;FIGUERES MESTRES MARIATERESA;SERRA SALVAT ARTUR;LUNA GOMEZ JESUS;RUIZ DE VILLA SUAREZ GONZALO;VALLEJO SUAREZ DE PUGAGUILLERMO;LAVIN DELGADO MANUEL. Datos registrales. T 30220 , F 60, S 8, H M 246035, I/A 16 (21.09.15).
Nombramientos. Apo.Sol.: MASCARAY MARTI MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 30220 , F 61, S 8, H M 246035, I/A 17(21.09.15).
22 de Octubre de 2014Cambio de domicilio social. C/ PROCION 7 Ptl.3 BAJO G (MADRID). Datos registrales. T 30220 , F 59, S 8, H M 246035, I/A 14(14.10.14).
09 de Octubre de 2014Revocaciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Nombramientos. Auditor: GRANDE BUSTOS MARIA. Aud.Supl.: CABEDOGREGORI RODRIGO. Datos registrales. T 30220 , F 58, S 8, H M 246035, I/A 13 ( 2.10.14).
21 de Enero de 2014Otros conceptos: ELIMINACION DE LA LIMITACION ECONOMICA DE DE 500.000 EUROS DE LAS FACULTADES ATRIBUIDAS ALOS CONSEJEROS DELEGADOS MANCOMUNADOS. Datos registrales. T 30220 , F 58, S 8, H M 246035, I/A 12 (13.01.14).
20 de Diciembre de 2013Ampliaci贸n de capital. Capital: 393.080,00 Euros. Resultante Suscrito: 400.000,00 Euros. Datos registrales. T 30220 , F 57, S 8, HM 246035, I/A 11 (12.12.13).
03 de Diciembre de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 108.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.920,00 Euros. Datos registrales. T 30220 , F 56,S 8, H M 246035, I/A 10 (25.11.13).
23 de Enero de 2013Modificaciones estatutarias. 25. Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 30220 , F 56, S 8, H M 246035, I/A 9(16.01.13).
22 de Noviembre de 2012Nombramientos. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 30220 , F 55, S 8, H M 246035, I/A 8 (13.11.12).
05 de Octubre de 2012Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 28.730,00 Euros. Resultante Suscrito: 114.920,00 Euros. Datos registrales. T 30220 , F54, S 8, H M 246035, I/A 7 (24.09.12).
21 de Febrero de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN SAN CRISTOBAL ALBERTO. Cons.Del.Man: MARTIN SAN CRISTOBAL ALBERTO. Datosregistrales. T 14801 , F 203, S 8, H M 246035, I/A 6 ( 8.02.12).
04 de Enero de 2011Nombramientos. Cons.Del.Man: LUNA GOMEZ JESUS;RUIZ DE VILLA SUAREZ GONZALO;VALLEJO SUAREZ DE PUGAGUILLERMO;LAVIN DELGADO MANUEL;MARTIN SAN CRISTOBAL ALBERTO. Datos registrales. T 14801 , F 203, S 8, H M246035, I/A 5 (24.12.10).
20 de Enero de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 121.450,00 Euros. Resultante Suscrito: 143.650,00 Euros. Datos registrales. T 14801 , F 202, S 8,H M 246035, I/A 4 ( 7.01.09).