Actos BORME de Adhesivos Del Segura Sociedad Anonima
18 de Diciembre de 2023Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3621 , F 214, S 8, H MU 15830, I/A 46 (11.12.23).
09 de Mayo de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: JOSE-ALFONSO BAENA SUAREZ. Datos registrales. T 3621 , F 214, S 8, H MU 15830, I/A 45(28.04.23).
27 de Marzo de 2023Reelecciones. Adm. Unico: PRINTEOS CARTERA INDUSTRIAL SL. Datos registrales. T 3237 , F 100, S 8, H MU 15830, I/A 43(20.03.23).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: JOAQUIN CHACON ALCALA. Datos registrales. T 3237 , F 100, S 8, H MU 15830, I/A 44(20.03.23).
11 de Octubre de 2022Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3237 , F 100, S 8, H MU 15830, I/A 42 ( 4.10.22).
25 de Noviembre de 2021Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3237 , F 100, S 8, H MU 15830, I/A 41 (18.11.21).
21 de Junio de 2021Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3237 , F 100, S 8, H MU 15830, I/A 40 (14.06.21).
31 de Enero de 2020Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3237 , F 100, S 8, H MU 15830, I/A 39 (24.01.20).
17 de Julio de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: VICTOR ABELLANER GIL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: JUAN FRANCISCO GARCIA ORTEGA.Datos registrales. T 3237 , F 99, S 8, H MU 15830, I/A 38 (10.07.19).
11 de Julio de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: TRINIDAD LOZANO MARTINEZ. Datos registrales. T 3237 , F 97, S 8, H MU 15830, I/A 36 (4.07.18).
09 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: PABLO CARAVACA SANCHEZ. Datos registrales. T 3237 , F 97, S 8, H MU 15830, I/A 35 (29.06.18).
14 de Diciembre de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: MIGUEL FERRER HERNANDEZ. Nombramientos. Apo.Man.Soli: VICTOR ABELLANER GIL;JOSE-ALFONSO BAENA SUAREZ. Datos registrales. T 3237 , F 96, S 8, H MU 15830, I/A 34 ( 4.12.17).
18 de Abril de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: JOSE PABLO CARRASCO GARCIA;EUSEBIO RAMON GOMARIZ. Datos registrales. T 3237 , F 96,S 8, H MU 15830, I/A 32 ( 7.04.17).
16 de Febrero de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: TRINIDAD LOZANO MARTINEZ. Datos registrales. T 3147 , F 223, S 8, H MU 15830, I/A 30(10.02.17).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MIGUEL FERRER HERNANDEZ. Datos registrales. T 3147 , F 223, S 8, H MU 15830, I/A 31(10.02.17).
25 de Noviembre de 2016Ceses/Dimisiones. Auditor: BLAZQUEZ & ASOCIADOS AUDITORES SLP. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datosregistrales. T 3147 , F 223, S 8, H MU 15830, I/A 29 (18.11.16).
03 de Marzo de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: JOSE LUIS ALCALDE BLANQUER;JUAN MARCOS COLOMINA HUELMO;JOSE LUIS GO脩IMASCARAQUE;FRANCISCO JAVIER ZAMBRANA CONTRERAS;ISIDORO RODRIGUEZ SANTIUSTE. Datos registrales. T 3147 , F222, S 8, H MU 15830, I/A 27 (25.02.16).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: JOSE PABLO CARRASCO GARCIA;ARTURO CARRASCO GARCIA;EUSEBIO RAMON GOMARIZ.Datos registrales. T 3147 , F 223, S 8, H MU 15830, I/A 28 (25.02.16).
02 de Marzo de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: JOSE PABLO CARRASCO GARCIA;EUSEBIO RAMON GOMARIZ. Nombramientos. Adm. Unico:PRINTEOS CARTERA INDUSTRIAL SL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 3013 , F 149, S 8, H MU 15830, I/A 26 (24.02.16).
03 de Noviembre de 2015Nombramientos. Auditor: BLAZQUEZ & ASOCIADOS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3013 , F 149, S 8, H MU 15830, I/A
18 de Febrero de 2015Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 371.479,80 Euros. Desembolsado: 371.479,80 Euros. Resultante Suscrito: 432.190,90 Euros.Resultante Desembolsado: 432.190,90 Euros. Datos registrales. T 3013 , F 147, S 8, H MU 15830, I/A 23 (11.02.15).
07 de Agosto de 2014Otros conceptos: Por orden ministerial de fecha 23 de Junio de 2.014, se conceden incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985de 27 de Diciembre, para la realizacion del proyecto de inversion presentado por esta sociedad titular del expediente MU/1341/P02, poruna subvencion a fondo perdido de 174.032,64 euros. Datos registrales. T 3013 , F 147, S 8, H MU 15830, I/A 22 (31.07.14).
25 de Febrero de 2014Otros conceptos: concesion de incentivos regionales. Datos registrales. T 3013 , F 146, S 8, H MU 15830, I/A 21 (18.02.14).
14 de Febrero de 2014Reelecciones. Auditor: BLAZQUEZ & ASOCIADOS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1958 , F 166, S 8, H MU 15830, I/A 20 (7.02.14).
14 de Enero de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: JOSE PABLO CARRASCO GARCIA;EUSEBIO RAMON GOMARIZ. Nombramientos. Adm. Solid.:JOSE PABLO CARRASCO GARCIA;EUSEBIO RAMON GOMARIZ. Otros conceptos: MODIFICACION DEL ARTICULO 12 DE LOSESTATUTOS SOCIALES.- Datos registrales. T 1958 , F 166, S 8, H MU 15830, I/A 19 ( 8.01.13).
07 de Marzo de 2011Nombramientos. Auditor: BLAZQUEZ & ASOCIADOS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1958 , F 166, S 8, H MU 15830, I/A18 (25.02.11).