Actos BORME de Adial Higiene Sl
12 de Mayo de 2023Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: DE GORGOLAS LOPEZ NICOLAS. Nombramientos. Secretario: PROLIMSUR MALAGA SL.Datos registrales. T 35509 , F 207, S 8, H M 339398, I/A 29 ( 5.05.23).
15 de Marzo de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOPEZ CARNE VICTOR MANUEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ CARNE VICTORMANUEL. Apo.Manc.: QUIMILEON HIGIENE INDUSTRIAL SL. Datos registrales. T 35509 , F 206, S 8, H M 339398, I/A 28 (8.03.23).
31 de Enero de 2023Nombramientos. Presidente: QUIMILEON HIGIENE INDUSTRIAL SL. Datos registrales. T 35509 , F 206, S 8, H M 339398, I/A 27(24.01.23).
09 de Diciembre de 2022Ceses/Dimisiones. Representan: DE GORGOLAS MARTIN-ALAMEDA VICTOR. Cons.Del.Sol: JEN QUIMICA SL. Presidente: JENQUIMICA SL. Nombramientos. Representan: VARGAS FUEYO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 35509 , F 205, S 8, H M339398, I/A 26 (30.11.22).
12 de Agosto de 2022Ceses/Dimisiones. Secretario: PROLIMSUR MALAGA SL. Nombramientos. SecreNoConsj: DE GORGOLAS LOPEZ NICOLAS.Modificaciones estatutarias. 8. Nombramiento duraci贸n y prohibici贸n de competencia.-. 9. Funcionamiento Junta General.-. 10.Funcionamiento Junta General.-. Datos registrales. T 35509 , F 203, S 8, H M 339398, I/A 24 ( 6.08.22).
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: JEN QUIMICA SL. Nombramientos. Cons.Del.Sol: JEN QUIMICA SL. Datos registrales. T35509 , F 205, S 8, H M 339398, I/A 25 ( 6.08.22).
13 de Junio de 2022Ceses/Dimisiones. Representan: DE GORGOLAS LOPEZ NICOLAS. Nombramientos. Representan: DE GORGOLAS MARTIN-ALAMEDA VICTOR. Datos registrales. T 35509 , F 203, S 8, H M 339398, I/A 23 ( 6.06.22).
30 de Marzo de 2021Revocaciones. Apoderado: IGLESIAS GONZALEZ ANGEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ CARNE VICTOR MANUEL.Apo.Manc.: JEN QUIMICA SL. Datos registrales. T 35509 , F 201, S 8, H M 339398, I/A 22 (23.03.21).
17 de Marzo de 2021Nombramientos. Cons.Del.Sol: JEN QUIMICA SL. Datos registrales. T 35509 , F 201, S 8, H M 339398, I/A 21 (10.03.21).
14 de Junio de 2019Cambio de domicilio social. AVDA DE LA ALBUFERA 321 4 7 (MADRID). Datos registrales. T 35509 , F 201, S 8, H M 339398, I/A20 ( 7.06.19).
28 de Noviembre de 2017Cambio de domicilio social. C/ ALBASANZ 14BIS 2E (MADRID). Datos registrales. T 19360 , F 225, S 8, H M 339398, I/A 18(21.11.17).
Revocaciones. Apoderado: CA脩O URIBE ARANZAZU. Nombramientos. Apoderado: IGLESIAS GONZALEZ ANGEL. Datosregistrales. T 19360 , F 225, S 8, H M 339398, I/A 19 (21.11.17).
02 de Agosto de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: SUQUISA SL. Representan: GARCIA SAGASTI ANGEL RUPERTO. Datos registrales. T 19360 , F224, S 8, H M 339398, I/A 17 (25.07.17).
23 de Julio de 2015Reelecciones. Auditor: AUDILEX AUDITORES SL. Datos registrales. T 19360 , F 224, S 8, H M 339398, I/A 16 (16.07.15).
20 de Junio de 2014Ceses/Dimisiones. Representan: LAGO BRAVO DE LAGUNA VICTOR. Consejero: CAVAS CATALANAS SL. Datos registrales. T19360 , F 224, S 8, H M 339398, I/A 15 (10.06.14).
10 de Febrero de 2014Nombramientos. Representan: GARCIA SAGASTI ANGEL RUPERTO;NAVASCUES BONNIN MARIA-PAZ. Consejero: SUQUISASL;QUIMILEON HIGIENE INDUSTRIAL SL. Datos registrales. T 19360 , F 223, S 8, H M 339398, I/A 14 (31.01.14).
17 de Enero de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: DARLIM SL. Representan: CUEVAS FARO SAUL. Datos registrales. T 19360 , F 223, S 8, H M339398, I/A 13 ( 9.01.14).
11 de Diciembre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: MU脩OZ BOSCH SL. Representan: MU脩OZ BOSCH RAFAEL. Datos registrales. T 19360 , F 223, S8, H M 339398, I/A 12 (29.11.13).
19 de Agosto de 2013Nombramientos. Consejero: SUMINISTROS ALF SA. Representan: ALFARO CARCELLER JAVIER JOAQUIN. Datos registrales. T19360 , F 222, S 8, H M 339398, I/A 11 ( 9.08.13).
26 de Marzo de 2013Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 10& EL NOMBRAMIENTO DE "CAVAS CATALANAS SA", SIENDOLO CORRECTO "CAVAS CATALANAS SL". Datos registrales. T 19360 , F 221, S 8, H M 339398, I/A 10 (12.03.13).
21 de Marzo de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: DE GORGOLAS LOPEZ NICOLAS. Presidente: DE GORGOLAS LOPEZ NICOLAS. Consejero:RUBIO JARA DANIEL;MU脩OZ BOSCH RAFAEL;HUETO PEREZ FRANCISCO;LAGO BRAVO DE LAGUNA VICTOR;CUEVAS FAROSAUL. Secretario: HUETO PEREZ FRANCISCO. Nombramientos. Representan: DE GORGOLAS LOPEZ NICOLAS. Auditor:AUDILEX AUDITORES SL. Consejero: JEN QUIMICA SL;PROLIMSUR MALAGA SL;DARLIM SL;CAVAS CATALANAS SA;MU脩OZBOSCH SL. Presidente: JEN QUIMICA SL. Secretario: PROLIMSUR MALAGA SL. Representan: HUETO PEREZFRANCISCO;CUEVAS FARO SAUL;LAGO BRAVO DE LAGUNA VICTOR;MU脩OZ BOSCH RAFAEL. Datos registrales. T 19360 , F221, S 8, H M 339398, I/A 10 (12.03.13).
28 de Febrero de 2012Cambio de domicilio social. C/ CORAZON DE MARIA 6 5 - OFICINA 4 (MADRID). Datos registrales. T 19360 , F 221, S 8, H M339398, I/A 9 (17.02.12).
02 de Febrero de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: ALFARO CARCELLER JAVIER;GARCIA ALMONACID SANTIAGO;JOSE CARBONELL JULIAN.Secretario: ALFARO CARCELLER JAVIER. Consejero: GARCIA SAGASTI ANGEL RUPERTO;RUEDA CARVAJAL JUAN CARLOS.Nombramientos. Consejero: RUBIO JARA DANIEL;MU脩OZ BOSCH RAFAEL;HUETO PEREZ FRANCISCO;LAGO BRAVO DELAGUNA VICTOR;CUEVAS FARO SAUL. Secretario: HUETO PEREZ FRANCISCO. Datos registrales. T 19360 , F 220, S 8, H M339398, I/A 8 (24.01.11).
30 de Noviembre de 2010Revocaciones. Apo.Man.Soli: MU脩OZ BOSCH FRANCISCO JOSE. Nombramientos. Apoderado: CA脩O URIBE ARANZAZU.Datos registrales. T 19360 , F 220, S 8, H M 339398, I/A 7 (18.11.10).
17 de Mayo de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: CUEVAS MONTES INDALECIO;RUBIO DIAZ ELOY. Nombramientos. Consejero: GARCIASAGASTI ANGEL RUPERTO;RUEDA CARVAJAL JUAN CARLOS. Datos registrales. T 19360 , F 219, S 8, H M 339398, I/A 6 (5.05.10).