Actos BORME de Adibio Sl
27 de Febrero de 2023Otros conceptos: Refundici贸n de los estatutos sociales. De acuerdo al informe de administradores, y habiendo votado de formaseparada cada art铆culo, se acuerda por unanimidad derogar en su totalidad los Estatutos Sociales y aprobar un nuevo texto refundido,Datos registrales. T 275, L 275, F 4, S 8, H TE 6450, I/A 8 ( 9.02.23).
21 de Abril de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: MARTINEZ JUAN JOSE LUIS;FELIPE ESCORIHUELA SAHUN;ROMERO LOPEZ VICENTE;JORGEALBERTO MORTE MURILLO;PEREZ ESCUDER DANIEL;IBA脩EZ CASTELLOTE ROBERTO;RICARDO JESUS SOBREVIELA SOLA.Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ JUAN JOSE LUIS;FELIPE ESCORIHUELA SAHUN;ROMERO LOPEZ VICENTE;JORGEALBERTO MORTE MURILLO;PEREZ ESCUDER DANIEL;IBA脩EZ CASTELLOTE ROBERTO;RICARDO JESUS SOBREVIELASOLA;MONICA AGUILAR MONTESINOS;ALBA GIMENO LEAL. Datos registrales. T 274, L 274, F 101, S 8, H TE 6450, I/A 7(13.04.21).
01 de Febrero de 2021Modificaciones estatutarias. "ARTICULO 14. RETRIBUCION DEL ADMINISTRADOR. El cargo de Administrador no ser谩 retribuido.No obstante, las personas que ocupen ese cargo podr谩n perdbir de la Sociedad tanto honorarios por servidos profesionales comosalarios por vinculad贸n laboral, siempre y cuando estas relaciones sean independientes de su car谩cter de Administrador, la retribuci贸nque conl. Datos registrales. T 274, L 274, F 101, S 8, H TE 6450, I/A 6 (31.12.20).
19 de Junio de 2019Revocaciones. Apoderado: RAMOS FERNANDEZ ALBERTO;VIVAS SAURA MIGUEL-ANDRES. Nombramientos. Apoderado:ALBA GIMENO LEAL. Datos registrales. T 272, L 272, F 71, S 8, H TE 6450, I/A 5 ( 6.06.19).
22 de Mayo de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ DIES SANTIAGO. Nombramientos. Consejero: ALBA GIMENO LEAL. Datos registrales. T272, L 272, F 71, S 8, H TE 6450, I/A 4 (14.05.19).
05 de Abril de 2018Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los Estatutos : ARTICULO 4.- El domicilio de la sociedad est谩 en Teruel, Calle Enebrosn煤mero 74, Edificio Galileo, 2陋 planta -44002-. Por acuerdod el 贸rgano de administraci贸n, podr谩 trasladarse dentro de la mismapoblaci贸n donde se halle establecido, as铆 como crearse, modificarse o suprimirse sucursales, agencais o delegaciones, tanto en.Cambio de domicilio social. C/ ENEBROS, 74 2陋-EDIFICIO GALILEO 44002 (TERUEL). Datos registrales. T 272, L 272, F 70, S 8,H TE 6450, I/A 2 (27.03.18).
Revocaciones. Apo.Manc.: MARTINEZ JUAN JOSE LUIS. Apo.Sol.: MARTINEZ JUAN JOSE LUIS. Apo.Manc.: VIVAS SAURAMIGUEL-ANDRES. Apo.Sol.: VIVAS SAURA MIGUEL-ANDRES. Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ JUAN JOSELUIS;FELIPE ESCORIHUELA SAHUN;ROMERO LOPEZ VICENTE;MORTE MURILLO JORGE ALBERTO;PEREZ ESCUDERDANIEL;IBA脩EZ CASTELLOTE ROBERTO;SOBREVIELA SOLA RICARDO. Datos registrales. T 272, L 272, F 70, S 8, H TE 6450,I/A 3 (27.03.18).
20 de Diciembre de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 14.286,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:5.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.000,00 Euros. Datos registrales. T 33848 , F 65, S 8, H M 586307, I/A 10 (12.12.17).
24 de Octubre de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ JUAN JOSE LUIS. Apo.Manc.: MARTINEZ JUAN JOSE LUIS. Apo.Sol.: VIVAS SAURAMIGUEL-ANDRES. Apo.Manc.: VIVAS SAURA MIGUEL-ANDRES. Datos registrales. T 33848 , F 64, S 8, H M 586307, I/A 9(16.10.17).
28 de Septiembre de 2017Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ JUAN JOSE LUIS;MARCA PUIG JORDI. Datos registrales. T 33848 , F 63, S 8, H M586307, I/A 8 (20.09.17).
21 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ LORENTE MARIA PILAR;VIVAS SAURA MIGUEL-ANDRES;IBA脩EZ CASTELLOTEROBERTO;RAMOS FERNANDEZ ALBERTO. Datos registrales. T 33848 , F 63, S 8, H M 586307, I/A 7 (12.07.17).
01 de Octubre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: MARCA PUIG JUAN;MARCA PUIG JORDI;LOPEZ MARTIN RAUL;ALVAREZ FERNANDEZ DEGAMARRA CARMELO;LOPEZ RAMOS ABELARDO JUAN. Vicepresid.: MARCA PUIG JUAN;ALVAREZ FERNANDEZ DE GAMARRACARMELO. Secretario: LOPEZ MARTIN RAUL. Co.De.Ma.So: MARCA PUIG JORDI. Nombramientos. SecreNoConsj: NOLASCOGOMEZ JOSE MANUEL. Consejero: PEREZ DIES SANTIAGO;MARTINEZ JUAN JOSE LUIS. Ampliaci贸n de capital. Capital:8.286,00 Euros. Resultante Suscrito: 14.286,00 Euros. Modificaciones estatutarias. SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 8, 10 Y 12DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. . Cambio de domicilio social. PLAZA DE LAS CORTES, 4, PISO 1 IZQUIERDA. (MADRID).Datos registrales. T 32573 , F 139, S 8, H M 586307, I/A 5 (23.09.15).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ JUAN JOSE LUIS;MARCA PUIG JORDI. Datos registrales. T 33848 , F 62, S 8, H M586307, I/A 6 (23.09.15).
24 de Septiembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: WORLD SMART OMNIA SERVICES SL. Co.De.Ma.So: WORLD SMART OMNIA SERVICES SL.Representan: PIRES ALCAIDE LUIS. Datos registrales. T 32573 , F 139, S 8, H M 586307, I/A 4 (15.09.15).
24 de Octubre de 2014Nombramientos. Co.De.Ma.So: MARCA PUIG JORDI;WORLD SMART OMNIA SERVICES SL. Datos registrales. T 32573 , F 138,S 8, H M 586307, I/A 3 (16.10.14).
17 de Septiembre de 2014Cambio de domicilio social. C/ MARQUES DE CUBAS 25, - 3潞-DERECHA (MADRID). Datos registrales. T 32573 , F 138, S 8, H M586307, I/A 2 ( 8.09.14).
20 de Agosto de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARCA PUIG JORDI. Nombramientos. Consejero: RUBIO NISTAL PEDRO MIGUEL;MARCAPUIG JUAN;MARCA PUIG JORDI;LOPEZ MARTIN RAUL;ALVAREZ FERNANDEZ DE GAMARRA CARMELO;LOPEZ RAMOSABELARDO JUAN. Presidente: RUBIO NISTAL PEDRO MIGUEL. Consejero: WORLD SMART OMNIA SERVICES SL. Vicepresid.:MARCA PUIG JUAN;ALVAREZ FERNANDEZ DE GAMARRA CARMELO. Secretario: LOPEZ MARTIN RAUL. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 1267 , F 71, S 8, H L25201, I/A 3 (11.08.14).
29 de Octubre de 2012Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: BOREN RUIZ ANA CRISTINA;MARCA PUIG JORDI. Nombramientos. Adm. Unico: MARCAPUIG JORDI. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados a Administrador煤nico. Cambio de domicilio social. C/ RAMON MUNTANER 32 (TORREFARRERA). Datos registrales. T 1267 , F 70, S 8, H L25201, I/A 2 (17.10.12).
14 de Abril de 2011Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 10.03.11. Objeto social: El desarrollo, fabricaci贸n y distribuci贸n de productos orientados el谩mbito de la alimentaci贸n y salud animal en general del mercado veterinario. La explotaci贸n de fincas agr铆colas y ganaderas decualquier tipo. Domicilio: C/ PINYANA S/N - POLIGONO DE TORREFARRERA (TORREFARRERA). Capital: 6.000,00 Euros.Nombramientos. Adm. Mancom.: BOREN RUIZ ANA CRISTINA;MARCA PUIG JORDI. Datos registrales. T 1267 , F 64, S 8, H L25201, I/A 1 ( 5.04.11).