Buscador CIF Logo

Actos BORME Adm Agro Iberica Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Adm Agro Iberica Sl

Actos BORME Adm Agro Iberica Sl - B78071669

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Adm Agro Iberica Sl con CIF B78071669

🔙 Perfil de Adm Agro Iberica Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Adm Agro Iberica Sl

14 de Diciembre de 2023
Revocaciones. Apoderado: VALLEJO DREHS MARTIN. Nombramientos. Apo.Sol.: CUESTA ILLANA JOSE LUIS. Apo.Manc.:LORENTE BULNES RAMON. Datos registrales. T 20359 , F 73, S 8, H M 70629, I/A 72 ( 5.12.23).

18 de Abril de 2023
Nombramientos. Cons.Del.Man: FRANCO BONILLA GUILLERMINA. Datos registrales. T 20359 , F 72, S 8, H M 70629, I/A 71

06 de Marzo de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: VALLEJO DREHS MARTIN. Secretario: VALLEJO DREHS MARTIN. Cons.Del.Man: VALLEJODREHS MARTIN. Nombramientos. Consejero: FRANCO BONILLA GUILLERMINA. Secretario: FRANCO BONILLA GUILLERMINA.Datos registrales. T 20359 , F 72, S 8, H M 70629, I/A 70 (27.02.23).

21 de Febrero de 2023
Revocaciones. Apo.Manc.: BERNAR SOLANO PEDRO. Nombramientos. Apo.Manc.: FRANCO BONILLAGUILLERMINA;HERNANDEZ RODRIGUEZ BELEN;HERRAIZ MORALES ALEJANDRO VICTOR;GARCIA MARTINEZ JUANCARLOS. Datos registrales. T 20359 , F 71, S 8, H M 70629, I/A 69 (14.02.23).

07 de Octubre de 2022
Nombramientos. Apo.Manc.: DAMDIMOPOULOS DIMITRIS;OKROY ADRIANA WIESLAWA LOJEWSKI;FRANJOLA MARIAVALLEJOS-OLGA;ROMANIAN CORNEL MOCANU;POLISH SINGLEUL DANIEL PAWEL KOLASA;POLISH SINGLEUL ROMANBASINSKI;POLISH SINGLEUL MALGORZATA WOJCIECHOWSKA. Datos registrales. T 20359 , F 71, S 8, H M 70629, I/A 68(30.09.22).

12 de Septiembre de 2022
Nombramientos. Auditor: RSM SPAIN AUDITORES SLP. Datos registrales. T 20359 , F 70, S 8, H M 70629, I/A 67 ( 5.09.22).

02 de Febrero de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: BERNAR SOLANO PEDRO-ALFONSO. Cons.Del.Man: BERNAR SOLANO PEDRO-ALFONSO.Nombramientos. Consejero: GAITAN SALAMANCA JOAQUIN. Cons.Del.Man: GAITAN SALAMANCA JOAQUIN. Datos registrales.T 20359 , F 70, S 8, H M 70629, I/A 66 (26.01.22).

24 de Diciembre de 2021
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 20359 , F 70, S 8, H M 70629, I/A 65 (17.12.21).

17 de Febrero de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: IDIAZABAL HERNANDO JOSE RAMON. Cons.Del.Man: IDIAZABAL HERNANDO JOSE RAMON.Nombramientos. Consejero: BERNAR SOLANO PEDRO-ALFONSO. Cons.Del.Man: BERNAR SOLANO PEDRO-ALFONSO. Datosregistrales. T 20359 , F 69, S 8, H M 70629, I/A 63 (10.02.21).

Revocaciones. Apo.Sol.: IDIAZABAL HERNANDO JOSE RAMON. Apoderado: IDIAZABAL HERNANDO JOSE RAMON;STEPHANJURGEN;FUCHS HARTWIG. Apo.Man.Soli: GONZALEZ GUTIERREZ RAUL. Datos registrales. T 20359 , F 69, S 8, H M 70629, I/A64 (10.02.21).

05 de Enero de 2021
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 20359 , F 69, S 8, H M 70629, I/A 62 (28.12.20).

12 de Febrero de 2020
Ceses/Dimisiones. Presidente: LASTRA DOMINGO ALEJANDRO. Consejero: LASTRA DOMINGO ALEJANDRO. Nombramientos.Consejero: HEIJBROEK PATRICK CHRISTIAAN. Presidente: HEIJBROEK PATRICK CHRISTIAAN. Datos registrales. T 20359 , F68, S 8, H M 70629, I/A 60 ( 5.02.20).

Modificaciones estatutarias. 16.-. Datos registrales. T 20359 , F 68, S 8, H M 70629, I/A 61 ( 5.02.20).

11 de Octubre de 2019
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 20359 , F 68, S 8, H M 70629, I/A 59 ( 6.10.19).

07 de Noviembre de 2018
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 20359 , F 67, S 8, H M 70629, I/A 58 (30.10.18).

27 de Octubre de 2017
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 20359 , F 67, S 8, H M 70629, I/A 57 (18.10.17).

10 de Marzo de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: RAINER VON RYMON THOMAS HANS. Vicepresid.: RAINER VON RYMON THOMAS HANS. Datosregistrales. T 20359 , F 67, S 8, H M 70629, I/A 56 ( 3.03.17).

14 de Octubre de 2016
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 20359 , F 67, S 8, H M 70629, I/A 55 ( 6.10.16).

04 de Agosto de 2015
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 20359 , F 67, S 8, H M 70629, I/A 54 (23.07.15).

05 de Noviembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: TIEDEMANN THORSTEN. Vicepresid.: TIEDEMANN THORSTEN. Nombramientos. Consejero:RAINER VON RYMON THOMAS HANS. Vicepresid.: RAINER VON RYMON THOMAS HANS. Datos registrales. T 20359 , F 66, S 8,H M 70629, I/A 53 (29.10.14).

10 de Octubre de 2014
Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ GUTIERREZ RAUL;SANCHEZ RUIZ JESUS JOSE;HERNANDEZ RODRIGUEZ BELEN.Apo.Manc.: BERNAR SOLANO PEDRO;RUIZ GOMEZ MANUEL;GONZALEZ GUTIERREZ RAUL;SANCHEZ RUIZ JESUS JOSE.Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ GUTIERREZ RAUL;SANCHEZ RUIZ JESUS JOSE;HERNANDEZ RODRIGUEZBELEN;GARCIA PEREZ VICTOR MIGUEL. Apo.Manc.: BERNAR SOLANO PEDRO. Datos registrales. T 20359 , F 65, S 8, H M70629, I/A 52 ( 3.10.14).

09 de Octubre de 2014
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 20359 , F 65, S 8, H M 70629, I/A 51 ( 1.10.14).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información