Actos BORME de Administraciones Zalle Sl
16 de Octubre de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: ZABALA LLERANDI MIGUEL ANGEL;GARCIA MONTE ALEJANDRO. Apo.Manc.: ZABALA LLERANDIMIGUEL ANGEL;GARCIA MONTE ALEJANDRO. Datos registrales. T 4466 , F 112, S 8, H AS 50293, I/A 10 ( 5.10.23).
05 de Noviembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: ZABALA DEL REY MIGUEL ANGEL;CAMPILLO MARTINEZ PRUDENCIA ENCARNACION.Presidente: ZABALA DEL REY MIGUEL ANGEL. Consejero: ZABALA LLERANDI JORGE ABELARDO. Secretario: ZABALALLERANDI JORGE ABELARDO. Con.Delegado: ZABALA DEL REY MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Adm. Unico: INVERSIONESZALLE SL. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4. Domicilio social y web corporativa.-. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Cambio de domicilio social. C/ J -POLIGONO DE PRONI NAVE 1, MERES (SIERO). Datos registrales. T 4217 , F 99, S 8, H AS 50293, I/A 8 (27.10.21).
Nombramientos. Apoderado: ZABALA LLERANDI MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 4217 , F 99, S 8, H AS 50293, I/A 9(27.10.21).
26 de Junio de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: ZABALA LLERANDI MIGUEL ANGEL;GARCIA MONTE ALEJANDRO. Apo.Manc.: ZABALA LLERANDIMIGUEL ANGEL;GARCIA MONTE ALEJANDRO. Datos registrales. T 4217 , F 98, S 8, H AS 50293, I/A 7 (18.06.19).
21 de Junio de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ MACIAS VERONICA. Apo.Manc.: GONZALEZ MACIAS VERONICA. Apo.Sol.: GONZALEZFERNANDEZ BEATRIZ. Apo.Manc.: GONZALEZ FERNANDEZ BEATRIZ;ZABALA LLERANDI MIGUEL ANGEL;GONZALEZ MACIASVERONICA;GONZALEZ FERNANDEZ BEATRIZ. Datos registrales. T 4217 , F 98, S 8, H AS 50293, I/A 6 (13.06.19).
08 de Junio de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ MACIAS VERONICA. Apo.Manc.: GONZALEZ MACIAS VERONICA. Apo.Sol.: GONZALEZFERNANDEZ BEATRIZ. Apo.Manc.: GONZALEZ FERNANDEZ BEATRIZ. Datos registrales. T 4217 , F 96, S 8, H AS 50293, I/A 4(31.05.18).
Nombramientos. Apo.Manc.: ZABALA LLERANDI MIGUEL ANGEL;GONZALEZ MACIAS VERONICA;GONZALEZ FERNANDEZBEATRIZ Datos registrales. T 4217 , F 97, S 8, H AS 50293, I/A 5 (31.05.18).
10 de Mayo de 2018Revocaciones. Consejero: LLAMES GONZALEZ JOSE MARIA;SUAREZ GARCIA IVAN. Secretario: SUAREZ GARCIA IVAN.Apo.Sol.: CAMPILLO MARTINEZ PRUDENCIA ENCARNACION;LLAMES GONZALEZ JOSE MARIA;SUAREZ GARCIA IVAN.Apo.Manc.: CAMPILLO MARTINEZ PRUDENCIA ENCARNACION;LLAMES GONZALEZ JOSE MARIA;SUAREZ GARCIA IVAN.Nombramientos. Apo.Manc.: ZABALA LLERANDI JORGE ABELARDO. Apo.Sol.: ZABALA LLERANDI JORGE ABELARDO.Consejero: ZABALA LLERANDI JORGE ABELARDO. Secretario: ZABALA LLERANDI JORGE ABELARDO. Con.Delegado: ZABALADEL REY MIGUEL ANGEL. Apo.Manc.: CAMPILLO MARTINEZ PRUDENCIA ENCARNACION. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 4. Domicilio social y web corporativa.-. Cambio de domicilio social. C/ LIBERTAD 27 1潞 A (GIJON). Datosregistrales. T 4217 , F 96, S 8, H AS 50293, I/A 3 ( 2.05.18).
27 de Octubre de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: CAMPILLO MARTINEZ PRUDENCIA ENCARNACION;LLAMES GONZALEZ JOSE MARIA;SUAREZGARCIA IVAN. Apo.Manc.: CAMPILLO MARTINEZ PRUDENCIA ENCARNACION;LLAMES GONZALEZ JOSE MARIA;SUAREZGARCIA IVAN. Datos registrales. T 4217 , F 95, S 8, H AS 50293, I/A 2 (19.10.16).
14 de Octubre de 2016Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 20.09.16. Objeto social: CNAE 6820. La adquisici贸n, tenencia, explotaci贸n y enajenaci贸npor cualquier t铆tulo de edificaciones, fincas urbanas y r煤sticas en general, as铆 como la rehabilitaci贸n, edificaci贸n y promoci贸n de lasmismas. Domicilio: POLIG INDUSTRIAL DE SANTIANES S/N - SANTIANES (SARIEGO). Capital: 355.100,00 Euros.Nombramientos. Consejero: ZABALA DEL REY MIGUEL ANGEL;SUAREZ GARCIA IVAN;CAMPILLO MARTINEZ PRUDENCIAENCARNACION;LLAMES GONZALEZ JOSE MARIA. Presidente: ZABALA DEL REY MIGUEL ANGEL. Secretario: SUAREZ GARCIAIVAN. Datos registrales. T 4217 , F 76, S 8, H AS 50293, I/A 1 ( 5.10.16).