Actos BORME de Adroher Germans Sa
03 de Julio de 2020Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 320/2015. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 5/06/2020. Auto de conclusi贸n delconcurso. Insuficiencia de la masa activa. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE GIRONA. Juez:SANTIAGO ARAGONES SEIJO. Resoluciones: La conclusi贸n del procedimiento concursal por insuficiencia de la masa activa.Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 320/2015. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 5/06/2020. Cese de las limitaciones de lasfacultades de administraci贸n. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE GIRONA. Juez: SANTIAGOARAGONES SEIJO. Extinci贸n. Datos registrales. T 1786 , F 29, S 8, H GI 6711, I/A 52 (26.06.20).
13 de Marzo de 2014Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: MARTI ADROHER SULLA. Nombramientos. Cons.Del.Sol: JOSEP MARIA ADROHER BEN.Datos registrales. T 1786 , F 28, S 8, H GI 6711, I/A 49 ( 6.03.14).
Nombramientos. Apoderado: MARTI ADROHER SULLA. Datos registrales. T 1786 , F 29, S 8, H GI 6711, I/A 50 ( 6.03.14).
27 de Diciembre de 2013Modificaciones estatutarias. Se establece que el cargo de administrador sea retribuido. . Datos registrales. T 1786 , F 28, S 8, HGI 6711, I/A 47 (19.12.13).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARIA CARME CEZON CEPERO;EMILIO CARMONA VALLES;JOSEP DIAZ ALONSO. Datosregistrales. T 1786 , F 28, S 8, H GI 6711, I/A 48 (19.12.13).
17 de Diciembre de 2013Ceses/Dimisiones. Secretario: MARTI ADROHER SULLA. Nombramientos. Secretario: FRANCESCA SULLA CANO. Datosregistrales. T 1786 , F 28, S 8, H GI 6711, I/A 46 (11.12.13).
18 de Octubre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: JOSEP ADROHER SULLA;FRANCESC ADROHER SULLA. Secretario: JOSEP ADROHER SULLA.Con.Delegado: JOSEP ADROHER SULLA. Nombramientos. Consejero: FRANCESCA SULLA CANO;MARTI ADROHER SULLA.Secretario: MARTI ADROHER SULLA. Con.Delegado: MARTI ADROHER SULLA. Modificaciones estatutarias. 11. Administraci贸n yRepresentacion.- FACULTADES DE LA ADMINISTRACION: El 贸rgano de Administraci贸n tendr谩 las facultades y atribuciones que porla Ley no est茅n preceptivamente reservadas a la Junta General. A t铆tulo enunciativo y no limitativo , se enumeran como facultadespropias de la. Cambio de domicilio social. CTRA SANTA COLOMA 82 BAJOS - POLIGONO INDUSTRIAL M (GIRONA). Datosregistrales. T 1786 , F 27, S 8, H GI 6711, I/A 45 (10.10.13).
29 de Mayo de 2012Reelecciones. Auditor: AUDITORIA I CONTROL AUDITORS SLP. Datos registrales. T 1786 , F 27, S 8, H GI 6711, I/A 44(17.05.12).
18 de Noviembre de 2011Revocaciones. Apo.Manc.: JOSEP ADROHER SULLA;JOSE MARIA VICENS ESTRACH;DOLORES TORRAMILANS LLUNELL.Datos registrales. T 1786 , F 27, S 8, H GI 6711, I/A 43 ( 9.11.11).
25 de Enero de 2011Reelecciones. Consejero: JOSEP MARIA ADROHER BEN;JOSEP ADROHER SULLA;FRANCESC ADROHER SULLA. Presidente:JOSEP MARIA ADROHER BEN. Secretario: JOSEP ADROHER SULLA. Con.Delegado: JOSEP ADROHER SULLA. Modificacionesestatutarias. 8. Administraci贸n y Representacion.- El cargo del 贸rgano de administraci贸n ser谩 retribuido. La retribuci贸n consistir谩enuna cantidad fija anual no participativa que ser谩 determinada para cada ejercicio por acuerdo de la Junta General. . Datos registrales.T 1786 , F 27, S 8, H GI 6711, I/A 42 (13.01.11).
23 de Enero de 2009Reelecciones. Auditor: AUDITORIA I CONTROL AUDITORS SL. Datos registrales. T 1786 , F 27, S 8, H GI 6711, I/A 41 (10.01.09).