Actos BORME de Aduanas Logistica Transportes E Intermediacion En Unidades De Servicio Sa
26 de Abril de 2023Reelecciones. Auditor: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL. Datos registrales. T 4287, L 4287, F 177, S 8, H PO27278, I/A 151 (31.03.23).
14 de Marzo de 2023Reelecciones. Consejero: ORTEGA TAMAYO OLGA;RAIMUNDEZ JUSTO JOSE MANUEL. Presidente: DAVILA VEGA EDUARDO.Consejero: DAVILA VEGA EDUARDO;GARCIA-MAURIÑO BRASCHI JAIME MARIA. Cons.Del.Sol: DAVILA VEGAEDUARDO;GARCIA-MAURIÑO BRASCHI JAIME MARIA. Consejero: DAVILA GONZALEZ PELAYO. Datos registrales. T 4287, L4287, F 177, S 8, H PO 27278, I/A 150 ( 6.03.23).
25 de Enero de 2023Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ GARCIA PAULA. Datos registrales. T 4287, L 4287, F 176, S 8, H PO 27278, I/A 149(17.01.23).
23 de Mayo de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ GOMEZ DAVID. Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ VIEITEZ EUGENIO. Datosregistrales. T 4287, L 4287, F 176, S 8, H PO 27278, I/A 148 (13.05.22).
24 de Marzo de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: TURREZ IBARZABAL JOSE MARIA. Apo.Sol.: TURREZ IBARZABAL JOSE MARIA. Datos registrales.T 4287, L 4287, F 175, S 8, H PO 27278, I/A 147 (16.03.22).
17 de Marzo de 2022Revocaciones. Apoderado: MATIAS REVELO ALFREDO JESUS. Nombramientos. Apoderado: GUZMAN ELORZA PEDRO.Datos registrales. T 4287, L 4287, F 174, S 8, H PO 27278, I/A 146 ( 9.03.22).
22 de Diciembre de 2021Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA HERNANDO GONZALO;ESCLAPES DIAZ ALBERTO;HERRERO MATEOS FATIMA. Datosregistrales. T 4287, L 4287, F 174, S 8, H PO 27278, I/A 145 (10.12.21).
21 de Diciembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA HERNANDO GONZALO;ORTEGA TAMAYO OLGA;HERRERO MATEOS FATIMA. Datosregistrales. T 4287, L 4287, F 174, S 8, H PO 27278, I/A 144 (10.12.21).
04 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: PORRUA NUÑEZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 4287, L 4287, F 173, S 8, H PO 27278, I/A 143(26.10.21).
01 de Febrero de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: VILLORIA CHACON MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 4287, L 4287, F 172, S 8, H PO 27278,I/A 142 (25.01.21).
11 de Noviembre de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: COCA LASSO DE LA VEGA JAVIER. Apoderado: CASTRO SUAREZ MARTA-MARIA;SOLER VALLESPINFEDERICO. Datos registrales. T 4287, L 4287, F 172, S 8, H PO 27278, I/A 141 ( 2.11.20).
26 de Octubre de 2020Nombramientos. Consejero: DAVILA GONZALEZ PELAYO. Datos registrales. T 4287, L 4287, F 172, S 8, H PO 27278, I/A 140(16.10.20).
14 de Julio de 2020Revocaciones. Apoderado: MCHIRI SAMI. Apo.Sol.: MCHIRI SAMI;BLAY GARBAYO BEGONYA. Apoderado: GARCIA PEREZARANZAZU. Datos registrales. T 4287, L 4287, F 172, S 8, H PO 27278, I/A 139 ( 7.07.20).
27 de Marzo de 2020Revocaciones. Apo.Manc.: ORTEGA TAMAYO OLGA;TURREZ IBARZABAL JOSE MARIA;DIEZ GIL LORENA. Nombramientos.Apo.Manc.: ORTEGA TAMAYO OLGA;TURREZ IBARZABAL JOSE MARIA;DIEZ GIL LORENA;GOMEZ HERNANDOAITZIBER;TEJEDOR ESCOBAR BLANCA. Datos registrales. T 4287, L 4287, F 171, S 8, H PO 27278, I/A 138 (18.03.20).
16 de Marzo de 2020Reelecciones. Auditor: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 171, S 8, H PO27278, I/A 137 ( 9.03.20).
25 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apoderado: RODON SANS SANDRA. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 170, S 8, H PO 27278, I/A 136(15.11.19).
22 de Noviembre de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: MANZANARES BALLESTEROS EVA. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 170, S 8, H PO 27278, I/A 135(15.11.19).
03 de Julio de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ GOMEZ DAVID. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 124, S 8, H PO 27278, I/A 132(24.06.19).
Revocaciones. Apoderado: IZQUIERDO FIORENZA CARLOS JESUS. Datos registrales. T 4287, L 4287, F 170, S 8, H PO 27278,I/A 133 (24.06.19).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA PEREZ ARANZAZU. Datos registrales. T 4287, L 4287, F 170, S 8, H PO 27278, I/A 134(24.06.19).
31 de Mayo de 2019Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: DAVILA VEGA EDUARDO;GARCIA-MAURIÑO BRASCHI JAIME MARIA. Nombramientos.Cons.Del.Sol: DAVILA VEGA EDUARDO;GARCIA-MAURIÑO BRASCHI JAIME MARIA. Reelecciones. Presidente: DAVILA VEGAEDUARDO. Consejero: DAVILA VEGA EDUARDO;GARCIA-MAURIÑO BRASCHI JAIME MARIA. Datos registrales. T 4203, L 4203,F 124, S 8, H PO 27278, I/A 131 (23.05.19).
18 de Marzo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: AGUIRRE ESPARZA MERCEDES. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 124, S 8, H PO 27278, I/A 129 (7.03.19).
Revocaciones. Apo.Manc.: LOPEZ GIMENO HELENA. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 124, S 8, H PO 27278, I/A 130 (7.03.19).
22 de Febrero de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: DELGADO MONFORTE AURELIO. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 123, S 8, H PO 27278, I/A 127(13.02.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: BLAY GARBAYO BEGONYA. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 123, S 8, H PO 27278, I/A 128(13.02.19).
05 de Febrero de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: MENDEZ SUAREZ SUSANA ISABEL. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 123, S 8, H PO 27278, I/A126 (29.01.19).
14 de Enero de 2019Nombramientos. Apoderado: MATIAS REVELO ALFREDO JESUS. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 122, S 8, H PO 27278, I/A125 ( 4.01.19).
18 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: IZQUIERDO FIORENZA CARLOS JESUS. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 121, S 8, H PO27278, I/A 123 (12.07.18).
Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ANTONIO. Apo.Sol.: FERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ANTONIO.Datos registrales. T 4203, L 4203, F 121, S 8, H PO 27278, I/A 124 (12.07.18).
05 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: IGUAL APARICIO IVAN. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 121, S 8, H PO 27278, I/A 122(27.06.18).
14 de Mayo de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA MARQUEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 121, S 8, H PO 27278, I/A121 ( 4.05.18).
10 de Abril de 2018Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ MARTINEZ JUAN. Apo.Man.Soli: BELENGUER SALVADOR RAFAELENRIQUE;GONZALEZ MARTINEZ JUAN. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 121, S 8, H PO 27278, I/A 120 ( 2.04.18).
01 de Marzo de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 121, S 8, H PO 27278, I/A119 (21.02.18).
07 de Febrero de 2018Pérdida del caracter de unipersonalidad. Ampliación de capital. Suscrito: 1.999.000,00 Euros. Desembolsado: 1.999.000,00Euros. Resultante Suscrito: 2.300.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 2.300.000,00 Euros. Datos registrales. T 4203, L 4203, F120, S 8, H PO 27278, I/A 118 ( 1.02.18).
20 de Diciembre de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: TURREZ IBARZABAL JOSE MARIA;ESCLAPES DIAZ ALBERTO;MANZANARES BALLESTEROS EVA.Datos registrales. T 4203, L 4203, F 120, S 8, H PO 27278, I/A 117 (11.12.17).
02 de Noviembre de 2017Nombramientos. Apoderado: CORRALES SANZ SALVADOR MARIA. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 120, S 8, H PO 27278,I/A 116 (25.10.17).
24 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: SEGUI CANDELA MARIA AMPARO. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 225, S 8, H PO 27278, I/A115 (14.07.17).
05 de Junio de 2017Revocaciones. Apoderado: HERRERA BERROCAL JOAQUIN. Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ VAZQUEZ-DODEROJORGE. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 224, S 8, H PO 27278, I/A 114 (26.05.17).
11 de Abril de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ PERIAGO PABLO;GAMALLO RODRIGUEZ JOSE GERMAN. Datos registrales. T 2638, L 2638,F 224, S 8, H PO 27278, I/A 113 ( 4.04.17).
23 de Marzo de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: DE DIEGO GONZALEZ BALTASAR. Nombramientos. Consejero: ORTEGA TAMAYOOLGA;RAIMUNDEZ JUSTO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 224, S 8, H PO 27278, I/A 111 (13.03.17).
Revocaciones. Apoderado: QUINTANA ROIG MONICA. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 224, S 8, H PO 27278, I/A 112(13.03.17).
10 de Marzo de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ ALONSO SANDRA. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 223, S 8, H PO 27278, I/A 110(28.02.17).
09 de Marzo de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: ALONSO GOMEZ ANA ISABEL. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 223, S 8, H PO 27278, I/A 109(28.02.17).
13 de Enero de 2017Revocaciones. Apoderado: DIANEZ CARAME SALVADOR;DE LA RIERA AUTRAN ALEJANDRO. Apo.Sol.: DE LA RIERA AUTRANALEJANDRO;DE LA RIERA AUTRAN ALEJANDRO. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 223, S 8, H PO 27278, I/A 106 ( 4.01.17).
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ PEIRAGO PABLO. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 223, S 8, H PO 27278, I/A 107 (4.01.17).
Nombramientos. Apoderado: ANTEQUERA GOMEZ SUSANA. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 223, S 8, H PO 27278, I/A 108( 4.01.17).
23 de Diciembre de 2016Nombramientos. Auditor: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 222, S 8, H PO27278, I/A 105 (13.12.16).
26 de Julio de 2016Nombramientos. Apoderado: SOLER VALLESPIN FEDERICO. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 222, S 8, H PO 27278, I/A 104(18.07.16).
08 de Julio de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: CAMPOS DOMINGUEZ MARIA ELENA. Nombramientos. Apo.Manc.: PEÑA GONZALEZ-CONCHEIRO NELY;MARTINEZ PORTELA ROSA. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 221, S 8, H PO 27278, I/A 102 (29.06.16).
Nombramientos. Apo.Manc.: LOPEZ GIMENO HELENA. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 222, S 8, H PO 27278, I/A 103(29.06.16).
24 de Junio de 2016Nombramientos. Apoderado: CASTRO SUAREZ MARTA-MARIA. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 221, S 8, H PO 27278, I/A101 (16.06.16).
03 de Junio de 2016Nombramientos. Apoderado: SOLER VALLESPIN FEDERICO. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 221, S 8, H PO 27278, I/A 100(26.05.16).
25 de Mayo de 2016Nombramientos. Apoderado: QUINTANA ROIG MONICA. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 220, S 8, H PO 27278, I/A 99(16.05.16).
04 de Abril de 2016Revocaciones. Apo.Manc.: MCHIRI SAMI;GALLARDO CANEDO MIGUEL. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 219, S 8, H PO27278, I/A 98 (23.03.16).
30 de Septiembre de 2015Nombramientos. Apoderado: HERRERA BERROCAL JOAQUIN. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 219, S 8, H PO 27278, I/A 96(22.09.15).
Revocaciones. Apo.Manc.: ORTEGA TAMAYO OLGA;TURREZ IBARZABAL JOSE MARIA;ALCARAZ RUIZ PILAR.Nombramientos. Apo.Manc.: ORTEGA TAMAYO OLGA;TURREZ IBARZABAL JOSE MARIA;DIEZ GIL LORENA. Datos registrales.T 2638, L 2638, F 219, S 8, H PO 27278, I/A 97 (22.09.15).
28 de Mayo de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: MARCELLO FERRARO SALVADOR. Apo.Man.Soli: BLANCO HERNANDEZ JOAQUIN. Datos registrales.
Nombramientos. Apoderado: MCHIRI SAMI. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 196, S 8, H PO 27278, I/A 95 (21.05.15).
14 de Mayo de 2015Revocaciones. Apoderado: CANTARELL PALAU RICARD. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 195, S 8, H PO 27278, I/A 91 (5.05.15).
Nombramientos. Apo.Sol.: MCHIRI SAMI. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 195, S 8, H PO 27278, I/A 92 ( 5.05.15).
Nombramientos. Apo.Manc.: GALLARDO CANEDO MIGUEL;MCHIRI SAMI. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 196, S 8, H PO27278, I/A 93 ( 5.05.15).
05 de Enero de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: ANDRINO MIRANDA BEATRIZ. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 195, S 8, H PO 27278, I/A 90(24.12.14).
17 de Octubre de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: CORRAL TRUJILLO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 195, S 8, H PO 27278,I/A 89 ( 9.10.14).
05 de Marzo de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: MARCELLO FERRARO SALVADOR. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 195, S 8, H PO 27278, I/A 88(20.02.14).
21 de Febrero de 2014Reelecciones. Auditor: ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 194, S 8, H PO 27278, I/A87 (13.02.14).
06 de Febrero de 2014Nombramientos. Apoderado: LAGE GOMEZ ALFONSO. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 194, S 8, H PO 27278, I/A 86(28.01.14).
03 de Septiembre de 2013Revocaciones. Apo.Sol.: MARTI ESQUIVA FRANCISCO. Apo.Man.Soli: MARTI ESQUIVA FRANCISCO. Datos registrales. T 2638,L 2638, F 194, S 8, H PO 27278, I/A 85 (27.08.13).
18 de Junio de 2013Revocaciones. Apoderado: PEREZ DEL MORAL CARLOS. Apo.Sol.: PEREZ DEL MORAL CARLOS. Apoderado: DENISE BULLOCKPATRICIA;MARTI ESQUIVA FRANCISCO. Apo.Manc.: TURREZ IBARZABAL JOSE MARIA;ALCARAZ RUIZ PILAR. Datosregistrales. T 2638, L 2638, F 194, S 8, H PO 27278, I/A 83 ( 3.06.13).
Nombramientos. Apo.Manc.: ORTEGA TAMAYO OLGA;TURREZ IBARZABAL JOSE MARIA;ALCARAZ RUIZ PILAR. Datosregistrales. T 2638, L 2638, F 194, S 8, H PO 27278, I/A 84 ( 3.06.13).
29 de Mayo de 2013Revocaciones. Apo.Manc.: VARO REYES JUAN;MARIÑO GARCIA JOSE LUIS. Apo.Man.Soli: FILGUEIRA IGLESIAS GERMAN.Apo.Sol.: FILGUEIRA IGLESIAS GERMAN;MARIÑO GARCIA JOSE LUIS;FILGUEIRA IGLESIAS GERMAN. Datos registrales. T2638, L 2638, F 192, S 8, H PO 27278, I/A 80 (21.05.13).
Nombramientos. Apo.Sol.: ANDRINO MIRANDA BEATRIZ. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 193, S 8, H PO 27278, I/A 81(21.05.13).
Nombramientos. Apo.Sol.: PEÑA GONZALEZ-CONCHEIRO NELY. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 193, S 8, H PO 27278, I/A82 (21.05.13).
17 de Mayo de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ SIERRA JOSE ENRIQUE. Cons.Del.Sol: GARCIA-MAURIÑO BRASCHI JAIMEMARIA;DAVILA VEGA EDUARDO. Nombramientos. Cons.Del.Sol: DAVILA VEGA EDUARDO;GARCIA-MAURIÑO BRASCHI JAIMEMARIA. Reelecciones. Consejero: DAVILA VEGA EDUARDO. Presidente: DAVILA VEGA EDUARDO. Consejero: DE DIEGOGONZALEZ BALTASAR;GARCIA-MAURIÑO BRASCHI JAIME MARIA. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 192, S 8, H PO 27278,I/A 79 ( 7.05.13).
11 de Abril de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: TROSKA FUERTES CHRISTIAN. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 191, S 8, H PO 27278, I/A 77 (3.04.13).
Nombramientos. Apo.Sol.: TROSKA FUERTES CHRISTIAN. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 191, S 8, H PO 27278, I/A 78 (3.04.13).
14 de Diciembre de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ANTONIO;RUIZ BERMEJO ANGEL. Datos registrales. T 2638, L2638, F 191, S 8, H PO 27278, I/A 76 ( 5.12.12).
20 de Noviembre de 2012Revocaciones. Apo.Man.Soli: SAURA LLORIA MANUEL;BELENGUER SALVADOR RAFAEL ENRIQUE. Apo.Sol.: TELLCREMADES CRISTINA. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 191, S 8, H PO 27278, I/A 74 ( 8.11.12).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTI ESQUIVA FRANCISCO;GONZALEZ MARTINEZ JUAN;BELENGUER SALVADOR RAFAELENRIQUE Datos registrales. T 2638, L 2638, F 191, S 8, H PO 27278, I/A 75 ( 8.11.12).
29 de Octubre de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: UGALDE ALLIKA KARMELE. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 189, S 8, H PO 27278, I/A 71(16.10.12).
Nombramientos. Apo.Sol.: VIYUELA CALVO MAIDER. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 190, S 8, H PO 27278, I/A 72(16.10.12).
Nombramientos. Apo.Sol.: UGALDE ALLIKA KARMELE. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 190, S 8, H PO 27278, I/A 73
09 de Octubre de 2012Otros conceptos: La sociedad traslada su domicilio social estableciéndolo enVigo (Pontevedra), Muelle de Reparaciones de Bouzass/n, edificio MARINA DAVILA SPORT, mofificándo en consecuencia el artículo 4º de los estatutos sociales. Cambio de domiciliosocial. MUELL MUELLE DE REPARACIONES DE BOUZAS, EDIFICIO M (VIGO). Datos registrales. T 2638, L 2638, F 189, S 8, HPO 27278, I/A 70 (28.09.12).
27 de Julio de 2012Revocaciones. Apo.Sol.: RUEDA GARCIA JUAN MANUEL. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 189, S 8, H PO 27278, I/A 69(17.07.12).
23 de Julio de 2012Revocaciones. Apoderado: RUEDA GARCIA JUAN MANUEL. Nombramientos. Apoderado: ANTEQUERA GOMEZ SUSANA.Datos registrales. T 2638, L 2638, F 188, S 8, H PO 27278, I/A 68 ( 9.07.12).
20 de Marzo de 2012Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ MARTINEZ JUAN. Datos registrales. T 2638, L 2638, F 188, S 8, H PO 27278, I/A 67 (7.03.12).
15 de Marzo de 2012Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ SIERRA JOSE ENRIQUE. Datos registrales. T 2580, L 2580, F 103, S 8, H PO 27278,I/A 66 ( 5.03.12).
10 de Febrero de 2012Nombramientos. Apoderado: DIANEZ CARAME SALVADOR. Datos registrales. T 2580, L 2580, F 103, S 8, H PO 27278, I/A 65(30.01.12).
18 de Agosto de 2011Nombramientos. Apoderado: DENISE BULLOCK PATRICIA. Datos registrales. T 2580, L 2580, F 162, S 8, H PO 27278, I/A 64 (3.08.11).
29 de Junio de 2011Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ANTONIO. Datos registrales. T 2580, L 2580, F 162, S 8, H PO27278, I/A 62 (16.06.11).
Nombramientos. Apo.Manc.: ANTEQUERA GOMEZ SUSANA;VARO REYES JUAN. Datos registrales. T 2580, L 2580, F 162, S 8,H PO 27278, I/A 63 (16.06.11).
17 de Mayo de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: DE LA RIERA AUTRAN ALEJANDRO;LOPEZ PEIRAGO PABLO;BAO FERNANDEZVANESA;FILGUEIRA IGLESIAS GERMAN. Datos registrales. T 2580, L 2580, F 162, S 8, H PO 27278, I/A 60 ( 5.05.11).
Nombramientos. Apo.Sol.: TELL CREMADES CRISTINA. Datos registrales. T 2580, L 2580, F 162, S 8, H PO 27278, I/A 61 (5.05.11).
05 de Mayo de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: COCA LASSO DE LA VEGA JAVIER. Datos registrales. T 2580, L 2580, F 160, S 8, H PO 27278, I/A 53(25.04.11).
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTI ESQUIVA FRANCISCO. Datos registrales. T 2580, L 2580, F 160, S 8, H PO 27278, I/A 54(25.04.11).
Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ DEL MORAL CARLOS. Datos registrales. T 2580, L 2580, F 161, S 8, H PO 27278, I/A 55(25.04.11).
Nombramientos. Apo.Sol.: DE LA RIERA AUTRAN ALEJANDRO;LOPEZ PEIRAGO PABLO;BAO FERNANDEZVANESA;FILGUEIRA IGLESIAS GERMAN. Datos registrales. T 2580, L 2580, F 161, S 8, H PO 27278, I/A 56 (25.04.11).
Nombramientos. Apo.Sol.: RUEDA GARCIA JUAN MANUEL;ANTEQUERA GOMEZ SUSANA;VARO REYES JUAN;DURAN LERMACARMEN. Datos registrales. T 2580, L 2580, F 161, S 8, H PO 27278, I/A 57 (25.04.11).
Nombramientos. Apo.Sol.: MARIÑO GARCIA JOSE LUIS. Datos registrales. T 2580, L 2580, F 161, S 8, H PO 27278, I/A 58(25.04.11).
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO;GARCIA DURAN JOSE CARLOS;ESTEBAN RICO MARTA.Datos registrales. T 2580, L 2580, F 161, S 8, H PO 27278, I/A 59 (25.04.11).
03 de Febrero de 2011Nombramientos. Auditor: ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL. Datos registrales. T 2580, L 2580, F 160, S 8, H PO 27278,I/A 52 (24.01.11).
13 de Octubre de 2010Nombramientos. Apoderado: ESTEBAN RICO MARTA. Datos registrales. T 2580, L 2580, F 159, S 8, H PO 27278, I/A 50(30.09.10).
Revocaciones. Apoderado: CARAZO GOMEZ JULIAN. Datos registrales. T 2580, L 2580, F 160, S 8, H PO 27278, I/A 51(30.09.10).
12 de Mayo de 2010Nombramientos. Apoderado: QUINTANA CASTAÑO MARIA ROSARIO. Datos registrales. T 2580, L 2580, F 159, S 8, H PO27278, I/A 49 (28.04.10).
24 de Febrero de 2010Revocaciones. Apoderado: CARRASCO VALLADOLID CLAUDIO. Datos registrales. T 2580, L 2580, F 159, S 8, H PO 27278, I/A48 ( 2.02.10).