Actos BORME de Aegon Mediacion Sl
02 de Noviembre de 2023Nombramientos. VsecrNoConsj: MESTRALLET SANCHEZ IGNACIO. Datos registrales. T 35647 , F 113, S 8, H M 497460, I/A 27(25.10.23).
05 de Octubre de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 6.906.708,41 Euros. Resultante Suscrito: 566.729,65 Euros. Datos registrales. T 35647 ,F 112, S 8, H M 497460, I/A 26 (28.09.22).
16 de Agosto de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 613.345,93 Euros. Resultante Suscrito: 7.473.438,06 Euros. Datos registrales. T 35647 ,F 112, S 8, H M 497460, I/A 25 ( 8.08.22).
27 de Julio de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.247.809,01 Euros. Resultante Suscrito: 8.086.783,99 Euros. Datos registrales. T 35647, F 111, S 8, H M 497460, I/A 24 (19.07.22).
21 de Diciembre de 2020Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del art铆culo 12 de los Estatutos Sociales . Datos registrales. T 35647 , F 111, S 8, H M497460, I/A 23 (14.12.20).
14 de Enero de 2020Modificaciones estatutarias. Modificados los art铆culos 6, 7 y 8 de los estatutos sociales.. Ampliacion del objeto social. AGENTEDE ENTIDADES DE CREDITO O DE EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSION EN LOS TERMINOS Y CONDICIONESESTABLECIDOS EN LA LEGISLACION VIGENTE. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: CAVANILLES SA. Datosregistrales. T 35647 , F 103, S 8, H M 497460, I/A 22 ( 7.01.20).
21 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: PASCAR SIMONA MARIA;RUBIO MU脩OZ MARIA KATIA. Datos registrales. T 35647 , F 103, S 8, H M497460, I/A 21 (14.11.19).
26 de Junio de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: AEGON ESPA脩A SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGU;AEGON ACTIVOSSA;CAVANILLES SA. Presidente: AEGON ESPA脩A SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGU. Cons.Del.Sol: AEGONESPA脩A SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGU;CAVANILLES SA. Representan: AZURMENDI UBARRECHENA JOSERAMON;BORRERO MAYORA BORJA;CENTENO GARCIA HORACIO. Nombramientos. Consejero: CENTENO GARCIAHORACIO;AZURMENDI UBARRECHENA JOSE RAMON;BORRERO MAYORA BORJA. Presidente: CENTENO GARCIA HORACIO.Cons.Del.Sol: CENTENO GARCIA HORACIO;AZURMENDI UBARRECHENA JOSE RAMON. Datos registrales. T 35647 , F 102, S8, H M 497460, I/A 20 (19.06.19).
25 de Junio de 2019Fe de erratas: Se public贸 por error en la inscripci贸n 18陋 el cese de AEGON ACTIVOS SA como consejero, debiendo quedar vigente.Datos registrales. T 35647 , F 102, S 8, H M 497460, I/A 18 ( 8.10.18).
08 de Noviembre de 2018Ceses/Dimisiones. Representan: DE LEEUW RONALD. Nombramientos. Representan: CENTENO GARCIA HORACIO. Datosregistrales. T 35647 , F 102, S 8, H M 497460, I/A 19 (31.10.18).
17 de Octubre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: AEGON ACTIVOS A.V. SA. Cons.Del.Sol: AEGON ACTIVOS A.V. SA. Nombramientos.Cons.Del.Sol: CAVANILLES SA. Datos registrales. T 35647 , F 102, S 8, H M 497460, I/A 18 ( 8.10.18).
15 de Octubre de 2018Ceses/Dimisiones. Representan: ARECHAGA LOPEZ SANTIAGO. Nombramientos. Representan: BORRERO MAYORA BORJA.Datos registrales. T 35647 , F 101, S 8, H M 497460, I/A 17 ( 4.10.18).
27 de Junio de 2018Cambio de objeto social. La Prestaci贸n de servicios de marketing directo, telemarketing y asesoramiento en marketing y la aperturade nuevas l铆neas de negocio. - La consultor铆a, selecci贸n de personal, asesoramiento, formaci贸n, instrucci贸n y ense帽anza de empresasy sus mandos intermedios y directivos, as铆 como, la ... Datos registrales. T 35647 , F 101, S 8, H M 497460, I/A 16 (20.06.18).
17 de Julio de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 10.990.306,12 Euros. Resultante Suscrito: 344.286,88 Euros. Ampliaci贸n de capital.Capital: 10.990.306,12 Euros. Resultante Suscrito: 11.334.593,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5.Capital social.-. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datos registrales. T 35647 , F 100, S 8, H M 497460, I/A 15 ( 7.07.17).
16 de Marzo de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: MOTILLA RUBIA MARIA ESPERANZA. Datos registrales. T 27604 , F 129, S 8, H M 497460, I/A 14( 9.03.17).
28 de Noviembre de 2016Cambio de domicilio social. VIA DE LOS POBLADOS 3 (MADRID). Datos registrales. T 27604 , F 129, S 8, H M 497460, I/A 13(18.11.16).
24 de Noviembre de 2016Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: URBANO JIMENEZ JAVIER. VsecrNoConsj: MOTILLA RUBIA MARIA ESPERANZA.Nombramientos. SecreNoConsj: MOTILLA RUBIA MARIA ESPERANZA. VsecrNoConsj: PUERTAS DIAZ NATALIA. Datosregistrales. T 27604 , F 129, S 8, H M 497460, I/A 12 (16.11.16).
02 de Noviembre de 2016Nombramientos. Apoderado: AEGON ADMINISTRACION Y SERVICIOS AIE. Datos registrales. T 27604 , F 126, S 8, H M 497460,I/A 10 (21.10.16).
Revocaciones. Apoderado: LARA PIZARRO FRANCISCO JOSE;PLAZA LOPEZ-BERGES MARIO. Datos registrales. T 27604 , F129, S 8, H M 497460, I/A 11 (21.10.16).
14 de Junio de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GONZALEZ PEREZ SAUL. Nombramientos. SecreNoConsj: URBANO JIMENEZ JAVIER.VsecrNoConsj: MOTILLA RUBIA MARIA ESPERANZA. Consejero: AEGON ESPA脩A SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS YREASEGU;AEGON ACTIVOS A.V. SA;CAVANILLES SA. Presidente: AEGON ESPA脩A SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS YREASEGU. Cons.Del.Sol: AEGON ESPA脩A SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGU;AEGON ACTIVOS A.V. SA.Representan: AZURMENDI UBARRECHENA JOSE RAMON;DE LEEUW RONALD;ARECHAGA LOPEZ SANTIAGO. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 27604 , F125, S 8, H M 497460, I/A 9 ( 6.06.16).
05 de Mayo de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 7.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 11.334.593,00 Euros. Datos registrales. T 27604 , F 125,S 8, H M 497460, I/A 8 (26.04.16).
29 de Abril de 2016Nombramientos. Apoderado: PLAZA LOPEZ-BERGES MARIO. Datos registrales. T 27604 , F 124, S 8, H M 497460, I/A 7(22.04.16).
25 de Noviembre de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.331.587,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.334.593,00 Euros. Datos registrales. T 27604 , F 124, S8, H M 497460, I/A 6 (17.11.15).
16 de Marzo de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.003.006,00 Euros. Datos registrales. T 27604 , F 123, S8, H M 497460, I/A 5 ( 9.03.15).