Actos BORME de Aeriam Technologies Sl
26 de Julio de 2022P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: PADILLA GOMEZ GUILLAMON VICENTE;GOMEZ-GUILLAMON MANRIQUE ANTONIO. Revocaciones. Apoderado: TORRES CASADO DE AMEZUA DANIEL;TORRES CASADO DEAMEZUA DANIEL;MARTOS MARTINEZ EVA;MARTIN ORTEGA FERNANDO MANUEL. Apo.Man.Soli: TORRES CASADO DEAMEZUA DANIEL;MARS LAURENCE MARIE ISABELLE CLAUDE BLANPAIN LE BO. Apo.Manc.: ZAFRA IBA脩EZ ANTONIOJESUS;MARS LAURENCE MARIE ISABELLE CLAUDE BLANPAIN LE BO;TORRES CASADO DE AMEZUA DANIEL. Disoluci贸n.Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 5624, L 4531, F 122, S 8, H MA 66778, I/A 15 (12.07.22).
06 de Junio de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: TORRES CASADO DE AMEZUA DANIEL. Apo.Manc.: ZAFRA IBA脩EZ ANTONIO JESUS;MARSLAURENCE MARIE ISABELLE CLAUDE BLANPAIN LE BO. Datos registrales. T 3429, L 2341, F 166, S 8, H MA 66778, I/A 13(23.05.17).
31 de Mayo de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARS LAURENCE MARIE ISABELLE CLAUDE BLANPAIN LE BO. Apo.Manc.: TORRES CASADODE AMEZUA DANIEL. Datos registrales. T 5624, L 4531, F 122, S 8, H MA 66778, I/A 14 (23.05.17).
19 de Enero de 2017Cambio de domicilio social. AVDA JUAN LOPEZ DE PE脩ALVER 17 (MALAGA). Datos registrales. T 3429, L 2341, F 166, S 8, HMA 66778, I/A 12 ( 9.01.17).
04 de Agosto de 2015Revocaciones. Apoderado: MARTIN ORTEGA FERNANDO MANUEL. Nombramientos. Apoderado: MARTIN ORTEGAFERNANDO MANUEL. Datos registrales. T 3429, L 2341, F 165, S 8, H MA 66778, I/A 11 (27.07.15).
15 de Junio de 2015Nombramientos. Apoderado: TORRES CASADO DE AMEZUA DANIEL. Datos registrales. T 3429, L 2341, F 165, S 8, H MA66778, I/A 9 ( 3.06.15).
11 de Junio de 2015Nombramientos. Apoderado: MARTOS MARTINEZ EVA. Datos registrales. T 3429, L 2341, F 165, S 8, H MA 66778, I/A 10 (3.06.15).
10 de Abril de 2015Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: AERTEC INGENIERIA Y DESARROLLOS SL. Datos registrales. T 3429, L 2341, F164, S 8, H MA 66778, I/A 8 (27.03.15).
04 de Julio de 2014Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 7.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 92.500,00 Euros. Datos registrales. T 3429, L 2341,F 164, S 8, H MA 66778, I/A 7 (25.06.14).
26 de Febrero de 2014Nombramientos. Auditor: AB INTEGRO SL. Datos registrales. T 3429, L 2341, F 164, S 8, H MA 66778, I/A 6 (17.02.14).
30 de Julio de 2013Nombramientos. Apoderado: TORRES CASADO DE AMEZUA DANIEL. Datos registrales. T 3429, L 2341, F 164, S 8, H MA66778, I/A 5 (19.07.13).
17 de Agosto de 2011Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SANCHEZ PEREZ PEDRO PABLO. Nombramientos. Adm. Solid.: PADILLA GOMEZ-GUILLAMONVICENTE;GOMEZ-GUILLAMON MANRIQUE ANTONIO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n:Administrador 煤nico a Administradores solidarios. Datos registrales. T 3429, L 2341, F 164, S 8, H MA 66778, I/A 4 ( 2.08.11).