Actos BORME de Aeronaval De Construcciones E Instalaciones Sa
05 de Diciembre de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ VICO MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ VICO MIGUEL ANGEL.Datos registrales. T 41517 , F 131, S 8, H M 39125, I/A 255 (28.11.23).
Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ ROMERO ALFONSO. Otros conceptos: Revocado el poder conferido por la inscripci贸n136, 236 y 242 a don Alfonso Fern谩ndez Romero, el 28 de julio de 2023. Datos registrales. T 41517 , F 132, S 8, H M 39125, I/A 256(28.11.23).
01 de Diciembre de 2023Nombramientos. Apoderado: BALMASEDA RUIZ VALDEPE脩AS MONTSERRAT. Datos registrales. T 41517 , F 130, S 8, H M39125, I/A 253 (24.11.23).
Nombramientos. Apoderado: GUERRERO CORDERO JOSE MARIA;APARICIO MORENO MARIA SOLEDAD. Datos registrales. T41517 , F 131, S 8, H M 39125, I/A 254 (24.11.23).
15 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: JIMENEZ NU脩EZ JAVIER. Datos registrales. T 41517 , F 129, S 8, H M 39125, I/A 251 ( 7.11.23).
Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ ROMERO ALFONSO;SOENGAS GARCIA ADOLFO. Apo.Sol.: PEREZ RODRIGUEZBENJAMIN. Apo.Manc.: QUAN LIN;FERNANDEZ ROMERO ALFONSO. Datos registrales. T 41517 , F 130, S 8, H M 39125, I/A 252( 7.11.23).
26 de Septiembre de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ HERNANDO IVAN. Apoderado: DE LA TORRE GALINDO JUAN-JOSE. Apo.Sol.: FLETESRINCON JOSE DAVID. Apoderado: FLETES RINCON JOSE DAVID. Apo.Sol.: FLETES RINCON JOSE DAVID. Apo.Manc.: ALONSOVENA JOAQUIN;FLETES RINCON JOSE DAVID. Apoderado: ALONSO VENA JOAQUIN. Datos registrales. T 41517 , F 128, S 8, HM 39125, I/A 250 (19.09.23).
19 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: CUERVO GONZALEZ MARIA BALBINA;PI脩ERO MARTIN INMACULADA;ZARAGOZA GONZALEZSILVIA. Datos registrales. T 41517 , F 126, S 8, H M 39125, I/A 249 (12.09.23).
15 de Junio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: ZHENG QI. Datos registrales. T 41517 , F 125, S 8, H M 39125, I/A 247 ( 8.06.23).
31 de Mayo de 2023Fe de erratas: Se publicaron por error los apoderados de la inscripci贸n 201 como Mancomunados, siendo lo correcto, APODERADOSSOLIDARIOS. Datos registrales. T 28091 , F 69, S 8, H M 39125, I/A 201 (16.05.19).
09 de Mayo de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: ARGUELLES DE BUSTILLO JOSE MARIA;FERNANDEZ RUIZ MATILDE;FERNANDEZ RUIZ MATILDE.Apo.Manc.: ARGUELLES DE BUSTILLO JOSE MARIA;GARCIA RAMIREZ MANUEL. Datos registrales. T 41517 , F 124, S 8, H M39125, I/A 246 ( 2.05.23).
31 de Marzo de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: FERNANDEZ ROMERO ALFONSO. Nombramientos. Adm. Mancom.: ZHENG QI. Datosregistrales. T 41517 , F 124, S 8, H M 39125, I/A 245 (24.03.23).
15 de Febrero de 2023Otros conceptos: Rectificaci贸n de la inscripci贸n 241潞 en cuanto a la facultad n煤mero 4. Datos registrales. T 41517 , F 123, S 8, H M39125, I/A 244 ( 8.02.23).
24 de Enero de 2023Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 60,10 Euros. Desembolsado: 60,10 Euros. Resultante Suscrito: 1.262.160,10 Euros. ResultanteDesembolsado: 1.262.160,10 Euros. Datos registrales. T 41517 , F 123, S 8, H M 39125, I/A 243 (17.01.23).
09 de Enero de 2023Otros conceptos: Se acuerda anular la revocaci贸n y revertir los poderes que fueron revocados en virtud de la escritura que caus贸 lainscripci贸n 240陋 de la hoja social.. En virtud de lo anterior se revierten los poderes que fueron conferidos en escrituras que causaronlas inscripciones 166陋, 207陋, 213陋, y 216陋. Datos registrales. T 41517 , F 122, S 8, H M 39125, I/A 242 (30.12.22).
23 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: LANA HERNANDEZ FERNANDO. Nombramientos. Apo.Sol.: LANA HERNANDEZ FERNANDO. Datosregistrales. T 41517 , F 121, S 8, H M 39125, I/A 241 (16.12.22).
12 de Diciembre de 2022Fe de erratas: Se public贸 por error en la inscripci贸n 240陋 la revocci贸n del poder solidario de FERNANDEZ RUIZ MATILDE y el podersolid, y mancom. de ALONSO VENA JOAQUIN, siendo solo la revocaci贸n como mancom. quedando como solidario en la inscr. 216陋.Datos registrales. T 41517 , F 120, S 8, H M 39125, I/A 240 (21.11.22).
Otros conceptos: La revocaci贸n del poder conferido a favor de don Joaqu铆n Alonso Vena y do帽a Matilde Fernandez Ruiz por lainscripci贸n 240陋, lo es 煤nicamente en cuanto a las facultades conferidas con caracter mancomunado, en el acuerdo segundo de lasinscripciones 216陋 y 213陋 repectivamente. Datos registrales. T 41517 , F 120, S 8, H M 39125, I/A 240 (21.11.22).
28 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA RAMIREZ MANUEL;SANCHEZ DUE脩AS RUBEN MANUEL;NU脩EZ MORENOFELIX;FERNANDEZ ROMERO ALFONSO;CANTERO GARCIA JUAN CARLOS;FRIAS CHICHARRO SARA;ARGUELLES DEBUSTILLO JOSE MARIA;VAZQUEZ ALVAREZ JORGE;PALLARES MORANO MARIA LUISA;COBO ESPEJO JESUS. Apoderado:MEDIAVILLA MARTIN MARIA DE LOS ANGELES. Apo.Sol.: FERNANDEZ RUIZ MATILDE. Apo.Manc.: FERNANDEZ RUIZ MATILDE.Apo.Man.Soli: ALONSO VENA JOAQUIN. Datos registrales. T 41517 , F 120, S 8, H M 39125, I/A 240 (21.11.22).
23 de Noviembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: ZHANG YING. Datos registrales. T 41517 , F 119, S 8, H M 39125, I/A 239 (16.11.22).
04 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: BERROCAL CASQUERO JORGE. Apo.Manc.: BERROCAL CASQUERO JORGE. Nombramientos.Apo.Sol.: BERROCAL CASQUERO JORGE;BERROCAL CASQUERO JORGE. Datos registrales. T 41517 , F 119, S 8, H M 39125,I/A 238 (27.10.22).
03 de Octubre de 2022Nombramientos. Apoderado: COBO ESPEJO JESUS. Datos registrales. T 41517 , F 118, S 8, H M 39125, I/A 237 (26.09.22).
26 de Septiembre de 2022Nombramientos. Apo.Manc.: BERROCAL CASQUERO JORGE;PALLARES MORA脩O MARIA LUISA;MEDIAVILLA MARTIN MARIAANGELES;ALONSO VENA JOAQUIN;ZHANG YING;QUAN LIN;AIMIN JIANG;ZHANG YOUYOU;FERNANDEZ ROMEROALFONSO;CANTERO GARCIA JUAN CARLOS;FRIAS CHICHARRO SARA;ARGUELLES DE BUSTILLO JOSE MARIA;RAMOSGARCIA LUIS;COBO ESPEJO JESUS;VAZQUEZ ALVAREZ JORGE;REY GOMEZ GUILLERMO;FLETES RINCON JOSEDAVID;GARCIA RAMIREZ MANUEL;SANCHEZ DUE脩AS RUBEN MANUEL;NU脩EZ MORENO FELIX. Datos registrales. T 41517 ,F 117, S 8, H M 39125, I/A 236 (19.09.22).
20 de Septiembre de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GARCIA RAMIREZ MANUEL. Nombramientos. Adm. Mancom.: FERNANDEZ ROMEROALFONSO. Reelecciones. Adm. Mancom.: NU脩EZ MORENO FELIX. Datos registrales. T 41517 , F 117, S 8, H M 39125, I/A 235(13.09.22).
03 de Mayo de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: POU YA脩EZ JUAN MIGUEL. Nombramientos. Apo.Sol.: CARRERA CARRERO JOSE ANTONIO. Datosregistrales. T 41517 , F 116, S 8, H M 39125, I/A 234 (25.04.22).
29 de Abril de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA YEBRA RAUL. Datos registrales. T 41517 , F 116, S 8, H M 39125, I/A 233 (22.04.22).
08 de Marzo de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRERO CORDERO JOSE MARIA. Datos registrales. T 41517 , F 115, S 8, H M 39125, I/A 231 (1.03.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRERO CORDERO JOSE MARIA. Datos registrales. T 41517 , F 115, S 8, H M 39125, I/A 232 (1.03.22).
11 de Febrero de 2022Nombramientos. Apoderado: LANDAZURI PLAZA MARIA BEGO脩A. Datos registrales. T 41517 , F 114, S 8, H M 39125, I/A 229 (4.02.22).
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ ROMERO RUBEN. Datos registrales. T 41517 , F 114, S 8, H M 39125, I/A 230 ( 4.02.22).
18 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: ALDESA CONSTRUCCIONES SA;FLETES RINCON JOSE DAVID;BERROCAL CASQUEROJORGE;FERNANDEZ RUIZ MATILDE. Datos registrales. T 41517 , F 111, S 8, H M 39125, I/A 226 ( 8.10.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: REDONDO ARROYO JUAN MANUEL. Datos registrales. T 41517 , F 112, S 8, H M 39125, I/A 227 (8.10.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: TORRALBA VILLARROEL OLGA;TORRALBA VILLARROEL OLGA. Datos registrales. T 41517 , F 113,S 8, H M 39125, I/A 228 ( 8.10.21).
19 de Julio de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: QUINTERO BERGANZA FRANCISCO. Datos registrales. T 41517 , F 111, S 8, H M 39125, I/A 224(12.07.21).
Nombramientos. Apoderado: LANDAZURI PLAZA MARIA BEGO脩A. Datos registrales. T 41517 , F 111, S 8, H M 39125, I/A 225(12.07.21).
18 de Junio de 2021Nombramientos. Apoderado: FRIAS CHICHARRO SARA. Datos registrales. T 41517 , F 110, S 8, H M 39125, I/A 223 (11.06.21).
15 de Junio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: FLETES RINCON JOSE DAVID. Apoderado: FLETES RINCON JOSE DAVID. Datos registrales. T38726 , F 186, S 8, H M 39125, I/A 222 ( 8.06.21).
04 de Junio de 2021Nombramientos. Apoderado: GARCIA NATES MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 38726 , F 185, S 8, H M 39125, I/A 220(28.05.21).
Revocaciones. Apoderado: CANALO MENA MANUEL. Datos registrales. T 38726 , F 186, S 8, H M 39125, I/A 221 (28.05.21).
17 de Febrero de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA LOPEZ SERGIO. Apo.Sol.: GARCIA LOPEZ SERGIO;GARCIA LOPEZ SERGIO.Nombramientos. Apoderado: RANGEL GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 38726 , F 182, S 8, H M 39125, I/A
Nombramientos. Apoderado: SOLE PEREZ MARC;SOLE PEREZ MARC. Datos registrales. T 38726 , F 183, S 8, H M 39125, I/A218 (10.02.21).
Nombramientos. Apoderado: ANDREU SABATER LUCIANO. Datos registrales. T 38726 , F 185, S 8, H M 39125, I/A 219(10.02.21).
11 de Febrero de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALONSO VENA JOAQUIN. Datos registrales. T 38726 , F 181, S 8, H M 39125, I/A 216 ( 4.02.21).
01 de Diciembre de 2020Revocaciones. Apoderado: LOPEZ DE FORONDA PEREZ MIGUEL;LOPEZ DE FORONDA PEREZ MIGUEL;LOPEZ DE FORONDA
24 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: BERROCAL CASQUERO JORGE. Apo.Manc.: BERROCAL CASQUERO JORGE. Datos registrales. T38726 , F 180, S 8, H M 39125, I/A 214 (17.11.20).
19 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ RUIZ MATILDE. Apo.Manc.: FERNANDEZ RUIZ MATILDE. Datos registrales. T 38726 , F179, S 8, H M 39125, I/A 213 (12.11.20).
28 de Octubre de 2020Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 38726 , F 179, S 8, H M 39125,I/A 212 (21.10.20).
21 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: LANDAZURI PLAZA MARIA BEGO脩A. Datos registrales. T 38726 , F 178, S 8, H M 39125, I/A 211(14.08.20).
03 de Agosto de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ RODRIGUEZ BENJAMIN. Datos registrales. T 38726 , F 176, S 8, H M 39125, I/A 209(27.07.20).
Nombramientos. Apoderado: MONCADA CALLEJA JOSE LUIS. Datos registrales. T 38726 , F 177, S 8, H M 39125, I/A 210(27.07.20).
15 de Julio de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ RUIZ ISABEL;FERNANDEZ RUIZ MATILDE. Apoderado: LOPEZ DE FORONDA PEREZMIGUEL;FERNANDEZ RUIZ ALEJANDRO. Apo.Sol.: ARENAS BRUALLA JOSE LUIS. Datos registrales. T 38726 , F 176, S 8, H M39125, I/A 208 ( 8.07.20).
24 de Junio de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: PORRO HIDALGO PABLO. Nombramientos. Apoderado: MEDIAVILLA MARTIN MARIA DE LOSANGELES. Datos registrales. T 38726 , F 176, S 8, H M 39125, I/A 207 (17.06.20).
26 de Marzo de 2020Revocaciones. Apo.Manc.: PEDROSILLO MARTY PABLO. Datos registrales. T 38726 , F 175, S 8, H M 39125, I/A 206 (19.03.20).
04 de Marzo de 2020Revocaciones. Apoderado: DOMENECH REINOSO JAUME. Datos registrales. T 38726 , F 175, S 8, H M 39125, I/A 205(26.02.20).
25 de Octubre de 2019Revocaciones. Apo.Manc.: VAQUERO COLLADO RAUL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: PORRO HIDALGO PABLO. Datosregistrales. T 38726 , F 175, S 8, H M 39125, I/A 203 (18.10.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: IBA脩EZ CELADA ANTONIO. Datos registrales. T 38726 , F 175, S 8, H M 39125, I/A 204 (18.10.19).
24 de Junio de 2019Nombramientos. Apoderado: BOU RODRIGUEZ CRISTINA. Datos registrales. T 28091 , F 71, S 8, H M 39125, I/A 202 (17.06.19).
23 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Manc.: LANA HERNANDEZ FERNANDO;MARTINEZ VICO MIGUEL ANGEL;CUERVO GONZALEZ MARIABALBINA Datos registrales. T 28091 , F 69, S 8, H M 39125, I/A 201 (16.05.19).
03 de Mayo de 2019Revocaciones. Apoderado: LERIDA GARCIA RICARDO. Nombramientos. Apoderado: LERIDA GARCIA RICARDO. Datosregistrales. T 28091 , F 68, S 8, H M 39125, I/A 200 (24.04.19).
05 de Abril de 2019Nombramientos. Apoderado: DE LA LLAVE JAIME JOAQUIN BORJA. Datos registrales. T 28091 , F 67, S 8, H M 39125, I/A 199(29.03.19).
03 de Abril de 2019Revocaciones. Apoderado: CANALO MENA MANUEL. Nombramientos. Apoderado: CANALO MENA MANUEL. Datosregistrales. T 28091 , F 66, S 8, H M 39125, I/A 198 (27.03.19).
27 de Marzo de 2019Revocaciones. Apo.Manc.: CORDOBA FERNANDEZ JOSE. Datos registrales. T 28091 , F 66, S 8, H M 39125, I/A 197 (20.03.19).
15 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: DOMENECH REINOSO JAUME. Datos registrales. T 28091 , F 65, S 8, H M 39125, I/A 196 (8.03.19).
16 de Enero de 2019Revocaciones. Apoderado: SPOTTORNO ZULOAGA JUAN. Datos registrales. T 28091 , F 65, S 8, H M 39125, I/A 195 ( 8.01.19).
02 de Enero de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: GOMEZ PUCHE MARGARITA. Apoderado: DOMINGUEZ SANTOS JULIO. Datos registrales. T 28091 , F64, S 8, H M 39125, I/A 194 (24.12.18).
05 de Junio de 2018Nombramientos. Apoderado: SOENGAS GARCIA ADOLFO. Datos registrales. T 28091 , F 63, S 8, H M 39125, I/A 192 (29.05.18).
Revocaciones. Apoderado: BLANC GARCIA-VALCARCEL CARLOS. Apo.Manc.: TORRES PAREDES MIGUEL;DOMINGUEZSANTOS JULIO. Datos registrales. T 28091 , F 64, S 8, H M 39125, I/A 193 (29.05.18).
13 de Abril de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: PIRRETAS MARTI JORDI. Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 171陋 LAREVOCACION DEL PODER OTORGADO A POU YA脩EZ JUAN MIGUEL, SIENDO LO CORRECTO PIRRETAS MARTI JORDI.Datos registrales. T 28091 , F 63, S 8, H M 39125, I/A 191 (20.03.18).
28 de Marzo de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: POU YA脩EZ JUAN MIGUEL. Datos registrales. T 28091 , F 63, S 8, H M 39125, I/A 191 (20.03.18).
16 de Enero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: ARENAS BRUALLA JOSE LUIS. Datos registrales. T 28091 , F 61, S 8, H M 39125, I/A 187 ( 9.01.18).
Revocaciones. Apoderado: BURGOS BLANCO CONCEPCION. Nombramientos. Apo.Sol.: BERROCAL CASQUEROJORGE;GARCIA YEBRA RAUL. Datos registrales. T 28091 , F 61, S 8, H M 39125, I/A 188 ( 9.01.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA LOPEZ SERGIO. Datos registrales. T 28091 , F 62, S 8, H M 39125, I/A 189 ( 9.01.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: SANTACRUZ NAVARRO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 28091 , F 62, S 8, H M 39125, I/A 190 (9.01.18).
13 de Diciembre de 2017Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 28091 , F 60, S 8, H M 39125, I/A 186 ( 1.12.17).
13 de Octubre de 2017Revocaciones. Apoderado: CAVIA BA脩ALES GERARDO. Datos registrales. T 28091 , F 60, S 8, H M 39125, I/A 185 ( 4.10.17).
04 de Septiembre de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: GUERRERO ALMAGRO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 28091 , F 59, S 8, H M 39125, I/A 183(28.08.17).
Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del art铆culo 4潞 y adici贸n del art铆culo 4潞 bis.. Ampliacion del objeto social. Proyecto,planificaci贸n y asesoramiento, fabricaci贸n, suministro, instalaci贸n, mantenimiento y explotaci贸n de aparatos, dispositivos y sistemas deseguridad anti-intrusismo, contraincendios, televisi贸n y cualquier otra actividad relacionada con la seguridad y protecci贸n de personas ocosas, etc. Datos registrales. T 28091 , F 59, S 8, H M 39125, I/A 184 (28.08.17).
31 de Agosto de 2017Revocaciones. Apoderado: CALDERON GONZALEZ ANTONIO;GARCIA NIEVES JOSE MARIA. Nombramientos. Apoderado:GARCIA NIEVES JOSE MARIA. Datos registrales. T 28091 , F 57, S 8, H M 39125, I/A 181 (23.08.17).
Nombramientos. Apoderado: CANALO MENA MANUEL. Datos registrales. T 28091 , F 58, S 8, H M 39125, I/A 182 (23.08.17).
30 de Agosto de 2017Nombramientos. Apoderado: CARDABA CALLEJO JAVIER;DE LA TORRE GALINDO JUAN-JOSE. Datos registrales. T 28091 , F56, S 8, H M 39125, I/A 180 (23.08.17).
30 de Junio de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: DIAZ RUIZ CESAR. Datos registrales. T 28091 , F 56, S 8, H M 39125, I/A 179 (23.06.17).
29 de Mayo de 2017Otros conceptos: SUBSANACION DE LA IDENTIDAD DEL APODERADO DON JORDI PIRRETAS MARTI, SIENDO LA CORRECTA"JORGE PIRRETAS MARTI". Datos registrales. T 28091 , F 55, S 8, H M 39125, I/A 176 (19.05.17).
Revocaciones. Apo.Sol.: BLAZQUEZ ALONSO CARLOS. Datos registrales. T 28091 , F 56, S 8, H M 39125, I/A 177 (19.05.17).
Revocaciones. Apo.Sol.: DUARTE I MACARRO ESTHER. Datos registrales. T 28091 , F 56, S 8, H M 39125, I/A 178 (19.05.17).
03 de Abril de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: POU YANEZ JUAN MIGUEL;SILVA GOMEZ OSCAR MANUEL. Nombramientos. Apo.Sol.: POU YA脩EZJUAN MIGUEL;PIRRETAS MARTI JORDI. Datos registrales. T 28091 , F 53, S 8, H M 39125, I/A 174 (27.03.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA LOPEZ SERGIO;GUERRERO ALMAGRO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 28091 , F 54, S8, H M 39125, I/A 175 (27.03.17).
29 de Marzo de 2017Nombramientos. Apoderado: SPOTTORNO ZULOAGA JUAN. Datos registrales. T 28091 , F 52, S 8, H M 39125, I/A 173(22.03.17).
21 de Marzo de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: LERIDA GARCIA RICARDO. Datos registrales. T 28091 , F 51, S 8, H M 39125, I/A 172 ( 9.03.17).
09 de Febrero de 2017Nombramientos. Apoderado: MENDEZ ESQUER MARIA ANGELES. Datos registrales. T 28091 , F 51, S 8, H M 39125, I/A 171(31.01.17).
24 de Enero de 2017Nombramientos. Apoderado: CAVIA BA脩ALES GERARDO. Datos registrales. T 28091 , F 47, S 8, H M 39125, I/A 167 (17.01.17).
Nombramientos. Apoderado: REY GOMEZ GUILLERMO. Datos registrales. T 28091 , F 48, S 8, H M 39125, I/A 168 (17.01.17).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ RUIZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 28091 , F 49, S 8, H M 39125, I/A 169(17.01.17).
Nombramientos. Apoderado: BURGOS BLANCO CONCEPCION. Datos registrales. T 28091 , F 51, S 8, H M 39125, I/A 170(17.01.17).
02 de Enero de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: CANTERO GARCIA JUAN CARLOS;FERNANDEZ ROMERO ALFONSO;DOMINGUEZ SANTOSJULIO;LOPEZ DE FORONDA PEREZ MIGUEL;BLANC GARCIA VALCARCEL CARLOS;PALLARES MORA脩O MARIALUISA;ALONSO VENA JOAQUIN. Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA RAMIREZ MANUEL;TORRES PAREDESMIGUEL;SANCHEZ DUE脩AS RUBEN MANUEL;NU脩EZ MORENO FELIX;FERNANDEZ ROMERO ALFONSO;CANTERO GARCIAJUAN CARLOS;FRIAS CHICHARRO SARA;QUINTERO BERGANZA FRANCISCO;CORDOBA FERNANDEZ JOSE;ARGUELLES DEBUSTILLO JOSE MARIA;PEDROSILLO MARTY PABLO;VAZQUEZ ALVAREZ JORGE;GARCIA LOPEZ SERGIO;DOMINGUEZSANTOS JULIO;LOPEZ DE FORONDA PEREZ MIGUEL;PALLARES MORANO MARIA LUISA;VAQUERO COLLADO RAUL;COBOESPEJO JESUS. Datos registrales. T 28091 , F 46, S 8, H M 39125, I/A 166 (23.12.16).
15 de Diciembre de 2016Nombramientos. Apoderado: LERIDA GARCIA RICARDO. Datos registrales. T 28091 , F 45, S 8, H M 39125, I/A 165 ( 7.12.16).
14 de Diciembre de 2016Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28091 , F 45, S 8, H M 39125, I/A 164 ( 5.12.16).
16 de Noviembre de 2016Revocaciones. Apo.Sol.: SOLORZANO FERNANDEZ JOAQUIN. Nombramientos. Apo.Sol.: SILVA GOMEZ OSCAR MANUEL.Datos registrales. T 28091 , F 44, S 8, H M 39125, I/A 163 ( 8.11.16).
17 de Octubre de 2016Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: VEGA SORROSAL LUIS. SecreNoConsj: FERNANDEZ RUIZ ISABEL. Consejero: ALDESACONSTRUCCIONES SA;ALDESA AGRUPACION EMPRESARIAL SA. Presidente: ALDESA AGRUPACION EMPRESARIAL SA.Con.Delegado: ALDESA CONSTRUCCIONES SA. Consejero: ALDESA CONCESIONES SL. Representan: NU脩EZ MORENO FELIXJOSE;FERNANDEZ RUIZ ALEJANDRO;FERNANDEZ ROMERO ALFONSO. Nombramientos. Adm. Mancom.: GARCIA RAMIREZMANUEL;NU脩EZ MORENO FELIX. Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS LOS ARTICULOS 14, 23, 26, 28 Y 29 DE LOSESTATUTOS SOCIALES.. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradoresmancomunados. Datos registrales. T 28091 , F 43, S 8, H M 39125, I/A 162 ( 6.10.16).
01 de Julio de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: BLAZQUEZ ALONSO CARLOS. Datos registrales. T 28091 , F 42, S 8, H M 39125, I/A 161 (23.06.16).
07 de Junio de 2016Revocaciones. Apoderado: BLANC GARCIA-VALCARCEL CARLOS. Datos registrales. T 28091 , F 42, S 8, H M 39125, I/A 160(31.05.16).
10 de Marzo de 2016Nombramientos. Apoderado: NU脩EZ MORENO FELIX. Datos registrales. T 28091 , F 41, S 8, H M 39125, I/A 159 ( 2.03.16).
10 de Febrero de 2016Nombramientos. Apoderado: LOPEZ DE FORONDA PEREZ MIGUEL. Datos registrales. T 28091 , F 40, S 8, H M 39125, I/A 158 (3.02.16).
28 de Enero de 2016Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: ALDESA INGENIERIA Y SERVICIOS SA. Datos registrales. T 28091 , F 38, S 8, HM 39125, I/A 157 (21.01.16).
27 de Enero de 2016Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28091 , F 38, S 8, H M 39125, I/A 156 (20.01.16).
16 de Diciembre de 2015Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: AGRUPACION EMPRESAS AUTOMATISMOS MONTAJES Y SERVIC. Datosregistrales. T 28091 , F 35, S 8, H M 39125, I/A 155 ( 7.12.15).
01 de Septiembre de 2015Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 154& EL NOMBRAMIENTO COMO REPRESENTANTE DEFERNANDEZ RUIZ ALEJANDRO, SIENDO LO CORRECTO FERNANDEZ ROMERO ALFONSO. Datos registrales. T 28091 , F 35,S 8, H M 39125, I/A 154 (23.07.15).
30 de Julio de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: ALDESA INGENIERIA Y SERVICIOS SA. Representan: FERNANDEZ ROMERO ALFONSO.Nombramientos. Consejero: ALDESA CONCESIONES SL. Representan: FERNANDEZ RUIZ ALEJANDRO. Vicesecret.: VEGASORROSAL LUIS. Datos registrales. T 28091 , F 35, S 8, H M 39125, I/A 154 (23.07.15).
06 de Marzo de 2015Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: FERNANDEZ RUIZ MATILDE. Nombramientos. SecreNoConsj: FERNANDEZ RUIZ ISABEL.Datos registrales. T 28091 , F 34, S 8, H M 39125, I/A 153 (26.02.15).
04 de Marzo de 2015Ceses/Dimisiones. Representan: FERNANDEZ RUIZ ISABEL. Nombramientos. Representan: NU脩EZ MORENO FELIX JOSE.Datos registrales. T 28091 , F 34, S 8, H M 39125, I/A 152 (20.02.15).
23 de Diciembre de 2014Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28091 , F 34, S 8, H M 39125, I/A 151 (16.12.14).
09 de Diciembre de 2014Revocaciones. Apo.Sol.: LOPEZ DE LA CUADRA VALLE. Apoderado: CRUZ MOYA JULIO JOSE. Apo.Sol.: MARTIN PALACINJOSE LUIS;ESPASANDIN BLASCO JOSE MIGUEL;NU脩EZ TORREIRO ELENA. Datos registrales. T 28091 , F 33, S 8, H M 39125,I/A 150 (28.11.14).
19 de Agosto de 2014Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: ALDESA AGRUPACION EMPRESARIAL SA. Datos registrales. T28091 , F 33, S 8, H M 39125, I/A 149 (11.08.14).
05 de Junio de 2014Modificaciones estatutarias. QUEDA MODIFICADO EL ARTICULO 10 E INTRODUCCIDO EL 9BIS DE LOS ESTATUTOSSOCIALES.-. Datos registrales. T 28091 , F 33, S 8, H M 39125, I/A 148 (28.05.14).
26 de Febrero de 2014Nombramientos. Apoderado: LOPEZ DE FORONDA PEREZ MIGUEL. Datos registrales. T 28091 , F 33, S 8, H M 39125, I/A 147(18.02.14).
17 de Enero de 2014Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28091 , F 32, S 8, H M 39125, I/A 146 (10.01.14).
14 de Mayo de 2013Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ DE SANTOS PEDRO LUIS. Datos registrales. T 28091 , F 32, S 8, H M 39125, I/A 145 (7.05.13).
02 de Abril de 2013Revocaciones. Apo.Sol.: GUILLAMON TE脩A CARLOS;MARTINEZ GARCIA JUAN LUIS. Nombramientos. Apo.Sol.: SOLORZANOFERNANDEZ JOAQUIN;ARGUELLES DE BUSTILLO JOSE MARIA;ESPASANDIN BLASCO JOSE MIGUEL;GONZALEZ HERNANDOIVAN;POU YANEZ JUAN MIGUEL;NU脩EZ TORREIRO ELENA. Datos registrales. T 28091 , F 31, S 8, H M 39125, I/A 144(22.03.13).
22 de Marzo de 2013Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MARTINEZ DE SIMON SANTOS GUILLERMO. Nombramientos. SecreNoConsj: FERNANDEZRUIZ MATILDE. Datos registrales. T 28091 , F 30, S 8, H M 39125, I/A 143 (13.03.13).
06 de Febrero de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: DUARTE I MACARRO ESTHER. Datos registrales. T 28091 , F 30, S 8, H M 39125, I/A 142 (29.01.13).
22 de Enero de 2013Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28091 , F 30, S 8, H M 39125, I/A 141 (14.01.13).
04 de Diciembre de 2012Revocaciones. Apo.Sol.: RUS PEZZI MANUEL. Datos registrales. T 28091 , F 30, S 8, H M 39125, I/A 140 (23.11.12).
23 de Octubre de 2012Ceses/Dimisiones. Representan: DELGADO DELGADO JAVIER. Nombramientos. Representan: FERNANDEZ ROMEROALFONSO. Datos registrales. T 28091 , F 29, S 8, H M 39125, I/A 139 ( 8.10.12).
09 de Octubre de 2012Revocaciones. Apoderado: DELGADO DELGADO JAVIER;DELGADO DELGADO JAVIER. Apo.Manc.: DELGADO DELGADOJAVIER;CANTERO GARCIA JUAN CARLOS;LOPEZ DE FORONDA PEREZ MIGUEL;BLANC GARCIA VALCARCELCARLOS;PALLARES MORA脩O MARIA LUISA;DOMINGUEZ SANTOS JULIO;ALONSO VENA JOAQUIN. Nombramientos.Apo.Manc.: CANTERO GARCIA JUAN CARLOS;FERNANDEZ ROMERO ALFONSO;DOMINGUEZ SANTOS JULIO;LOPEZ DEFORONDA PEREZ MIGUEL;BLANC GARCIA VALCARCEL CARLOS;PALLARES MORA脩O MARIA LUISA;ALONSO VENAJOAQUIN. Datos registrales. T 28091 , F 29, S 8, H M 39125, I/A 138 (28.09.12).
25 de Julio de 2012Revocaciones. Apoderado: REINA SALGUERO JAVIER. Apo.Sol.: PEREZ NAVINES JAVIER. Datos registrales. T 28091 , F 29, S8, H M 39125, I/A 137 (13.07.12).
06 de Junio de 2012Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ ROMERO ALFONSO. Datos registrales. T 28091 , F 28, S 8, H M 39125, I/A 136(25.05.12).
22 de Marzo de 2012Revocaciones. Apoderado: MARTIN ADANERO FERNANDO. Datos registrales. T 28091 , F 27, S 8, H M 39125, I/A 134 ( 9.03.12).
Nombramientos. Apoderado: PALLARES MORA脩O MARIA LUISA. Datos registrales. T 28091 , F 27, S 8, H M 39125, I/A 135 (9.03.12).
02 de Febrero de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: PLAZA BARANDA JORGE;PALLARES MORA脩O MARIA LUISA. Datos registrales. T 28091 , F 27, S 8,H M 39125, I/A 133 (23.01.12).
01 de Febrero de 2012Revocaciones. Apoderado: ALSINA CASANOVA SANTIAGO;ALSINA CASANOVA SANTIAGO;PALLARES MORA脩O MARIALUISA;ALSINA CASANOVA SANTIAGO;ALSINA CASANOVA SANTIAGO;DELGADO DELGADO JAVIER;DOMINGUEZ SANTOSJULIO;LOPEZ DE FORONDA PEREZ MIGUEL;BLANC GARCIA-VALCARCEL CARLOS. Nombramientos. Apo.Sol.: PALLARESMORA脩O MARIA LUISA. Apo.Manc.: DELGADO DELGADO JAVIER;CANTERO GARCIA JUAN CARLOS;LOPEZ DE FORONDAPEREZ MIGUEL;BLANC GARCIA VALCARCEL CARLOS;PALLARES MORA脩O MARIA LUISA;DOMINGUEZ SANTOSJULIO;ALONSO VENA JOAQUIN. Datos registrales. T 28091 , F 26, S 8, H M 39125, I/A 132 (23.01.12).
10 de Enero de 2012Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28091 , F 26, S 8, H M 39125, I/A 131 (27.12.11).
10 de Noviembre de 2011Revocaciones. Apo.Sol.: ROLLE MARTINEZ CABA脩AS JOSE MARIA. Datos registrales. T 28091 , F 26, S 8, H M 39125, I/A 130(27.10.11).
26 de Octubre de 2011Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: FERNANDEZ RUIZ MATILDE. Nombramientos. SecreNoConsj: MARTINEZ DE SIMONSANTOS GUILLERMO. Datos registrales. T 28091 , F 25, S 8, H M 39125, I/A 129 (13.10.11).
21 de Julio de 2011Nombramientos. Apoderado: GARCIA NIEVES JOSE MARIA. Datos registrales. T 28091 , F 25, S 8, H M 39125, I/A 128(11.07.11).
24 de Marzo de 2011Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MANZANEDO GONZALEZ FELIX FERNANDO. Nombramientos. SecreNoConsj: FERNANDEZRUIZ MATILDE. Datos registrales. T 28091 , F 25, S 8, H M 39125, I/A 127 ( 9.03.11).
25 de Febrero de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: ROLLE MARTINEZ CABA脩AS JOSE MARIA;PEREZ NAVINES JAVIER;RUS PEZZI MANUEL. Datosregistrales. T 28091 , F 23, S 8, H M 39125, I/A 125 (15.02.11).
Revocaciones. Apoderado: PEREZ BARTOLOME JORGE. Datos registrales. T 28091 , F 25, S 8, H M 39125, I/A 126 (15.02.11).
10 de Febrero de 2011Revocaciones. Apoderado: MURILLO SANROMA ENRIQUE;MURILLO SANROMA ENRIQUE;MURILLO SANROMA ENRIQUE.Datos registrales. T 28091 , F 23, S 8, H M 39125, I/A 124 (31.01.11).
24 de Enero de 2011Nombramientos. Apoderado: LOPEZ DE FORONDA PEREZ MIGUEL;BLANC GARCIA-VALCARCEL CARLOS. Datos registrales.T 28091 , F 22, S 8, H M 39125, I/A 123 (12.01.11).
14 de Enero de 2011Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28091 , F 22, S 8, H M 39125, I/A 122 ( 3.01.11).
01 de Diciembre de 2010Revocaciones. Apoderado: LLAMAS VELASCO FRANCISCO. Datos registrales. T 25234 , F 182, S 8, H M 39125, I/A 121(18.11.10).
17 de Noviembre de 2010Revocaciones. Apoderado: GOMEZ NAVARRO GONZALO. Datos registrales. T 25234 , F 182, S 8, H M 39125, I/A 120 ( 4.11.10).
16 de Noviembre de 2010Ceses/Dimisiones. Representan: HERNANDEZ LUZ ENRIQUE. Nombramientos. Representan: FERNANDEZ RUIZ ISABEL.Datos registrales. T 25234 , F 182, S 8, H M 39125, I/A 119 ( 2.11.10).
29 de Octubre de 2010Revocaciones. Apoderado: HERNANDEZ LUZ ENRIQUE;MU脩OZ SUAREZ ANTONIO FERNANDO;HERNANDEZ LUZENRIQUE;HERNANDEZ LUZ ENRIQUE. Datos registrales. T 25234 , F 182, S 8, H M 39125, I/A 118 (19.10.10).
27 de Octubre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ RUIZ ALEJANDRO;MANZANEDO GONZALEZ FELIX FERNANDO;HERNANDEZ LUZENRIQUEPresidente: HERNANDEZ LUZ ENRIQUE. Secretario: MANZANEDO GONZALEZ FELIX FERNANDO. Con.Delegado:FERNANDEZ RUIZ ALEJANDRO. Nombramientos. SecreNoConsj: MANZANEDO GONZALEZ FELIX FERNANDO. Representan:FERNANDEZ RUIZ ALEJANDRO;DELGADO DELGADO JAVIER. Consejero: ALDESA CONSTRUCCIONES SA;ALDESAINGENIERIA Y SERVICIOS SL;ALDESA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION SL. Presidente: ALDESA ACTIVIDADES DECONSTRUCCION SL. Con.Delegado: ALDESA CONSTRUCCIONES SA. Representan: HERNANDEZ LUZ ENRIQUE. Datosregistrales. T 25234 , F 180, S 8, H M 39125, I/A 117 (18.10.10).
21 de Junio de 2010Revocaciones. Apoderado: ALSINA CASANOVA SANTIAGO;PALLARES MORA脩O MARIA LUISA. Datos registrales. T 25234 , F
11 de Junio de 2010Nombramientos. Apoderado: MURILLO SANROMA ENRIQUE. Datos registrales. T 25234 , F 179, S 8, H M 39125, I/A 115(31.05.10).
07 de Junio de 2010Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ DE SANTOS PEDRO LUIS;MARTIN ADANERO FERNANDO;REINA SALGUERO JAVIER.Datos registrales. T 25234 , F 176, S 8, H M 39125, I/A 113 (25.05.10).
Nombramientos. Apoderado: PALLARES MORA脩O MARIA LUISA;ALSINA CASANOVA SANTIAGO;MURILLO SANROMAENRIQUE;ALSINA CASANOVA SANTIAGO;HERNANDEZ LUZ ENRIQUE;MURILLO SANROMA ENRIQUE;DELGADO DELGADOJAVIER;DOMINGUEZ SANTOS JULIO;LOPEZ DE FORONDA PEREZ MIGUEL;BLANC GARCIA-VALCARCEL CARLOS. Datosregistrales. T 25234 , F 178, S 8, H M 39125, I/A 114 (25.05.10).
24 de Febrero de 2010Revocaciones. Apo.Manc.: ALSINA CASANOVA SANTIAGO;LLAMAS VELASCO FRANCISCO. Nombramientos. Apoderado:ALSINA CASANOVA SANTIAGO;PALLARES MORA脩O MARIA LUISA. Datos registrales. T 25234 , F 175, S 8, H M 39125, I/A 112(12.02.10).
08 de Febrero de 2010Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: ALDESA CONSTRUCCIONES SA. Datos registrales. T 25234 , F175, S 8, H M 39125, I/A 111 (27.01.10).
16 de Diciembre de 2009Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 25234 , F 175, S 8, H M 39125, I/A 110 ( 3.12.09).
27 de Noviembre de 2009Revocaciones. Apo.Manc.: HERNANDEZ LUZ ENRIQUE;DELGADO DELGADO JAVIER;GOMEZ NAVARROGONZALO;DOMINGUEZ SANTOS JULIO. Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ LUZ ENRIQUE;DELGADO DELGADOJAVIER;LOPEZ DE FORONDA PEREZ MIGUEL;DOMINGUEZ SANTOS JULIO;BLANC GARCIA-VALCARCEL CARLOS. Datosregistrales. T 25234 , F 175, S 8, H M 39125, I/A 109 (17.11.09).
20 de Mayo de 2009Revocaciones. Apo.Sol.: LOPEZ GARCIA DE LEANIZ JOSE. Datos registrales. T 25234 , F 174, S 8, H M 39125, I/A 108 (7.05.09).