Buscador CIF Logo

Actos BORME Aertec Industrial Engineering Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Aertec Industrial Engineering Sl

Actos BORME Aertec Industrial Engineering Sl - B91972927

Tenemos registrados 12 Actos BORME del Registro Mercantil de Malaga para Aertec Industrial Engineering Sl con CIF B91972927

馃敊 Perfil de Aertec Industrial Engineering Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Malaga

Actos BORME de Aertec Industrial Engineering Sl

10 de Mayo de 2017
Ceses/Dimisiones. Socio 煤nico: AERTEC SOLUTIONS SL. Adm. Solid.: GOMEZ GUILLAMON MANRIQUE ANTONIO;PADILLAGOMEZ GUILLAMON VICENTE. Revocaciones. Apoderado: BORDOY SANCHEZ PILAR;LERENA CABELLOS ARTURO;TORRESCASADO DE AMEZUA DANIEL;MARTOS MARTINEZ EVA;ZAFRA IBA脩EZ ANTONIO JESUS;LUCENA COBOS ANGEL.Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 5135, L 4042, F 224, S 8, H MA118105, I/A 19 (27.04.17).

24 de Enero de 2017
Reelecciones. Auditor: AB INTEGRO SL. Datos registrales. T 5135, L 4042, F 224, S 8, H MA118105, I/A 18 (13.01.17).

26 de Octubre de 2016
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 3. Domicilio social y web corporativa.-. Cambio de domicilio social. AVDAJUAN LOPEZ DE PE脩ALVER 17 (MALAGA). Datos registrales. T 5135, L 4042, F 224, S 8, H MA118105, I/A 17 (17.10.16).

20 de Julio de 2016
Revocaciones. Apoderado: DORAL DE LA PENA DAVID. Datos registrales. T 5135, L 4042, F 224, S 8, H MA118105, I/A 16(12.07.16).

05 de Julio de 2016
Nombramientos. Apoderado: LUCENA COBOS ANGEL. Datos registrales. T 5135, L 4042, F 224, S 8, H MA118105, I/A 15(27.06.16).

04 de Agosto de 2015
Revocaciones. Apoderado: DORAL DE LA PENA DAVID. Nombramientos. Apoderado: DORAL DE LA PENA DAVID. Datosregistrales. T 5135, L 4042, F 223, S 8, H MA118105, I/A 13 (27.07.15).

Nombramientos. Auditor: AB INTEGRO SL. Datos registrales. T 5135, L 4042, F 223, S 8, H MA118105, I/A 14 (27.07.15).

15 de Junio de 2015
Revocaciones. Apoderado: TORRES CASADO DE AMEZUA DANIEL. Nombramientos. Apoderado: TORRES CASADO DEAMEZUA DANIEL. Datos registrales. T 5135, L 4042, F 222, S 8, H MA118105, I/A 10 ( 3.06.15).

11 de Junio de 2015
Nombramientos. Apoderado: LERENA CABELLOS ARTURO. Datos registrales. T 5135, L 4042, F 222, S 8, H MA118105, I/A 9 (3.06.15).

Nombramientos. Apoderado: MARTOS MARTINEZ EVA. Datos registrales. T 5135, L 4042, F 222, S 8, H MA118105, I/A 11 (3.06.15).

Nombramientos. Apoderado: ZAFRA IBA脩EZ ANTONIO JESUS. Datos registrales. T 5135, L 4042, F 223, S 8, H MA118105, I/A12 ( 3.06.15).

26 de Diciembre de 2014
Nombramientos. Auditor: AB INTEGRO SL. Datos registrales. T 5135, L 4042, F 222, S 8, H MA118105, I/A 8 (15.12.14).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n