Buscador CIF Logo

Actos BORME Afanias Jardiser Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Afanias Jardiser Sl

Actos BORME Afanias Jardiser Sl - B80503048

Tenemos registrados 35 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Afanias Jardiser Sl con CIF B80503048

馃敊 Perfil de Afanias Jardiser Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Afanias Jardiser Sl

10 de Octubre de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ FERNANDEZ CESAR;FERNANDEZ PASCUAL CARLOS;CASTELLANO GARCIAANTONIO;RECIO MARTIN FRANCISCO. Presidente: RECIO MARTIN FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: GARCIA RUBIOMARIA ISABEL;FERNANDEZ DE CLERCK ELIZALDE RAFAEL HILARION;GARCIA MORETA HORTENSIA;BALANZAT ALONSOMANUEL. Presidente: GARCIA RUBIO MARIA ISABEL. Reelecciones. SecreNoConsj: ALBERQUILLA RODRIGUEZ JUANMANUEL. Datos registrales. T 37675 , F 188, S 8, H M 85739, I/A 46 ( 3.10.23).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA RUBIO MARIA ISABEL;FERNANDEZ DE CLERCK ELIZALDE RAFAELHILARION;BALANZAT ALONSO MANUEL;CALVO PEREZ ALIPIO;ALBERQUILLA RODRIGUEZ JUAN MANUEL. Datos registrales.T 37675 , F 188, S 8, H M 85739, I/A 47 ( 3.10.23).

04 de Agosto de 2023
Revocaciones. Apoderado: JIMENEZ FERNANDEZ CESAR;ARES ARRANZ RUBEN;ALBERQUILLA RODRIGUEZ JUANMANUEL;MARTINEZ GOMEZ ALEJANDRO;MARTINEZ GOMEZ ALEJANDRO;ARES ARRANZ RUBEN. Datos registrales. T 37675, F 187, S 8, H M 85739, I/A 45 (28.07.23).

15 de Septiembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: BA脩ARES MARIBELA EDUARDO. Datos registrales. T 37675 , F 187, S 8, H M 85739, I/A 43 (8.09.22).

29 de Agosto de 2022
Nombramientos. Presidente: RECIO MARTIN FRANCISCO. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la inscripci贸n 39陋 la publicaci贸ndel nombramiento de RECIO MARTIN FRANCISCO como presidente. Datos registrales. T 37675 , F 183, S 8, H M 85739, I/A 39(11.07.22).

18 de Julio de 2022
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ARES ARRANZ RUBEN. Con.Delegado: JIMENEZ FERNANDEZ CESAR. Presidente: JIMENEZFERNANDEZ CESAR. Nombramientos. SecreNoConsj: ALBERQUILLA RODRIGUEZ JUAN MANUEL. Consejero: RECIO MARTINFRANCISCO. Datos registrales. T 37675 , F 183, S 8, H M 85739, I/A 39 (11.07.22).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: RECIO MARTIN FRANCISCO;JIMENEZ FERNANDEZ CESAR. Datos registrales. T 37675 , F 184,S 8, H M 85739, I/A 40 (11.07.22).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALBERQUILLA RODRIGUEZ JUAN MANUEL. Datos registrales. T 37675 , F 185, S 8, H M 85739,I/A 41 (11.07.22).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: CALVO PEREZ ALIPIO. Datos registrales. T 37675 , F 186, S 8, H M 85739, I/A 42 (11.07.22).

03 de Marzo de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ GOMEZ ALEJANDRO. Presidente: MARTINEZ GOMEZ ALEJANDRO. Con.Delegado:MARTINEZ GOMEZ ALEJANDRO. Nombramientos. Consejero: CASTELLANO GARCIA ANTONIO. Presidente: JIMENEZFERNANDEZ CESAR. Con.Delegado: JIMENEZ FERNANDEZ CESAR. Datos registrales. T 37675 , F 183, S 8, H M 85739, I/A 38(24.02.21).

30 de Julio de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LA CRUZ SANCHEZ HIPOLITO;TORRES MARTIN LUIS;LOPEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO.Presidente: JIMENEZ FERNANDEZ CESAR. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ GOMEZ ALEJANDRO. Presidente:MARTINEZ GOMEZ ALEJANDRO. Con.Delegado: MARTINEZ GOMEZ ALEJANDRO. Consejero: FERNANDEZ PASCUAL CARLOS.Reelecciones. Consejero: JIMENEZ FERNANDEZ CESAR. SecreNoConsj: ARES ARRANZ RUBEN. Datos registrales. T 37675 , F182, S 8, H M 85739, I/A 37 (23.07.20).

17 de Marzo de 2020
Reelecciones. Auditor: AUNANCE AUDITORES SLP. Datos registrales. T 37675 , F 182, S 8, H M 85739, I/A 36 (10.03.20).

29 de Mayo de 2019
Nombramientos. Apoderado: ARES ARRANZ RUBEN. Datos registrales. T 37675 , F 182, S 8, H M 85739, I/A 35 (22.05.19).

13 de Marzo de 2019
Revocaciones. Apo.Manc.: SOBRINO OVIEDO JULIAN;TRENADO CORPA LORENZO. Apoderado: JOSE LUIS MARTINEZLORENZO;MARTINEZ GOMEZ LIMON LIBERTAD. Datos registrales. T 37675 , F 181, S 8, H M 85739, I/A 33 ( 6.03.19).

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GOMEZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 37675 , F 181, S 8, H M 85739, I/A 34 (6.03.19).

11 de Marzo de 2019
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GOMEZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 5237 , F 225, S 8, H M 85739, I/A 32 (4.03.19).

13 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apoderado: ALBERQUILLA RODRIGUEZ JUAN MANUEL. Datos registrales. T 5237 , F 224, S 8, H M 85739, I/A31 ( 2.02.18).

08 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GOMEZ LIMON LIBERTAD. Datos registrales. T 5237 , F 224, S 8, H M 85739, I/A 30 (1.02.18).

28 de Diciembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA BLAZQUEZ ANTONIO. Reelecciones. Presidente: JIMENEZ FERNANDEZ CESAR.SecreNoConsj: ARES ARRANZ RUBEN. Datos registrales. T 5237 , F 224, S 8, H M 85739, I/A 29 (20.12.17).

06 de Junio de 2017
Nombramientos. Apoderado: JOSE LUIS MARTINEZ LORENZO. Datos registrales. T 5237 , F 223, S 8, H M 85739, I/A 27(29.05.17).

Nombramientos. Auditor: AUNANCE AUDITORES SLP. Datos registrales. T 5237 , F 224, S 8, H M 85739, I/A 28 (30.05.17).

23 de Marzo de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: TRENADO CORPA LORENZO;ROMERA GARCIA ENRIQUE. Nombramientos. Consejero: LOPEZMARTINEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 5237 , F 223, S 8, H M 85739, I/A 26 (15.03.17).

03 de Mayo de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO. Vicepresid.: LOPEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO.Nombramientos. Consejero: ROMERA GARCIA ENRIQUE. Datos registrales. T 5237 , F 222, S 8, H M 85739, I/A 24 (22.04.16).

Ceses/Dimisiones. Consejero: GORTAZAR DE ORUE JAIME IGNACIO. Nombramientos. Consejero: TORRES MARTIN LUIS.Datos registrales. T 5237 , F 222, S 8, H M 85739, I/A 25 (22.04.16).

10 de Octubre de 2014
Reelecciones. Auditor: FISA AUDITORES SA. Datos registrales. T 5237 , F 222, S 8, H M 85739, I/A 23 ( 3.10.14).

06 de Mayo de 2014
Nombramientos. Apoderado: ARES ARRANZ RUBEN. Datos registrales. T 5237 , F 221, S 8, H M 85739, I/A 22 (25.04.14).

11 de Marzo de 2014
Ampliacion del objeto social. La inserci贸n laboral de trabajadores minusv谩lidos ps铆quicos a trav茅s de talleres o trabajos dejardiner铆a, manipulado y encuadernaci贸n artesana, mec谩nicos, inform谩ticos, arte floral, servicios domiciliarios, conservaci贸n ymantenimiento de bienes inmuebles y limpieza e higienizaci贸n. La inserci贸n. Datos registrales. T 5237 , F 221, S 8, H M 85739, I/A21 ( 3.03.14).

07 de Febrero de 2013
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: JIMENEZ FERNANDEZ CESAR. Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ FERNANDEZ CESAR.Datos registrales. T 5237 , F 220, S 8, H M 85739, I/A 20 (30.01.13).

29 de Enero de 2013
Reelecciones. Auditor: FISA AUDITORES SA. Datos registrales. T 5237 , F 220, S 8, H M 85739, I/A 19 (21.01.13).

14 de Diciembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: LAZARO GONZALEZ LEONCIO. Presidente: LAZARO GONZALEZ LEONCIO. Cons.Del.Sol:LAZARO GONZALEZ LEONCIO. Nombramientos. Presidente: JIMENEZ FERNANDEZ CESAR. Con.Delegado: JIMENEZFERNANDEZ CESAR. Datos registrales. T 5237 , F 219, S 8, H M 85739, I/A 18 ( 5.12.12).

07 de Diciembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: FONSECA MORENO ROCIO;MARTINEZ LORENZO JOSE-LUIS;ARES ARRANZ RUBEN. Secretario:ARES ARRANZ RUBEN. Cons.Del.Sol: MARTINEZ LORENZO JOSE-LUIS. Nombramientos. Consejero: JIMENEZ FERNANDEZCESAR;DE LA CRUZ SANCHEZ HIPOLITO;GARCIA BLAZQUEZ ANTONIO. SecreNoConsj: ARES ARRANZ RUBEN. Reelecciones.Presidente: LAZARO GONZALEZ LEONCIO. Vicepresid.: LOPEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO. Cons.Del.Sol: LAZARO GONZALEZLEONCIO. Datos registrales. T 5237 , F 219, S 8, H M 85739, I/A 17 (27.11.12).

14 de Marzo de 2012
Nombramientos. Auditor: FISA AUDITORES SA. Datos registrales. T 5237 , F 219, S 8, H M 85739, I/A 16 ( 2.03.12).

14 de Febrero de 2011
Nombramientos. Apo.Manc.: ARES ARRANZ RUBEN;SOBRINO OVIEDO JULIAN;TRENADO CORPA LORENZO. Datosregistrales. T 5237 , F 218, S 8, H M 85739, I/A 15 ( 2.02.11).

03 de Enero de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: DARDER FERRER BARBARA. Vicepresid.: DARDER FERRER BARBARA. Consejero: CUEVASGARCIA ANTONIO. Secretario: CUEVAS GARCIA ANTONIO. Consejero: MAS GUTIERREZ LUIS. Nombramientos. Consejero:LOPEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO;ARES ARRANZ RUBEN. Vicepresid.: LOPEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO. Secretario: ARESARRANZ RUBEN. Cons.Del.Sol: LAZARO GONZALEZ LEONCIO;MARTINEZ LORENZO JOSE-LUIS. Datos registrales. T 5237 , F216, S 8, H M 85739, I/A 14 (22.12.10).

31 de Diciembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALHAMBRA DE ORDU脩A LUIS FERNANDO. Cons.Del.Sol: ALHAMBRA DE ORDU脩A LUISFERNANDO. Consejero: GUEDE MERINO GONZALO. Presidente: GUEDE MERINO GONZALO. Consejero: TORRES MARTIN LUIS.Vicepresid.: TORRES MARTIN LUIS. Consejero: JIMENEZ FERNANDEZ CESAR;JIMENEZ ESPINOSA EMILIO. Revocaciones.Apoderado: MARIN MEGIAS ISABEL MARIA;MAS GUTIERREZ LUIS. Nombramientos. Consejero: LAZARO GONZALEZLEONCIO;DARDER FERRER BARBARA;GORTAZAR DE ORUE JAIME IGNACIO;TRENADO CORPA LORENZO;MARTINEZLORENZO JOSE-LUIS. Presidente: LAZARO GONZALEZ LEONCIO. Cons.Del.Sol: LAZARO GONZALEZ LEONCIO. Vicepresid.:DARDER FERRER BARBARA. Cons.Del.Sol: MARTINEZ LORENZO JOSE-LUIS. Reelecciones. Consejero: FONSECA MORENOROCIO;CUEVAS GARCIA ANTONIO. Secretario: CUEVAS GARCIA ANTONIO. Consejero: MAS GUTIERREZ LUIS. Datosregistrales. T 5237 , F 215, S 8, H M 85739, I/A 13 (18.12.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n