Actos BORME de Afarvi Sistemas Sl
28 de Noviembre de 2023Ceses/Dimisiones. Auditor: MGI AUDICON & PARTNERS SLP. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 18754 , F 216, S 8, H M 326859, I/A 17 (21.11.23).
09 de Octubre de 2023Revocaciones. Apoderado: SERRANO MINCHAN AGUSTIN. Datos registrales. T 18754 , F 216, S 8, H M 326859, I/A 16 (2.10.23).
06 de Octubre de 2023Nombramientos. Apoderado: SEGURA SADABA CRISTINA. Datos registrales. T 18754 , F 214, S 8, H M 326859, I/A 14(29.09.23).
Modificaciones estatutarias. 7. Modificaci贸n del art铆culo 7潞 de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 18754 , F 215, S 8, H M326859, I/A 15 (29.09.23).
12 de Abril de 2023Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: INNOMETAL 2019 SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: DE LA CUERDA PEREZJUAN ANTONIO;MOYA RUIZ JOSE ANTONIO. Nombramientos. Adm. Unico: CLERBIL SL. Representan: JAINAGA GOMEZ JOSEANTONIO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administrador 煤nico. Datosregistrales. T 18754 , F 212, S 8, H M 326859, I/A 12 ( 3.04.23).
Nombramientos. Apoderado: DE LA CUERDA PEREZ JUAN ANTONIO;MOYA RUIZ JOSE ANTONIO;SERRANO MINCHANAGUSTIN;PINEDA GOMEZ MARCO;ECHARRI LOPEZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 18754 , F 213, S 8, H M 326859, I/A13 ( 3.04.23).
14 de Febrero de 2023Reelecciones. Auditor: MGI AUDICON & PARTNERS SLP. Datos registrales. T 18754 , F 212, S 8, H M 326859, I/A 10 ( 7.02.23).
Reelecciones. Auditor: MGI AUDICON & PARTNERS SLP. Datos registrales. T 18754 , F 212, S 8, H M 326859, I/A 11 ( 7.02.23).
26 de Mayo de 2021Nombramientos. Auditor: MGI AUDICON & PARTNERS SLP. Datos registrales. T 18754 , F 212, S 8, H M 326859, I/A 9 (19.05.21).
20 de Enero de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 7.206,00 Euros. Resultante Suscrito: 37.206,00 Euros. Datos registrales. T 18754 , F 211, S 8, H M326859, I/A 8 (12.01.17).
05 de Diciembre de 2014Cambio de domicilio social. C/ ATLANTICO 10 - POLIGONO INDUSTRIAL LOS OLIVOS (AJALVIR). Datos registrales. T 18754 ,F 211, S 8, H M 326859, I/A 7 (26.11.14).
11 de Febrero de 2013Modificaciones estatutarias. 14. Retribucion del organo de administracion.-. Datos registrales. T 18754 , F 210, S 8, H M 326859,I/A 6 (31.01.13).
03 de Febrero de 2011Cambio de domicilio social. C/ LAS MARINERAS,, N潞 16, PLGNO. IND. LAS MARINERA (AJALVIR). Datos registrales. T 18754 ,F 210, S 8, H M 326859, I/A 5 (21.01.11).
29 de Marzo de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LA CUERDA PEREZ JUAN ANTONIO. Presidente: MOYA RUIZ JOSE ANTONIO. Cons.Del.Sol:MOYA RUIZ JOSE ANTONIO. Consejero: MOYA RUIZ JOSE ANTONIO. Nombramientos. Adm. Solid.: DE LA CUERDA PEREZJUAN ANTONIO;MOYA RUIZ JOSE ANTONIO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 18754 , F 210, S 8, H M 326859, I/A 4 (15.03.10).
10 de Noviembre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: MONDEJAR MARTINEZ MIGUEL ANGEL. Secretario: MONDEJAR MARTINEZ MIGUEL ANGEL.Datos registrales. T 18754 , F 209, S 8, H M 326859, I/A 3 (27.10.09).
06 de Febrero de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MONDEJAR MARTINEZ MIGUEL ANGEL;DE LA CUERDA PEREZ JUAN ANTONIO.Nombramientos. Consejero: MONDEJAR MARTINEZ MIGUEL ANGEL;DE LA CUERDA PEREZ JUAN ANTONIO;MOYA RUIZ JOSEANTONIO. Presidente: MOYA RUIZ JOSE ANTONIO. Secretario: MONDEJAR MARTINEZ MIGUEL ANGEL. Cons.Del.Sol: MOYARUIZ JOSE ANTONIO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Consejode administraci贸n. Cambio de domicilio social. C/ RAFAEL PILLADO MOURELLE, 30 Bl.2 - NAVE 5, POLI (ALGETE). Datosregistrales. T 18754 , F 209, S 8, H M 326859, I/A 2 (27.01.09).