Actos BORME de Affistock Sl
11 de Abril de 2023Cambio de domicilio social. C/ CARPINTEROS 24 - PARQUE EMPRESARIAL PRADO DEL E (BOADILLA DEL MONTE). Datosregistrales. T 11720 , F 99, S 8, H M 184028, I/A 8 (30.03.23).
20 de Mayo de 2022Nombramientos. Apoderado: NAJERA GARCIA SEGOVIA CARLOS. Datos registrales. T 11720 , F 97, S 8, H M 184028, I/A 7(12.05.22).
18 de Mayo de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: DEL BARRIO SUAREZ ALFONSO. Presidente: DEL BARRIO SUAREZ ALFONSO. Consejero:GAMEZ DE LA ROSA MARIA JOSE. Vicepresid.: GAMEZ DE LA ROSA MARIA JOSE. Nombramientos. Presidente: DEL BARRIOGAMEZ MARIA-CONSOLACION. Reelecciones. Secretario: DEL BARRIO GAMEZ PATRICIA CRISTINA. Con.Delegado: DELBARRIO GAMEZ MARIA-CONSOLACION. Datos registrales. T 11720 , F 97, S 8, H M 184028, I/A 6 ( 9.05.16).
01 de Diciembre de 2011Nombramientos. Apoderado: DEL BARRIO GAMEZ PATRICIA CRISTINA;DEL BARRIO GAMEZ MARTA. Datos registrales. T11720 , F 96, S 8, H M 184028, I/A 5 (22.11.11).