Actos BORME de Afford Industrial Sl
20 de Enero de 2023Ampliaci贸n de capital. Capital: 520.483,32 Euros. Resultante Suscrito: 1.430.427,60 Euros. Datos registrales. T 34362 , F 121, S 8,H M 81892, I/A 16 (13.01.23).
18 de Noviembre de 2021Cambio de domicilio social. C/ DEHESA DE MARI MARTIN 4 (NAVALCARNERO). Datos registrales. T 34362 , F 121, S 8, H M81892, I/A 15 (11.11.21).
14 de Enero de 2021Nombramientos. Auditor: ARNAUDIT SLP. Datos registrales. T 34362 , F 121, S 8, H M 81892, I/A 14 ( 7.01.21).
04 de Marzo de 2016Nombramientos. Apoderado: MUNETA MARTINEZ DE MORENTIN MARIA LUISA. Datos registrales. T 4881 , F 184, S 8, H M81892, I/A 13 (26.02.16).
24 de Febrero de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MARTINEZ MUNETA PEDRO JOSE;MUNETA MARTINEZ MORENTIN MARIA LUISA.Nombramientos. Consejero: MUNETA MARTINEZ DE MORENTIN MARIA LUISA;MARTINEZ MUNETA PEDRO JOSE;MARTINEZMUNETA MARIA LUISA. Presidente: MUNETA MARTINEZ DE MORENTIN MARIA LUISA. Secretario: MARTINEZ MUNETA PEDROJOSE. Vicepresid.: MARTINEZ MUNETA MARIA LUISA. Con.Delegado: MARTINEZ MUNETA PEDRO JOSE. Modificacionesestatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 13潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 4881 , F 183, S 8, H M 81892, I/A 12(17.02.16).