Actos BORME de Agasemap Sl
21 de Marzo de 2022Nombramientos. APODERAD.SOL: DE MIGUEL RUIZ LAURENTINO. Datos registrales. T 24921 , F 33, S 8, H B 81084, I/A 9 (9.03.22).
30 de Abril de 2021Ampliaci贸n de capital. Capital: 13.642,70 Euros. Resultante Suscrito: 38.764,50 Euros. Cambio de objeto social. LA ACTIVIDADDE AGENCIA DE SEGUROS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REAL DECRETO LEY 3/2020 DE 4 DEFEBRERO,LA COMPRAVENTA Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.ETC. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas:
28 de Abril de 2016Revocaciones. CONSEJERO: DE MIGUEL RUIZ MARGARITA. SECRETARIO: DE MIGUEL RUIZ MARGARITA. Nombramientos.CONSEJERO: DE MIGUEL CAMPANARIO SARAY. SECRETARIO: DE MIGUEL CAMPANARIO SARAY. Datos registrales. T 24921, F 30, S 8, H B 81084, I/A 7 (20.04.16).
14 de Abril de 2016Revocaciones. APODERADO: DE MIGUEL RUIZ MARGARITA. Datos registrales. T 24921 , F 30, S 8, H B 81084, I/A 6 ( 6.04.16).
31 de Marzo de 2011Revocaciones. ADMINISTR.: CAMPANARIO VERA JULIA. Nombramientos. CONSEJERO: CAMPANARIO VERA JULIA.PRESIDENTE: CAMPANARIO VERA JULIA. CONS. DELEG.: CAMPANARIO VERA JULIA. CONSEJERO: DE MIGUEL RUIZLAURENTINO;DE MIGUEL RUIZ MARGARITA. SECRETARIO: DE MIGUEL RUIZ MARGARITA. Reducci贸n de capital. Importereducci贸n: 0,06 Euros. Resultante Suscrito: 3.005,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital: 22.116,80 Euros. Resultante Suscrito:25.121,80 Euros. Datos registrales. T 24921 , F 29, S 8, H B 81084, I/A 5 (21.03.11).