Buscador CIF Logo

Actos BORME Agencia Maritima Condeminas Madrid Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Agencia Maritima Condeminas Madrid Sa

Actos BORME Agencia Maritima Condeminas Madrid Sa - A28731651

Tenemos registrados 28 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Agencia Maritima Condeminas Madrid Sa con CIF A28731651

馃敊 Perfil de Agencia Maritima Condeminas Madrid Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Agencia Maritima Condeminas Madrid Sa

25 de Enero de 2019
Extinci贸n. Datos registrales. T 26674 , F 54, S 8, H M 64926, I/A 62 (18.01.19).

27 de Noviembre de 2017
Revocaciones. Apoderado: GARCIA-MI脩AUR CAREAGA GONZALO. Datos registrales. T 26674 , F 54, S 8, H M 64926, I/A 61(17.11.17).

21 de Abril de 2017
Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ BILBAO ANA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: SALDA脩A SOLERA SERGIO. Datosregistrales. T 26674 , F 54, S 8, H M 64926, I/A 60 (11.04.17).

03 de Marzo de 2016
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ PEREZ BLANCA. Datos registrales. T 26674 , F 53, S 8, H M 64926, I/A 58 (24.02.16).

Revocaciones. Apoderado: DOPICO RUIZ MARIA ARANZAZU. Nombramientos. Apoderado: DIAZ LARRIETAKOLDOBIKA;HERRERUELA TELLEZ MARTA ISABEL. Datos registrales. T 26674 , F 53, S 8, H M 64926, I/A 59 (24.02.16).

27 de Octubre de 2014
Ceses/Dimisiones. Representan: RUBIO VILAR RICARDO. Nombramientos. Representan: LOPEZ-DORIGA ESCALANTE JUAN.Datos registrales. T 26674 , F 53, S 8, H M 64926, I/A 57 (17.10.14).

03 de Julio de 2014
Reelecciones. Adm. Unico: BERGE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS LOGISTICOS SL. Datos registrales. T 26674 , F 52, S 8,H M 64926, I/A 56 (25.06.14).

26 de Junio de 2014
Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA FELIPE VALERIANO. Datos registrales. T 26674 , F 52, S 8, H M 64926, I/A 55 (18.06.14).

19 de Marzo de 2014
Revocaciones. Apoderado: PORTILLO MANERO ANDRES. Datos registrales. T 26674 , F 52, S 8, H M 64926, I/A 54 (10.03.14).

09 de Enero de 2014
Revocaciones. Apoderado: LOBO LOPEZ MARIA LUISA;CARBONE LEONARDO;LUIS GUTIERREZ ANTONIO;ORCERO NAVALESJAVIER;CASANOVA MARTINEZ FLORENTINO. Datos registrales. T 26674 , F 52, S 8, H M 64926, I/A 53 (30.12.13).

12 de Julio de 2013
Cambio de domicilio social. C/ ALCALA 65 (MADRID). Datos registrales. T 26674 , F 52, S 8, H M 64926, I/A 52 ( 3.07.13).

11 de Diciembre de 2012
Revocaciones. Apoderado: COOPER MARK NICHOLAS. Datos registrales. T 26674 , F 51, S 8, H M 64926, I/A 51 (30.11.12).

10 de Agosto de 2012
Nombramientos. Apoderado: GARCIA-MI脩AUR CAREAGA GONZALO. Datos registrales. T 26674 , F 50, S 8, H M 64926, I/A 50 (1.08.12).

16 de Noviembre de 2011
Revocaciones. Apoderado: AGUIRRE AGUIRREZABAL JUAN;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO;BELLO ALVAREZ ALICIA;IGLESIASSANZ ALBERTO;MU脩OZ CUEVAS FERNANDO;RIVERA LATAS ISABEL;GARCIA TEMPRANO MAHEY;MARTIN CORPACRISTINA;ORDO脩EZ PEREZ MARIA-JOSE;CEPEDA BAZA VANESSA;PEREZ DEL NOTARIO PUENTE ELENA;CERONECHEVARRIA SOLEDAD. Datos registrales. T 26674 , F 50, S 8, H M 64926, I/A 49 ( 2.11.11).

24 de Junio de 2011
Nombramientos. Apoderado: AGUIRRE AGUIRREZABAL JUAN;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO;BELLO ALVAREZ ALICIA;GOMEZ DESALAZAR DE VIANA BELEN;GONZALEZ TOJO ANDRES;DOPICO RUIZ MARIA ARANZAZU;FERNANDEZ BILBAO ANA. Datosregistrales. T 26674 , F 49, S 8, H M 64926, I/A 48 (14.06.11).

02 de Febrero de 2011
Revocaciones. Apoderado: CASANOVA MARTINEZ FLORENTINO. Datos registrales. T 26674 , F 47, S 8, H M 64926, I/A 46(21.01.11).

Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA FELIPE VALERIANO. Datos registrales. T 26674 , F 48, S 8, H M 64926, I/A 47 (21.01.11).

29 de Noviembre de 2010
Nombramientos. Apoderado: AGUIRRE AGUIRREZABAL JUAN;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO;BELLO ALVAREZ ALICIA;IGLESIASSANZ ALBERTO;MU脩OZ CUEVAS FERNANDO;RIVERA LATAS ISABEL;GARCIA TEMPRANO MAHEY;MARTIN CORPACRISTINA;ORDO脩EZ PEREZ MARIA-JOSE;CEPEDA BAZA VANESSA;PEREZ DEL NOTARIO PUENTE ELENA;CERONECHEVARRIA SOLEDAD. Datos registrales. T 26674 , F 47, S 8, H M 64926, I/A 45 (17.11.10).

27 de Mayo de 2010
Revocaciones. Apoderado: DEL BARRIO ALVAREZ ANGEL CARLOS. Datos registrales. T 26674 , F 47, S 8, H M 64926, I/A 44(17.05.10).

10 de Julio de 2009
Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ IGLESIAS MARIA DOLORES. Datos registrales. T 26674 , F 46, S 8, H M 64926, I/A 42 (1.07.09).

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ GEMA MATILDE. Datos registrales. T 26674 , F 46, S 8, H M 64926, I/A 43 (1.07.09).

08 de Julio de 2009
Cambio de domicilio social. C/ ANTONIO MAURA 4 (MADRID). Datos registrales. T 26674 , F 46, S 8, H M 64926, I/A 41(26.06.09).

18 de Mayo de 2009
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: AGENCIA MARITIMA CONDEMINAS SA. Representan: AGUIRRE AGUIRREZABAL JUAN.Nombramientos. Representan: RUBIO VILAR RICARDO. Adm. Unico: BERGE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS LOGISTICOSSL. Datos registrales. T 3868 , F 43, S 8, H M 64926, I/A 35 ( 5.05.09).

Nombramientos. Apoderado: DEL BARRIO ALVAREZ ANGEL CARLOS. Datos registrales. T 3868 , F 43, S 8, H M 64926, I/A 36 (5.05.09).

Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ IGLESIAS MARIA DOLORES. Datos registrales. T 3868 , F 44, S 8, H M 64926, I/A 37( 5.05.09).

Nombramientos. Apoderado: PORTILLO MANERO ANDRES. Datos registrales. T 26674 , F 41, S 8, H M 64926, I/A 38 ( 5.05.09).

Nombramientos. Apoderado: COOPER MARK NICHOLAS. Datos registrales. T 26674 , F 42, S 8, H M 64926, I/A 39 ( 5.05.09).

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ PEREZ BLANCA. Datos registrales. T 26674 , F 44, S 8, H M 64926, I/A 40 ( 5.05.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n