Actos BORME de Agencia Maritima Condeminas Norte Sociedad Limitada
26 de Septiembre de 2013Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 5192 , F 107, S 8, H BI 38705, I/A 17 (13.09.13).
20 de Diciembre de 2012Revocaciones. Apoderado: COOPER MARK NICHOLAS. Datos registrales. T 5192 , F 106, S 8, H BI 38705, I/A 16 ( 7.12.12).
14 de Septiembre de 2012Nombramientos. Apoderado: GARCIA MI脩AUR CAREAGA GONZALO. Datos registrales. T 5192 , F 105, S 8, H BI 38705, I/A 15(27.08.12).
27 de Junio de 2011Nombramientos. Apoderado: AGUIRRE AGUIRREZABAL JUAN;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO;BELLO ALVAREZ ALICIA;GOMEZ DESALAZAR DE VIANA BELEN;GONZALEZ TOJO ANDRES;DOPICO RUIZ MARIA ARANZAZU;FERNANDEZ BILBAO ANA. Datosregistrales. T 5192 , F 104, S 8, H BI 38705, I/A 14 (16.06.11).
11 de Abril de 2011Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ PEREZ BLANCA. Datos registrales. T 4383 , F 221, S 8, H BI 38705, I/A 11 (25.03.11).
Nombramientos. Apoderado: GABRIEL HERNANDO ANGEL. Datos registrales. T 4383 , F 223, S 8, H BI 38705, I/A 12 (25.03.11).
Nombramientos. Apoderado: COOPER MARK NICHOLAS. Datos registrales. T 4383 , F 225, S 8, H BI 38705, I/A 13 (25.03.11).