Buscador CIF Logo

Actos BORME Agencia Schembri Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Agencia Schembri Sa

Actos BORME Agencia Schembri Sa - A07000870

Tenemos registrados 41 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Agencia Schembri Sa con CIF A07000870

馃敊 Perfil de Agencia Schembri Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Agencia Schembri Sa

07 de Noviembre de 2023
Nombramientos. Apoderado: CANALDA MARTINEZ MARC;RODRIGUEZ SANCHEZ JAVIER DEL CRISTO;CASCALES DONESEDUARDO;DIAZ SAAVEDRA PAUL;MARTINEZ HUERGA OSCAR;ZAMORA GOMEZ JAIME. Datos registrales. T 33097 , F 146, S8, H M 207662, I/A 92 (30.10.23).

25 de Abril de 2023
Revocaciones. Apoderado: PACHON GARCIA MARIO;RISQUETE FERNANDEZ FRANCISCO;FERNANDEZ VILLAMANDOSMIGUEL ANGEL;PEREZ GONZALEZ JUAN MIGUEL. Apo.Man.Soli: QUERO GIL JAVIER MARIO;RISQUETE FERNANDEZFRANCISCO JOSE;SANCHEZ SANCHEZ ANGEL;PI脩EIRO REY RAMON;PARDO GIL ALBERDI MIGUEL;QUERO GIL JAVIERMARIO;RISQUETE FERNANDEZ FRANCISCO JOSE;LAPUENTE SASTRE FRANCISCO JAVIER. Apoderado: VAL MARTINEZFERNANDO. Datos registrales. T 33097 , F 143, S 8, H M 207662, I/A 90 (18.04.23).

Nombramientos. Apoderado: ARMAS MEAD ANTONIO PABLO;CANALDA MARTINEZ MARC;VIEJO BELON JOAQUIN;CABRERADEL PINO JAIME JESUS;RODRIGUEZ SANCHEZ JAVIER DEL CRISTO;CASCALES DONES EDUARDO. Datos registrales. T33097 , F 144, S 8, H M 207662, I/A 91 (18.04.23).

19 de Abril de 2023
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ARMAS MEAD ANTONIO PABLO;CANALDA MARTINEZ MARC;VIEJO BELON JOSE LUIS.Apo.Manc.: CABRERA DEL PINO JAIME JESUS;RODRIGUEZ SANCHEZ JAVIER DEL CRISTO. Apo.Man.Soli: CASCALES DONESEDUARDO;FERNANDEZ FLEITAS MONICA. Datos registrales. T 33097 , F 142, S 8, H M 207662, I/A 89 (12.04.23).

07 de Marzo de 2023
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: VAL MARTINEZ FERNANDO. Adm.Man.Supl: ESTUDIOS Y CONSIGNACIONES SL.Nombramientos. Adm. Mancom.: ESTUDIOS Y CONSIGNACIONES SL. Datos registrales. T 33097 , F 142, S 8, H M 207662, I/A88 (28.02.23).

30 de Diciembre de 2022
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 33097 , F 142, S 8, H M 207662, I/A 87 (22.12.22).

17 de Agosto de 2022
Modificaciones estatutarias. 8. Modificaci贸n de art. 8 de los estatutos.. Datos registrales. T 33097 , F 142, S 8, H M 207662, I/A 86( 9.08.22).

09 de Junio de 2022
Nombramientos. Apoderado: VAL MARTINEZ FERNANDO. Datos registrales. T 33097 , F 139, S 8, H M 207662, I/A 82 ( 2.06.22).

Nombramientos. Apoderado: ARMAS MEAD ANTONIO PABLO. Datos registrales. T 33097 , F 140, S 8, H M 207662, I/A 83 (2.06.22).

Nombramientos. Apoderado: ARMAS MEAD ANTONIO PABLO. Datos registrales. T 33097 , F 141, S 8, H M 207662, I/A 84 (2.06.22).

03 de Junio de 2022
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ARMAS FERNANDEZ ANTONIO. Nombramientos. Adm. Mancom.: ARMAS MEAD ANTONIOPABLO;VAL MARTINEZ FERNANDO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aAdministradores mancomunados. Datos registrales. T 33097 , F 139, S 8, H M 207662, I/A 81 (27.05.22).

10 de Marzo de 2021
Ceses/Dimisiones. Secretario: BUGALLO IBARROLA ESTEFANIA. Consejero: COMPA脩IA TRASMEDITERRANEA SA. Presidente:COMPA脩IA TRASMEDITERRANEA SA. Consejero: TRASMEDITERRANEA CARGO SOCIEDAD ANONIMA;TERMINAL FERRY DEBARCELONA SL. Representan: ARMAS MEAD ANTONIO PABLO;ARMAS FERNANDEZ ANTONIO;OGEA FONTAN ALBERTO.Nombramientos. Adm. Unico: ARMAS FERNANDEZ ANTONIO. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOSARTICULOS 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 Y 25 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 33097 , F 137, S 8, H M 207662, I/A 79 (3.03.21).

Revocaciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 33097 , F138, S 8, H M 207662, I/A 80 ( 3.03.21).

31 de Octubre de 2018
Ceses/Dimisiones. Representan: QUERO GIL JAVIER MARIO. Nombramientos. Representan: ARMAS FERNANDEZ ANTONIO.Datos registrales. T 33097 , F 137, S 8, H M 207662, I/A 78 (24.10.18).

09 de Octubre de 2018
Ceses/Dimisiones. Representan: RISQUETE FERNANDEZ FRANCISCO JOSE. Nombramientos. Representan: OGEA FONTANALBERTO. Datos registrales. T 33097 , F 137, S 8, H M 207662, I/A 77 ( 1.10.18).

19 de Septiembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Representan: LAPUENTE SASTRE FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Representan: ARMAS MEADANTONIO PABLO. Datos registrales. T 33097 , F 137, S 8, H M 207662, I/A 76 (12.09.18).

09 de Marzo de 2018
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 33097 , F 136, S 8, H M 207662, I/A 75 ( 2.03.18).

27 de Diciembre de 2017
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALONSO MONTOYA JOSE RAMON. Nombramientos. Apo.Man.Soli: LAPUENTE SASTREFRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 33097 , F 134, S 8, H M 207662, I/A 74 (18.12.17).

07 de Diciembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Representan: ALONSO MONTOYA JOSE RAMON. Nombramientos. Representan: LAPUENTE SASTREFRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 33097 , F 134, S 8, H M 207662, I/A 73 (28.11.17).

10 de Noviembre de 2016
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 33097 , F 134, S 8, H M 207662, I/A 72 (27.10.16).

14 de Septiembre de 2016
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GOMEZ MARTINEZ PABLO;PROVENCIO MIGUEL MARIA DOLORES;MERINO DE DIEGO ANGEL.Apoderado: RISQUETE FERNANDEZ FRANCISCO JOSE;ALONSO MONTOYA JOSE RAMON;MONTES CARACUELRAFAEL;QUERO GIL JAVIER MARIO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: QUERO GIL JAVIER MARIO;RISQUETE FERNANDEZFRANCISCO JOSE;ALONSO MONTOYA JOSE RAMON;SANCHEZ SANCHEZ ANGEL;PI脩EIRO REY RAMON;PARDO GILALBERDI MIGUEL;QUERO GIL JAVIER MARIO;RISQUETE FERNANDEZ FRANCISCO JOSE;ALONSO MONTOYA JOSERAMON;GOMEZ MARTINEZ PABLO. Datos registrales. T 33097 , F 131, S 8, H M 207662, I/A 71 ( 6.09.16).

24 de Junio de 2016
Nombramientos. Apoderado: PEREZ GONZALEZ JUAN MIGUEL. Datos registrales. T 33097 , F 131, S 8, H M 207662, I/A 70(16.06.16).

29 de Marzo de 2016
Reelecciones. Consejero: COMPA脩IA TRASMEDITERRANEA SA. Presidente: COMPA脩IA TRASMEDITERRANEA SA. Consejero:TRASMEDITERRANEA CARGO SOCIEDAD ANONIMA;TRASCARGO GRUPAJES SA. Datos registrales. T 33097 , F 130, S 8, H M207662, I/A 68 (16.03.16).

Ceses/Dimisiones. Representan: QUERO GIL JAVIER MARIO. Consejero: TRASCARGO GRUPAJES SA. Nombramientos.Representan: QUERO GIL JAVIER MARIO. Consejero: TERMINAL FERRY DE BARCELONA SL. Datos registrales. T 33097 , F 130,S 8, H M 207662, I/A 69 (17.03.16).

10 de Diciembre de 2015
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 13964 , F 224, S 8, H M 207662, I/A 67 ( 1.12.15).

01 de Julio de 2015
Revocaciones. Apoderado: HERRERO GOMEZ JOSE VICENTE. Datos registrales. T 13964 , F 224, S 8, H M 207662, I/A 66(23.06.15).

27 de Mayo de 2015
Ceses/Dimisiones. Representan: HERRERO GOMEZ JOSE VICENTE. Nombramientos. Representan: QUERO GIL JAVIERMARIO. Datos registrales. T 13964 , F 224, S 8, H M 207662, I/A 65 (19.05.15).

26 de Febrero de 2015
Revocaciones. Apoderado: AGUILERA CARMONA IGNACIO;ITURRALDE DEL BUSTO JUAN;FERNANDEZ DAY JOSE LUIS.Datos registrales. T 13964 , F 224, S 8, H M 207662, I/A 64 (18.02.15).

07 de Noviembre de 2014
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 13964 , F 223, S 8, H M 207662, I/A 63 (29.10.14).

07 de Noviembre de 2013
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 13964 , F 223, S 8, H M 207662, I/A 62 (30.10.13).

31 de Diciembre de 2012
Cambio de domicilio social. C/ ANABEL SEGURA 11 - COMPLEJO ALBATROS, EDIFICIO (ALCOBENDAS). Datos registrales. T13964 , F 223, S 8, H M 207662, I/A 61 (18.12.12).

04 de Diciembre de 2012
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 13964 , F 223, S 8, H M 207662, I/A 60 (22.11.12).

04 de Octubre de 2012
Revocaciones. Apoderado: GRAVALOS ESTEBAN ANTONIO;RISQUETE FERNANDEZ FRANCISCO JOSE;SANCHEZ ALVAREZJOAQUIN;GUTIERREZ MERELLES ALVARO;MU脩OZ TORRENTE ISABEL;ALONSO MONTOYA JOSE RAMON;MONTESCARACUEL RAFAEL. Nombramientos. Apoderado: AGUILERA CARMONA IGNACIO;RISQUETE FERNANDEZ FRANCISCOJOSE;ALONSO MONTOYA JOSE RAMON;HERRERO GOMEZ JOSE VICENTE;MONTES CARACUEL RAFAEL;QUERO GIL JAVIERMARIO;ITURRALDE DEL BUSTO JUAN;FERNANDEZ DAY JOSE LUIS. Datos registrales. T 13964 , F 221, S 8, H M 207662, I/A 59(24.09.12).

24 de Julio de 2012
Ceses/Dimisiones. Secretario: MARTINEZ LABURTA MARIA CRISTINA. Nombramientos. Secretario: BUGALLO IBARROLAESTEFANIA. Datos registrales. T 13964 , F 220, S 8, H M 207662, I/A 58 (11.07.12).

03 de Mayo de 2012
Ceses/Dimisiones. Representan: SANCHEZ ALVAREZ JOAQUIN. Nombramientos. Representan: ALONSO MONTOYA JOSERAMON. Datos registrales. T 13964 , F 220, S 8, H M 207662, I/A 57 (19.04.12).

26 de Abril de 2012
Ceses/Dimisiones. Representan: GUTIERREZ MERELLES ALVARO. Nombramientos. Representan: HERRERO GOMEZ JOSEVICENTE. Datos registrales. T 13964 , F 220, S 8, H M 207662, I/A 56 (17.04.12).

18 de Noviembre de 2011
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 13964 , F 154, S 8, H M 207662, I/A 55 ( 7.11.11).

23 de Febrero de 2011
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 13964 , F 154, S 8, H M 207662, I/A 54 (14.02.11).

17 de Febrero de 2011
Reelecciones. Consejero: COMPA脩IA TRASMEDITERRANEA SA. Presidente: COMPA脩IA TRASMEDITERRANEA SA. Consejero:TRASMEDITERRANEA CARGO SOCIEDAD ANONIMA;TRASCARGO GRUPAJES SA. Datos registrales. T 13964 , F 154, S 8, H M207662, I/A 53 ( 7.02.11).

17 de Marzo de 2010
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 13964 , F 154, S 8, H M 207662, I/A 52 ( 8.03.10).

10 de Junio de 2009
Revocaciones. Apoderado: SAEZ ELEGIDO JUAN ANDRES;FERNANDEZ LOPEZ ROBERTO. Nombramientos. Apoderado:MONTES CARACUEL RAFAEL. Datos registrales. T 13964 , F 153, S 8, H M 207662, I/A 51 (29.05.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n