Buscador CIF Logo

Actos BORME Agencia Valenciana De Prestaciones Sociales Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Agencia Valenciana De Prestaciones Sociales Sa

Actos BORME Agencia Valenciana De Prestaciones Sociales Sa - A97640056

Tenemos registrados 26 Actos BORME del Registro Mercantil de Valencia para Agencia Valenciana De Prestaciones Sociales Sa con CIF A97640056

馃敊 Perfil de Agencia Valenciana De Prestaciones Sociales Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Valencia

Actos BORME de Agencia Valenciana De Prestaciones Sociales Sa

07 de Octubre de 2013
Cesi贸n global de activo y pasivo. Beneficiarias de la cesi贸n: INSTITUTO VALENCIANO DE ACCION SOCIAL. Disoluci贸n. Cesi贸nglobal de activo y pasivo. Extinci贸n. Datos registrales. T 9520, L 6802, F 81, S 8, H V 111853, I/A 36 (30.09.13).

10 de Julio de 2013
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: INSTITUTO VALENCIANO DE ACCION SOCIAL. Datosregistrales. T 9520, L 6802, F 81, S 8, H V 111853, I/A 35 ( 2.07.13).

25 de Junio de 2013
Reelecciones. Auditor: IBERAUDIT AUDITORES LEVANTE SL. Datos registrales. T 9520, L 6802, F 81, S 8, H V 111853, I/A 34(18.06.13).

14 de Junio de 2013
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 2.188.300,00 Euros. Desembolsado: 2.188.300,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.288.300,00 Euros.Resultante Desembolsado: 2.288.300,00 Euros. Datos registrales. T 9520, L 6802, F 80, S 8, H V 111853, I/A 33 ( 7.06.13).

07 de Mayo de 2013
Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: MONTES SEBASTIAN BEATRIZ. Nombramientos. Vicesecret.: BEUNZA IBA脩EZ HELENA. Datosregistrales. T 9520, L 6802, F 80, S 8, H V 111853, I/A 32 (26.04.13).

06 de Mayo de 2013
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: MARTINEZ GOMEZ JOAQUIN. Consejero: CABRE RICO JORGE;MARTINEZ GOMEZJOAQUIN;GARCIA REBOLL MARIA MANUELA;FERRAN MARTINEZ GUILLERMO;NU脩EZ TORTAJADA AGAPITO. Con.Delegado:MARTINEZ GOMEZ JOAQUIN. Presidente: GARCIA REBOLL MARIA MANUELA. Nombramientos. Consejero: SANCHEZZAPLANA ASUNCION;GARCIA REBOLL MARIA MANUELA;FERRER CERVERA IGNACIO;ESCOLANO PUIG MANUEL;FERRANMARTINEZ GUILLERMO. Datos registrales. T 9520, L 6802, F 80, S 8, H V 111853, I/A 31 (25.04.13).

22 de Febrero de 2013
Nombramientos. Apoderado: SALVADOR MONFORT DAVID. Datos registrales. T 9520, L 6802, F 80, S 8, H V 111853, I/A 30(15.02.13).

15 de Febrero de 2013
Ceses/Dimisiones. Presidente: CABRE RICO JORGE. Nombramientos. Presidente: GARCIA REBOLL MARIA MANUELA. Datosregistrales. T 9520, L 6802, F 79, S 8, H V 111853, I/A 29 ( 8.02.13).

14 de Enero de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: VELA BARGUES JORGE. Datos registrales. T 9520, L 6802, F 79, S 8, H V 111853, I/A 28 (4.01.13).

03 de Octubre de 2012
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: MARTINEZ GOMEZ JOAQUIN. Nombramientos. Con.Delegado: MARTINEZ GOMEZJOAQUIN. Datos registrales. T 8589, L 5877, F 157, S 8, H V 111853, I/A 26 (24.09.12).

Ceses/Dimisiones. Dir. General: BARELLES ADSUARA DAVID. Revocaciones. Apoderado: BARELLES ADSUARA DAVID.Nombramientos. Dir. General: SALVADOR MONFORT DAVID. Apoderado: SALVADOR MONFORT DAVID. Datos registrales. T8589, L 5877, F 157, S 8, H V 111853, I/A 27 (24.09.12).

24 de Septiembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: CATALA BAS ALEXANDRE;JOFRE GARRIGUES CARMEN;MORA TEMPRANO MARIA ANGELES.Nombramientos. Consejero: NU脩EZ TORTAJADA AGAPITO;MARIA PILAR ALBERT GUEROLA. Datos registrales. T 8589, L5877, F 157, S 8, H V 111853, I/A 25 (14.09.12).

01 de Febrero de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: SUCH RONDA ANGELICA. Presidente: SUCH RONDA ANGELICA. Consejero: CALATAYUDCHOVER DAVID IGNACIO;ESCRIG NAVARRO JOSE MIGUEL;BATALLER VICENT ALFONSO. Vicepresid.: MARTINEZ GOMEZJOAQUIN. Consejero: MARTINEZ GOMEZ JOAQUIN. Con.Delegado: MARTINEZ GOMEZ JOAQUIN. Consejero: VELA BARGUESJOSE MANUEL;ROSADO BRETON LUIS EDUARDO;CARRERA HUESO MARIA LUISA;BRUSOLA CARDO ANA;HIDALGOCABALLERO PEDRO;VELA BARGUES JORGE;MAS TABERNER ALIDA. Nombramientos. Consejero: CABRE RICOJORGE;MARTINEZ GOMEZ JOAQUIN;PRECIOSO ESTIGUIN CARLOS ALBERTO;CATALA BAS ALEXANDRE;MORA TEMPRANOMARIA ANGELES;GARCIA REBOLL MARIA MANUELA;FERRAN MARTINEZ GUILLERMO;JOFRE GARRIGUESCARMEN;COLLADO CAPILLA PILAR;VELA BARGUES JORGE;BROSETA DUPRE BRUNO. Datos registrales. T 8589, L 5877, F154, S 8, H V 111853, I/A 21 (23.01.12).

Nombramientos. Presidente: CABRE RICO JORGE. Vicepresid.: MARTINEZ GOMEZ JOAQUIN. Datos registrales. T 8589, L 5877,F 155, S 8, H V 111853, I/A 22 (23.01.12).

Nombramientos. Con.Delegado: MARTINEZ GOMEZ JOAQUIN. Datos registrales. T 8589, L 5877, F 155, S 8, H V 111853, I/A 23(23.01.12).

Ceses/Dimisiones. D. Gerente: SALVADOR MONFORT DAVID. Revocaciones. Apoderado: SALVADOR MONFORT DAVID.Nombramientos. Apoderado: BARELLES ADSUARA DAVID. Dir. General: BARELLES ADSUARA DAVID. Datos registrales. T8589, L 5877, F 155, S 8, H V 111853, I/A 24 (23.01.12).

08 de Junio de 2011
Ceses/Dimisiones. Secretario: VALLES SALES FRANCISCO. Nombramientos. Secretario: RIOS NAVARRO ALEJANDRO.Vicesecret.: MONTES SEBASTIAN BEATRIZ. Cambio de domicilio social. C/ PROFESOR BELTRAN BAGUENA 4 - OFICINA 305(VALENCIA). Datos registrales. T 8589, L 5877, F 154, S 8, H V 111853, I/A 20 (30.05.11).

18 de Abril de 2011
Ceses/Dimisiones. Secretario: MAS TABERNER ALIDA. Nombramientos. Secretario: VALLES SALES FRANCISCO. Datosregistrales. T 8589, L 5877, F 154, S 8, H V 111853, I/A 19 ( 7.04.11).

30 de Diciembre de 2010
Nombramientos. Auditor: IBERAUDIT AUDITORES LEVANTE SL. Datos registrales. T 8589, L 5877, F 154, S 8, H V 111853, I/A18 (21.12.10).

11 de Agosto de 2010
Ceses/Dimisiones. Secretario: VIVANCOS COMES MARIANO. Consejero: VIVANCOS COMES MARIANO;COTINO FERRER JUANGABRIEL. Presidente: COTINO FERRER JUAN GABRIEL. Consejero: PEREZ BOADA ENRIQUE. Nombramientos. Consejero: MASTABERNER ALIDA;VELA BARGUES JORGE;SUCH RONDA ANGELICA. Presidente: SUCH RONDA ANGELICA. Secretario: MASTABERNER ALIDA. Datos registrales. T 8589, L 5877, F 153, S 8, H V 111853, I/A 17 ( 2.08.10).

26 de Mayo de 2009
Cambio de domicilio social. C/ MARQUES DE ZENETE 18 BAJO (VALENCIA). Datos registrales. T 8589, L 5877, F 153, S 8, H V111853, I/A 16 (14.05.09).

25 de Febrero de 2009
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: CALATAYUD CHOVER DAVID IGNACIO. Consejero: CALATAYUD CHOVER DAVID IGNACIO.Miem.Com.Ej.: CALATAYUD CHOVER DAVID IGNACIO. Vicpres C.E: CALATAYUD CHOVER DAVID IGNACIO. Consejero:MARTINEZ GOMEZ JOAQUIN;HIDALGO CABALLERO PEDRO. Nombramientos. Consejero: CALATAYUD CHOVER DAVIDIGNACIO;MARTINEZ GOMEZ JOAQUIN;HIDALGO CABALLERO PEDRO. Vicepresid.: MARTINEZ GOMEZ JOAQUIN. Datosregistrales. T 8393, L 5683, F 224, S 8, H V 111853, I/A 11 (16.02.09).

Ceses/Dimisiones. Miem.Com.Ej.: COTINO FERRER JUAN GABRIEL;VIVANCOS COMES MARIANO;ESCRIG NAVARRO JOSEMIGUEL;BATALLER VICENT ALFONSO. Pres.Com.Ej.: COTINO FERRER JUAN GABRIEL. Sec.Com.Ej.: VIVANCOS COMESMARIANO. Datos registrales. T 8393, L 5683, F 224, S 8, H V 111853, I/A 12 (16.02.09).

Nombramientos. Con.Delegado: MARTINEZ GOMEZ JOAQUIN. Datos registrales. T 8393, L 5683, F 224, S 8, H V 111853, I/A 13(16.02.09).

Revocaciones. Apoderado: CALATAYUD CHOVER DAVID IGNACIO. Datos registrales. T 8393, L 5683, F 224, S 8, H V 111853,I/A 14 (16.02.09).

Revocaciones. Apoderado: SALVADOR MONFORT DAVID. Nombramientos. Apoderado: SALVADOR MONFORT DAVID. Datosregistrales. T 8393, L 5683, F 224, S 8, H V 111853, I/A 15 (16.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n