Actos BORME de Agricola Ponce De Leon Sociedad Limitada
24 de Mayo de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: LOPEZ MALDONADO MIGUEL ANGEL;LOPEZ MALDONADO MANUEL ANDRES. Ampliaci贸n decapital. Capital: 100.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 361.000,00 Euros. Otros conceptos: Modificacion del valor noiminal de lasparticipaciones sociales, pasando de 43'50 euros cada una de ellas, a UN EURO de valor nominal por participaci贸n social. Datosregistrales. T 1063, L 827, F 217, S 8, H AB 11605, I/A 19 (17.05.23).
21 de Abril de 2023Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: IBERALMENDRAS SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1032, L 796, F184, S 8, H AB 11605, I/A 18 (13.04.23).
23 de Agosto de 2022Nombramientos. Adm. Solid.: MARTINEZ PANIAGUA JOSE MANUEL;VERGARA OCA脩A JAVIER. Datos registrales. T 1032, L796, F 183, S 8, H AB 11605, I/A 17 (16.08.22).
15 de Junio de 2021Ceses/Dimisiones. Presidente: PONCE DE LEON GARCIA JOSE MARIA. Consejero: PONCE DE LEON GARCIA JOSEMARIA;MORENO ELETA MIGUEL ANGEL. Secretario: PONCE DE LEON GARCIA ADELA. Con.Delegado: PONCE DE LEONGARCIA ADELA. Consejero: PONCE DE LEON GARCIA ADELA;GARZON PONCE DE LEON ROCIO. Revocaciones. Apoderado:GARCIA SALMERON ILUMINADO;SANCHEZ RUBIA LUIS;PONCE DE LEON GARCIA JOSE MARIA;MANDEL CONSULTORESSOCIEDAD LIMITADA;GARCIA SALMERON ILUMINADO. Nombramientos. Adm. Solid.: LOPEZ MALDONADO MIGUELANGEL;LOPEZ MALDONADO MANUEL ANDRES. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 988, L 752, F 59, S 8, H AB 11605, I/A 16 ( 8.06.21).
15 de Noviembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: PONCE DE LEON GARCIA MARIA ELISA. Nombramientos. Consejero: GARZON PONCE DELEON ROCIO. Datos registrales. T 988, L 752, F 59, S 8, H AB 11605, I/A 15 ( 7.11.18).
27 de Noviembre de 2017Revocaciones. Apoderado: GARCIA SALMERON ILUMINADO. Datos registrales. T 951, L 715, F 193, S 8, H AB 11605, I/A 13(20.11.17).
Nombramientos. Apoderado: MANDEL CONSULTORES SOCIEDAD LIMITADA;GARCIA SALMERON ILUMINADO. Datosregistrales. T 951, L 715, F 193, S 8, H AB 11605, I/A 14 (20.11.17).
26 de Mayo de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PONCE DE LEON GARCIA ADELA. Nombramientos. Consejero: PONCE DE LEON GARCIAJOSE MARIA;PONCE DE LEON GARCIA ADELA;PONCE DE LEON GARCIA MARIA ELISA;MORENO ELETA MIGUEL ANGEL.Presidente: PONCE DE LEON GARCIA JOSE MARIA. Secretario: PONCE DE LEON GARCIA ADELA. Con.Delegado: PONCE DELEON GARCIA ADELA. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n.Datos registrales. T 951, L 715, F 193, S 8, H AB 11605, I/A 11 (19.05.16).
05 de Febrero de 2015Nombramientos. Apoderado: GARCIA SALMERON ILUMINADO. Datos registrales. T 950, L 714, F 118, S 8, H AB 11605, I/A 11(29.01.15).
03 de Febrero de 2015Modificaciones estatutarias. ARTICULO 9. 3.- Retribuci贸n. El cargo de administrador ser谩 retribuido. La retribuci贸n no tendr谩 comobase una participaci贸n de los beneficios, sino que ser谩 una cantidad para cada ejercicio por acuerdo de la Junta General. El caracterretribuido del cargo ser谩 compatible con la posibilidad de una. Datos registrales. T 950, L 714, F 118, S 8, H AB 11605, I/A 10(27.01.15).
30 de Diciembre de 2014Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 99.607,26 Euros. Resultante Suscrito: 261.000,00 Euros. Datos registrales. T 920, L 684,F 138, S 8, H AB 11605, I/A 9 (19.12.14).
06 de Agosto de 2012Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ RUBIA LUIS. Datos registrales. T 919, L 683, F 181, S 8, H AB 11605, I/A 7 (26.07.12).
Nombramientos. Apoderado: PONCE DE LEON GARCIA JOSE MARIA. Datos registrales. T 920, L 684, F 138, S 8, H AB 11605,I/A 8 (26.07.12).
10 de Julio de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 120.202,42 Euros. Resultante Suscrito: 360.607,26 Euros. Datos registrales. T 919, L 683, F 181, S8, H AB 11605, I/A 6 (29.06.12).