Actos BORME de Agricola Rianzuela Sl
24 de Noviembre de 2015Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ-FIGUEROA MORENO IGNACIO. Datos registrales. T 7519 , F 92, S 8, H M 121647, I/A11 (16.11.15).
01 de Junio de 2015Revocaciones. Apoderado: TEPRO CONSULTORES AGRICOLAS SL. Datos registrales. T 7519 , F 92, S 8, H M 121647, I/A 10(22.05.15).
08 de Mayo de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 6.172,27 Euros. Resultante Suscrito: 42.502,72 Euros. Datos registrales. T 7519 , F 91, S 8, H M121647, I/A 9 (24.04.12).
15 de Abril de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: MARQUEZ PATI脩O MARIA CRISTINA. Presidente: MARQUEZ PATI脩O MARIA CRISTINA.Con.Delegado: MARQUEZ PATI脩O MARIA CRISTINA. Nombramientos. Presidente: LORA MARQUEZ MARIA CRISTINA.Con.Delegado: LORA MARQUEZ MARIA CRISTINA. Consejero: DE-LORA ALARCON CRISTINA. Reelecciones. Consejero: LORAMARQUEZ IVAN;LORA MARQUEZ MARIA CRISTINA;LORA MARQUEZ VERONICA;DE LORA MARQUEZ CECILIA. Secretario: DELORA MARQUEZ IVAN. Cambio de domicilio social. C/ VELAZQUEZ 59 5 - IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 7519 , F91, S 8, H M 121647, I/A 8 ( 6.04.11).
27 de Enero de 2011Nombramientos. Apoderado: DE LORA MARQUEZ IVAN;LORA MARQUEZ MARIA CRISTINA;LORA MARQUEZ VERONICA.Datos registrales. T 7519 , F 89, S 8, H M 121647, I/A 7 (17.01.11).
28 de Enero de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 4.747,90 Euros. Resultante Suscrito: 36.330,45 Euros. Modificaciones estatutarias. 8. . Datosregistrales. T 7519 , F 88, S 8, H M 121647, I/A 6 (19.01.09).