Actos BORME de Agrios La Galera Sa
13 de Marzo de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: BORRAS MONTALVA FRANCISCO;SALOM BORRAS VICENTE;PEREZ MARTINEZ FERNANDO.Presidente: BORRAS MONTALVA FRANCISCO. Secretario: SALOM BORRAS VICENTE. Nombramientos. Consejero: FERNANDOPEREZ MARTINEZ. Presidente: FERNANDO PEREZ MARTINEZ. Consejero: SALOM BORRAS VICENTE. Secretario: SALOMBORRAS VICENTE. Consejero: BORRAS SIERRA SUSANA LILIANA;BORRAS SIERRA CRISTINA;PEREZ MARTINEZ MARIAGRACIA.Cons.Del.Sol: PEREZ MARTINEZ MARIA GRACIA;BORRAS SIERRA CRISTINA. Modificaciones estatutarias.MODIFICADA LA REDACCION DEL ARTICULO 23º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y POR CONSIGUIENTE MODIFICADO ELSISTEMA DE RETRIBUCION DEL ORGANO DE ADMINISTRAION.. Datos registrales. T 6887, L 4190, F 27, S 8, H V 77309, I/A 16( 6.03.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: BORRAS SIERRA SUSANA LILIANA;BORRAS SIERRA CRISTINA;PEREZ MARTINEZ MARIA GRACIA.Datos registrales. T 6887, L 4190, F 28, S 8, H V 77309, I/A 17 ( 6.03.23).
16 de Mayo de 2017Reelecciones. Consejero: BORRAS MONTALVA FRANCISCO;SALOM BORRAS VICENTE;PEREZ MARTINEZ FERNANDO.Presidente: BORRAS MONTALVA FRANCISCO. Secretario: SALOM BORRAS VICENTE. Datos registrales. T 6887, L 4190, F 27, S8, H V 77309, I/A 15 ( 8.05.17).
23 de Febrero de 2017Nombramientos. Apoderado: PEREZ MARTINEZ FERNANDO. Datos registrales. T 6887, L 4190, F 26, S 8, H V 77309, I/A 14(16.02.17).
19 de Enero de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: BORRAS MONTALVA FRANCISCO;SALOM BORRAS VICENTE. Presidente: BORRAS MONTALVAFRANCISCO. Secretario: SALOM BORRAS VICENTE. Consejero: PEREZ MARTINEZ FERNANDO. Nombramientos. Consejero:BORRAS MONTALVA FRANCISCO. Presidente: BORRAS MONTALVA FRANCISCO. Consejero: SALOM BORRAS VICENTE.Secretario: SALOM BORRAS VICENTE. Consejero: PEREZ MARTINEZ FERNANDO. Ampliación de capital. Suscrito: 250.100,00Euros. Desembolsado: 250.100,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.812.310,00 Euros. Resultante Desembolsado: 1.812.310,00 Euros.Datos registrales. T 6887, L 4190, F 26, S 8, H V 77309, I/A 13 (10.01.12).
30 de Diciembre de 2010Nombramientos. Apoderado: PEREZ MARTINEZ FERNANDO. Datos registrales. T 6887, L 4190, F 26, S 8, H V 77309, I/A 12(21.12.10).
25 de Junio de 2010Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: BORRAS MONTALVA FRANCISCO. Datos registrales. T 6887, L 4190, F 25, S 8, H V 77309,I/A 11 (16.06.10).
23 de Junio de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ GIL FERNANDO. Nombramientos. Consejero: PEREZ MARTINEZ FERNANDO. Datosregistrales. T 6887, L 4190, F 25, S 8, H V 77309, I/A 10 (14.06.10).
11 de Marzo de 2009Ampliación de capital. Suscrito: 359.900,00 Euros. Desembolsado: 359.900,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.562.210,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.562.210,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Modificación de los artículos5º y 6º de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 6887, L 4190, F 25, S 8, H V 77309, I/A 9 ( 2.03.09).