Actos BORME de Agroalimentaria Del Sur Sa
13 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apoderado: MIRANDA SIMAVILLA JUAN. Datos registrales. T 4572 , F 146, S 8, H Z 3265, I/A 93 ( 3.11.23).
10 de Noviembre de 2023Revocaciones. Apoderado: MIRANDA SIMAVILLA JUAN. Datos registrales. T 4572 , F 146, S 8, H Z 3265, I/A 92 ( 2.11.23).
17 de Agosto de 2023Nombramientos. Auditor: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 4572 , F 146, S 8, H Z 3265, I/A 91 (9.08.23).
02 de Marzo de 2023Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 11.626.400,00 Euros. Desembolsado: 11.626.400,00 Euros. Resultante Suscrito: 65.677.800,00Euros. Resultante Desembolsado: 65.677.800,00 Euros. Datos registrales. T 4572 , F 145, S 8, H Z 3265, I/A 90 (24.02.23).
05 de Julio de 2022Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ BOLIVAR MIGUEL;GARCIA BARBA CRISTOBAL;GARRIDO PULIDOFERNANDO;ALCU脩A MARTINEZ ANTONIO. Datos registrales. T 4572 , F 144, S 8, H Z 3265, I/A 89 (29.06.22).
14 de Febrero de 2022Revocaciones. Apoderado: HERRANDO PE脩A FERNANDO;GAMIZ MARTINEZ JUAN;GAMIZ MARTINEZ JUAN BAUTISTA;PAULBRUNED MIGUEL;BARROSO DORADO ANDRES. Datos registrales. T 4461 , F 121, S 8, H Z 3265, I/A 77 ( 4.02.22).
Nombramientos. Apoderado: BARROSO DORADO ANDRES. Datos registrales. T 4461 , F 121, S 8, H Z 3265, I/A 78 ( 4.02.22).
Nombramientos. Apoderado: PAUL BRUNED MIGUEL. Datos registrales. T 4461 , F 122, S 8, H Z 3265, I/A 79 ( 4.02.22).
Nombramientos. Apoderado: TURBICA MORENA CARLOS. Datos registrales. T 4461 , F 123, S 8, H Z 3265, I/A 80 ( 4.02.22).
Nombramientos. Apoderado: HERRANDO PE脩A FERNANDO. Datos registrales. T 4572 , F 138, S 8, H Z 3265, I/A 81 ( 4.02.22).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ DURAN JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 4572 , F 139, S 8, H Z 3265, I/A 82 (4.02.22).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ BOLIVAR MIGUEL. Datos registrales. T 4572 , F 140, S 8, H Z 3265, I/A 83 ( 4.02.22).
Nombramientos. Apoderado: ROMERO MU脩OZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 4572 , F 141, S 8, H Z 3265, I/A 84 (4.02.22).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA BARBA CRISTOBAL. Datos registrales. T 4572 , F 141, S 8, H Z 3265, I/A 85 ( 4.02.22).
Nombramientos. Apoderado: GARRIDO PULIDO FERNANDO. Datos registrales. T 4572 , F 142, S 8, H Z 3265, I/A 86 ( 4.02.22).
Nombramientos. Apoderado: REVILLA TERCE脩O ISIDRO. Datos registrales. T 4572 , F 143, S 8, H Z 3265, I/A 87 ( 4.02.22).
Nombramientos. Apoderado: ALCU脩A MARTINEZ ANTONIO. Datos registrales. T 4572 , F 144, S 8, H Z 3265, I/A 88 ( 4.02.22).
09 de Febrero de 2022Revocaciones. Apoderado: FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 4461 , F 121, S 8, H Z 3265, I/A 76 ( 2.02.22).
29 de Diciembre de 2021Nombramientos. Apoderado: ESCOSA GONZALEZ JESUS MARIA. Datos registrales. T 4461 , F 120, S 8, H Z 3265, I/A 75(22.12.21).
20 de Octubre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Presidente: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Datos registrales. T 4461 ,F 120, S 8, H Z 3265, I/A 73 (13.10.21).
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MIRANDA SIMAVILLA JUAN. Vicepresid.: LUENGO EGIDO JAVIER. Nombramientos.Consejero: FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL. Secretario: FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL. Cons.Del.Sol: FRAJ GASCON MIGUELANGEL. Presidente: LUENGO EGIDO JAVIER. Otros conceptos: Cambiado el representante del consejero SA MINERACATALANO ARAGONESA. Datos registrales. T 4461 , F 120, S 8, H Z 3265, I/A 74 (13.10.21).
27 de Julio de 2021Nombramientos. Apoderado: MIRANDA SIMAVILLA JUAN. Datos registrales. T 4461 , F 119, S 8, H Z 3265, I/A 72 (20.07.21).
21 de Junio de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Presidente: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Consejero: LUENGOEGIDO JAVIER. Secretario: LUENGO EGIDO JAVIER. Con.Delegado: LUENGO EGIDO JAVIER. Consejero: SOCIEDAD ANONIMAMINERA CATALANO ARAGONESA. Nombramientos. SecreNoConsj: MIRANDA SIMAVILLA JUAN. Consejero: LUENGOMARTINEZ ANGEL;SOCIEDAD ANONIMA MINERA CATALANO ARAGONESA;LUENGO EGIDO JAVIER. Presidente: LUENGOMARTINEZ ANGEL. Vicepresid.: LUENGO EGIDO JAVIER. Con.Delegado: LUENGO EGIDO JAVIER. Datos registrales. T 4461 , F118, S 8, H Z 3265, I/A 70 (10.06.21).
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 7.545.500,00 Euros. Desembolsado: 7.545.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 54.051.400,00 Euros.Resultante Desembolsado: 54.051.400,00 Euros. Datos registrales. T 4461 , F 119, S 8, H Z 3265, I/A 71 (10.06.21).
05 de Marzo de 2021Cambio de domicilio social. C/ BILBAO 5 - LOCAL (ZARAGOZA). Datos registrales. T 4461 , F 118, S 8, H Z 3265, I/A 69(26.02.21).
02 de Marzo de 2021Nombramientos. Auditor: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 4461 , F 118, S 8, H Z 3265, I/A 68(22.02.21).
02 de Julio de 2020P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 11.005.900,00 Euros. Desembolsado: 11.005.900,00Euros. Resultante Suscrito: 46.505.900,00 Euros. Resultante Desembolsado: 46.505.900,00 Euros. Datos registrales. T 4461 , F 116,S 8, H Z 3265, I/A 67 (26.06.20).
27 de Marzo de 2020Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: COMPA脩IA AGRICOLA TESORILLO SA. HACIENDA ATALAYA DEL EBRO SL.AGRICOLA DE LAS CORONAS SL. Datos registrales. T 4461 , F 116, S 8, H Z 3265, I/A 65 (20.03.20).
Cambio de objeto social. a) La actividad agraria; y b) el arrendamiento de inmuebles r煤sticos. Datos registrales. T 4461 , F 116, S8, H Z 3265, I/A 66 (20.03.20).
19 de Marzo de 2020Cambio de objeto social. Adquisici贸n de fincas agricolas, su transformaci贸n y mejora, concentraci贸n y desconcentraci贸n de ellas,producci贸n, comercializaci贸n, industrializaci贸n y exportaci贸n de toda clase de productos de agricultura y ganader铆a, y de maquinaria oelementos para ellas y el arrendamiento de fincas r煤sticas. Datos registrales. T 4156 , F 79, S 8, H Z 3265, I/A 64 (13.03.20).
10 de Febrero de 2020Otros conceptos: Revocada la facultad 19陋 del poder conferido a favor de don Juan-Carlos Rituerto G贸mez, que consta en lainscripci贸n 52陋 de la hoja de la sociedad. Datos registrales. T 4156 , F 79, S 8, H Z 3265, I/A 63 ( 4.02.20).
07 de Febrero de 2020Nombramientos. Apoderado: GAMIZ MARTINEZ JUAN BAUTISTA. Datos registrales. T 4156 , F 78, S 8, H Z 3265, I/A 62(31.01.20).
16 de Octubre de 2019Revocaciones. Apoderado: VARGAS LEPE JUAN. Datos registrales. T 4156 , F 78, S 8, H Z 3265, I/A 61 ( 9.10.19).
14 de Octubre de 2019Nombramientos. Apoderado: VARGAS LEPE JUAN. Datos registrales. T 4156 , F 77, S 8, H Z 3265, I/A 60 ( 7.10.19).
20 de Agosto de 2019Nombramientos. Apoderado: BARROSO DORADO ANDRES. Datos registrales. T 4156 , F 76, S 8, H Z 3265, I/A 57 ( 9.08.19).
Revocaciones. Apoderado: CALDERERO SUAREZ DANIEL;ALBANO MAESTRE JORGE. Datos registrales. T 4156 , F 76, S 8, HZ 3265, I/A 58 ( 9.08.19).
Nombramientos. Apoderado: VARGAS LEPE JUAN. Datos registrales. T 4156 , F 77, S 8, H Z 3265, I/A 59 ( 9.08.19).
18 de Junio de 2019Revocaciones. Apoderado: GERSOL PEREZ-ANGULO JOSE-MANUEL;GERSOL PEREZ-ANGULO JOSE-MANUEL. Datosregistrales. T 4156 , F 74, S 8, H Z 3265, I/A 54 (11.06.19).
Nombramientos. Apoderado: PAUL BRUNED MIGUEL. Datos registrales. T 4156 , F 74, S 8, H Z 3265, I/A 55 (11.06.19).
Nombramientos. Apoderado: GAMIZ MARTINEZ JUAN BAUTISTA. Datos registrales. T 4156 , F 75, S 8, H Z 3265, I/A 56(11.06.19).
24 de Enero de 2018Nombramientos. Apo.D.Gral.: RITUERTO GOMEZ JUAN-CARLOS. Datos registrales. T 4156 , F 72, S 8, H Z 3265, I/A 52(17.01.18).
Revocaciones. Apo.D.Gral.: RITUERTO GOMEZ JUAN-CARLOS. Datos registrales. T 4156 , F 74, S 8, H Z 3265, I/A 53(17.01.18).
08 de Febrero de 2017Revocaciones. Apoderado: IRACHE PASAMAR VICTOR;CARRACEDO TORRES CARLOS;VILLARIG TOMAS PABLO;LABRADORMARTIN MANUEL-JUSTO. Datos registrales. T 4156 , F 72, S 8, H Z 3265, I/A 51 (26.01.17).
30 de Enero de 2017Nombramientos. Apoderado: GERSOL PEREZ-ANGULO JOSE-MANUEL. Datos registrales. T 4156 , F 70, S 8, H Z 3265, I/A 48(23.01.17).
Nombramientos. Apoderado: CALDERERO SUAREZ DANIEL. Datos registrales. T 4156 , F 71, S 8, H Z 3265, I/A 49 (23.01.17).
Nombramientos. Apoderado: ALBANO MAESTRE JORGE. Datos registrales. T 4156 , F 71, S 8, H Z 3265, I/A 50 (23.01.17).
26 de Febrero de 2016Nombramientos. Apo.D.Gral.: RIVERA BELLOC ALFONSO. Datos registrales. T 4156 , F 69, S 8, H Z 3265, I/A 46 (18.02.16).
Nombramientos. Apoderado: FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 4156 , F 70, S 8, H Z 3265, I/A 47 (18.02.16).
23 de Febrero de 2016Revocaciones. Apoderado: LIZARRAGA CORTES FERNANDO;GONZALEZ CASBAS FERNANDO-JAVIER;LABRADOR MARTINMANUEL-JUSTO;GONZALEZ LAMANA PABLO-CRUZ;LORES LACAMBRA JESUS;FERNANDO ARA ISMAEL;HERRANDO PE脩AFERNANDO. Apo.Man.Soli: DEL ORDEN OLASAGASTI JORGE;RIVERA BELLOCH ALFONSO;RITUERTO GOMEZ JUAN-CARLOS.Apoderado: HERRANDO PE脩A FERNANDO. Datos registrales. T 3962 , F 20, S 8, H Z 3265, I/A 37 (15.02.16).
Nombramientos. Apoderado: LABRADOR MARTIN MANUEL-JUSTO. Datos registrales. T 3962 , F 21, S 8, H Z 3265, I/A 38(15.02.16).
Nombramientos. Apoderado: VILLARIG TOMAS PABLO. Datos registrales. T 3962 , F 21, S 8, H Z 3265, I/A 39 (15.02.16).
Nombramientos. Apoderado: HERRANDO PE脩A FERNANDO. Datos registrales. T 3962 , F 22, S 8, H Z 3265, I/A 40 (15.02.16).
Nombramientos. Apoderado: GAMIZ MARTINEZ JUAN. Datos registrales. T 3962 , F 22, S 8, H Z 3265, I/A 41 (16.02.16).
Nombramientos. Apoderado: CARRACEDO TORRES CARLOS. Datos registrales. T 3962 , F 23, S 8, H Z 3265, I/A 42 (16.02.16).
Nombramientos. Apoderado: IRACHE PASAMAR VICTOR. Datos registrales. T 3962 , F 23, S 8, H Z 3265, I/A 43 (16.02.16).
Nombramientos. Apoderado: GERSOL PEREZ-ANGULO JOSE-MANUEL. Datos registrales. T 3962 , F 24, S 8, H Z 3265, I/A 44(16.02.16).
Nombramientos. Apo.D.Gral.: RITUERTO GOMEZ JUAN-CARLOS. Datos registrales. T 4156 , F 68, S 8, H Z 3265, I/A 45(16.02.16).
28 de Enero de 2016Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 6.500.000,00 Euros. Desembolsado: 6.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 35.500.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 35.500.000,00 Euros. Datos registrales. T 3962 , F 20, S 8, H Z 3265, I/A 36 (20.01.16).
07 de Octubre de 2015Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: AGRICOLA DE FRUTOS DE EXPORTACION SA. FRUTOS DE ANDALUCIA SA.FRUTOS DEL GUADALQUIVIR SA. COMPA脩IA EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SOL SA. Datos registrales. T 3962 , F 20, S 8,H Z 3265, I/A 35 (30.09.15).
09 de Julio de 2015Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SA MINERA CATALANO ARAGONESA. Ceses/Dimisiones. Consejero: LUENGOMARTINEZ ANGEL. Presidente: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Cons.Del.Sol: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Consejero: SA MINERACATALANO ARAGONESA. Secretario: SA MINERA CATALANO ARAGONESA. Con.Delegado: SA MINERA CATALANOARAGONESA. Consejero: LUENGO EGIDO JAVIER. Cons.Del.Sol: LUENGO EGIDO JAVIER. Nombramientos. Consejero:LUENGO MARTINEZ ANGEL. Presidente: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Consejero: LUENGO EGIDO JAVIER. Secretario: LUENGOEGIDO JAVIER. Con.Delegado: LUENGO EGIDO JAVIER. Consejero: SA MINERA CATALANO ARAGONESA. Otros conceptos:Se nombra como representante de SA MINERA CATALANO ARAGONESA a Don Miguel Angel Fraj Gasc贸n en sustituco de DonGregorio Luengo Sanz. Datos registrales. T 3962 , F 19, S 8, H Z 3265, I/A 34 ( 1.07.15).
25 de Febrero de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: DEL ORDEN OLASAGASTI JORGE;RIVERA BELLOCH ALFONSO;RITUERTO GOMEZ JUAN-CARLOS. Datos registrales. T 2663 , F 39, S 8, H Z 3265, I/A 32 (17.02.14).
Nombramientos. Apoderado: HERRANDO PE脩A FERNANDO. Datos registrales. T 3962 , F 19, S 8, H Z 3265, I/A 33 (17.02.14).
14 de Febrero de 2014Nombramientos. Apoderado: HERRANDO PE脩A FERNANDO. Datos registrales. T 2663 , F 39, S 8, H Z 3265, I/A 31 ( 6.02.14).
27 de Enero de 2014Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 147,70 Euros. Desembolsado: 147,70 Euros. Resultante Suscrito: 92.000,00 Euros. ResultanteDesembolsado: 92.000,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 28.908.000,00 Euros. Desembolsado: 28.908.000,00 Euros.Resultante Suscrito: 29.000.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 29.000.000,00 Euros. Otros conceptos: Se modifica eln煤mero de acciones nominativas en que se divide el capital social (que pasa de 920.000 a 920) y el valor nominal de dichas acciones(que pasa de 0,10 euros a 100 euros); con la consiguiente modificaci贸n del Art铆culo Quinto de los Estatutos Sociales. Datosregistrales. T 2663 , F 38, S 8, H Z 3265, I/A 30 (17.01.14).
22 de Enero de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: LIZARRAGA CORTES FERNANDO. Vicepresid.: LIZARRAGA CORTES FERNANDO. Cons.Del.Sol:LIZARRAGA CORTES FERNANDO. Nombramientos. Consejero: LUENGO EGIDO JAVIER. Cons.Del.Sol: LUENGO EGIDOJAVIER. Datos registrales. T 2663 , F 38, S 8, H Z 3265, I/A 29 (14.01.14).
20 de Noviembre de 2012Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 2.691.486,00 Euros. Desembolsado: 2.691.486,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.755.569,00 Euros.Resultante Desembolsado: 2.755.569,00 Euros. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.663.716,70 Euros. Resultante Suscrito:91.852,30 Euros. Datos registrales. T 2663 , F 38, S 8, H Z 3265, I/A 28 ( 6.11.12).
21 de Febrero de 2012Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: LUENGO SANZ GREGORIO. Secretario: LUENGO SANZ GREGORIO. Consejero: LUENGOSANZ GREGORIO. Nombramientos. Consejero: SA MINERA CATALANO ARAGONESA. Secretario: SA MINERA CATALANOARAGONESA. Con.Delegado: SA MINERA CATALANO ARAGONESA. Datos registrales. T 2663 , F 38, S 8, H Z 3265, I/A 27 (9.02.12).
24 de Noviembre de 2011Nombramientos. Auditor: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA P. Datos registrales. T 2663 , F 37, S 8, H Z3265, I/A 26 (11.11.11).
14 de Septiembre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: LORES LACAMBRA JESUS. Vicesecret.: LORES LACAMBRA JESUS. Nombramientos.Cons.Del.Sol: LIZARRAGA CORTES FERNANDO;LUENGO MARTINEZ ANGEL;LUENGO SANZ GREGORIO. Reelecciones.Consejero: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Presidente: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Consejero: LUENGO SANZ GREGORIO.Secretario: LUENGO SANZ GREGORIO. Consejero: LIZARRAGA CORTES FERNANDO. Vicepresid.: LIZARRAGA CORTESFERNANDO. Modificaciones estatutarias. ""ARTICULO 12.-" La Administraci贸n de la sociedad se conf铆a al Consejo deAdministraci贸n, que estar谩 integrado por tres miembros como m铆nimo y siete como m谩ximo. Corresponde a laJunta General ladeterminaci贸n del n煤mero de Consejeros, as铆 como su nombramiento y separaci贸n. El cargo de Consejero es. Datos registrales. T2663 , F 37, S 8, H Z 3265, I/A 25 ( 3.09.10).
25 de Noviembre de 2009Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 576.747,00 Euros. Resultante Suscrito: 64.083,00 Euros. Datos registrales. T 2663 , F 37,S 8, H Z 3265, I/A 24 (16.11.09).