Buscador CIF Logo

Actos BORME Agroalimentaria Del Sur Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Agroalimentaria Del Sur Sa

Actos BORME Agroalimentaria Del Sur Sa - A50102201

Tenemos registrados 70 Actos BORME del Registro Mercantil de Zaragoza para Agroalimentaria Del Sur Sa con CIF A50102201

馃敊 Perfil de Agroalimentaria Del Sur Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Zaragoza

Actos BORME de Agroalimentaria Del Sur Sa

13 de Noviembre de 2023
Nombramientos. Apoderado: MIRANDA SIMAVILLA JUAN. Datos registrales. T 4572 , F 146, S 8, H Z 3265, I/A 93 ( 3.11.23).

10 de Noviembre de 2023
Revocaciones. Apoderado: MIRANDA SIMAVILLA JUAN. Datos registrales. T 4572 , F 146, S 8, H Z 3265, I/A 92 ( 2.11.23).

17 de Agosto de 2023
Nombramientos. Auditor: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 4572 , F 146, S 8, H Z 3265, I/A 91 (9.08.23).

02 de Marzo de 2023
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 11.626.400,00 Euros. Desembolsado: 11.626.400,00 Euros. Resultante Suscrito: 65.677.800,00Euros. Resultante Desembolsado: 65.677.800,00 Euros. Datos registrales. T 4572 , F 145, S 8, H Z 3265, I/A 90 (24.02.23).

05 de Julio de 2022
Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ BOLIVAR MIGUEL;GARCIA BARBA CRISTOBAL;GARRIDO PULIDOFERNANDO;ALCU脩A MARTINEZ ANTONIO. Datos registrales. T 4572 , F 144, S 8, H Z 3265, I/A 89 (29.06.22).

14 de Febrero de 2022
Revocaciones. Apoderado: HERRANDO PE脩A FERNANDO;GAMIZ MARTINEZ JUAN;GAMIZ MARTINEZ JUAN BAUTISTA;PAULBRUNED MIGUEL;BARROSO DORADO ANDRES. Datos registrales. T 4461 , F 121, S 8, H Z 3265, I/A 77 ( 4.02.22).

Nombramientos. Apoderado: BARROSO DORADO ANDRES. Datos registrales. T 4461 , F 121, S 8, H Z 3265, I/A 78 ( 4.02.22).

Nombramientos. Apoderado: PAUL BRUNED MIGUEL. Datos registrales. T 4461 , F 122, S 8, H Z 3265, I/A 79 ( 4.02.22).

Nombramientos. Apoderado: TURBICA MORENA CARLOS. Datos registrales. T 4461 , F 123, S 8, H Z 3265, I/A 80 ( 4.02.22).

Nombramientos. Apoderado: HERRANDO PE脩A FERNANDO. Datos registrales. T 4572 , F 138, S 8, H Z 3265, I/A 81 ( 4.02.22).

Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ DURAN JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 4572 , F 139, S 8, H Z 3265, I/A 82 (4.02.22).

Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ BOLIVAR MIGUEL. Datos registrales. T 4572 , F 140, S 8, H Z 3265, I/A 83 ( 4.02.22).

Nombramientos. Apoderado: ROMERO MU脩OZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 4572 , F 141, S 8, H Z 3265, I/A 84 (4.02.22).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA BARBA CRISTOBAL. Datos registrales. T 4572 , F 141, S 8, H Z 3265, I/A 85 ( 4.02.22).

Nombramientos. Apoderado: GARRIDO PULIDO FERNANDO. Datos registrales. T 4572 , F 142, S 8, H Z 3265, I/A 86 ( 4.02.22).

Nombramientos. Apoderado: REVILLA TERCE脩O ISIDRO. Datos registrales. T 4572 , F 143, S 8, H Z 3265, I/A 87 ( 4.02.22).

Nombramientos. Apoderado: ALCU脩A MARTINEZ ANTONIO. Datos registrales. T 4572 , F 144, S 8, H Z 3265, I/A 88 ( 4.02.22).

09 de Febrero de 2022
Revocaciones. Apoderado: FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 4461 , F 121, S 8, H Z 3265, I/A 76 ( 2.02.22).

29 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: ESCOSA GONZALEZ JESUS MARIA. Datos registrales. T 4461 , F 120, S 8, H Z 3265, I/A 75(22.12.21).

20 de Octubre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Presidente: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Datos registrales. T 4461 ,F 120, S 8, H Z 3265, I/A 73 (13.10.21).

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MIRANDA SIMAVILLA JUAN. Vicepresid.: LUENGO EGIDO JAVIER. Nombramientos.Consejero: FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL. Secretario: FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL. Cons.Del.Sol: FRAJ GASCON MIGUELANGEL. Presidente: LUENGO EGIDO JAVIER. Otros conceptos: Cambiado el representante del consejero SA MINERACATALANO ARAGONESA. Datos registrales. T 4461 , F 120, S 8, H Z 3265, I/A 74 (13.10.21).

27 de Julio de 2021
Nombramientos. Apoderado: MIRANDA SIMAVILLA JUAN. Datos registrales. T 4461 , F 119, S 8, H Z 3265, I/A 72 (20.07.21).

21 de Junio de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Presidente: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Consejero: LUENGOEGIDO JAVIER. Secretario: LUENGO EGIDO JAVIER. Con.Delegado: LUENGO EGIDO JAVIER. Consejero: SOCIEDAD ANONIMAMINERA CATALANO ARAGONESA. Nombramientos. SecreNoConsj: MIRANDA SIMAVILLA JUAN. Consejero: LUENGOMARTINEZ ANGEL;SOCIEDAD ANONIMA MINERA CATALANO ARAGONESA;LUENGO EGIDO JAVIER. Presidente: LUENGOMARTINEZ ANGEL. Vicepresid.: LUENGO EGIDO JAVIER. Con.Delegado: LUENGO EGIDO JAVIER. Datos registrales. T 4461 , F118, S 8, H Z 3265, I/A 70 (10.06.21).

Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 7.545.500,00 Euros. Desembolsado: 7.545.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 54.051.400,00 Euros.Resultante Desembolsado: 54.051.400,00 Euros. Datos registrales. T 4461 , F 119, S 8, H Z 3265, I/A 71 (10.06.21).

05 de Marzo de 2021
Cambio de domicilio social. C/ BILBAO 5 - LOCAL (ZARAGOZA). Datos registrales. T 4461 , F 118, S 8, H Z 3265, I/A 69(26.02.21).

02 de Marzo de 2021
Nombramientos. Auditor: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 4461 , F 118, S 8, H Z 3265, I/A 68(22.02.21).

02 de Julio de 2020
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 11.005.900,00 Euros. Desembolsado: 11.005.900,00Euros. Resultante Suscrito: 46.505.900,00 Euros. Resultante Desembolsado: 46.505.900,00 Euros. Datos registrales. T 4461 , F 116,S 8, H Z 3265, I/A 67 (26.06.20).

27 de Marzo de 2020
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: COMPA脩IA AGRICOLA TESORILLO SA. HACIENDA ATALAYA DEL EBRO SL.AGRICOLA DE LAS CORONAS SL. Datos registrales. T 4461 , F 116, S 8, H Z 3265, I/A 65 (20.03.20).

Cambio de objeto social. a) La actividad agraria; y b) el arrendamiento de inmuebles r煤sticos. Datos registrales. T 4461 , F 116, S8, H Z 3265, I/A 66 (20.03.20).

19 de Marzo de 2020
Cambio de objeto social. Adquisici贸n de fincas agricolas, su transformaci贸n y mejora, concentraci贸n y desconcentraci贸n de ellas,producci贸n, comercializaci贸n, industrializaci贸n y exportaci贸n de toda clase de productos de agricultura y ganader铆a, y de maquinaria oelementos para ellas y el arrendamiento de fincas r煤sticas. Datos registrales. T 4156 , F 79, S 8, H Z 3265, I/A 64 (13.03.20).

10 de Febrero de 2020
Otros conceptos: Revocada la facultad 19陋 del poder conferido a favor de don Juan-Carlos Rituerto G贸mez, que consta en lainscripci贸n 52陋 de la hoja de la sociedad. Datos registrales. T 4156 , F 79, S 8, H Z 3265, I/A 63 ( 4.02.20).

07 de Febrero de 2020
Nombramientos. Apoderado: GAMIZ MARTINEZ JUAN BAUTISTA. Datos registrales. T 4156 , F 78, S 8, H Z 3265, I/A 62(31.01.20).

16 de Octubre de 2019
Revocaciones. Apoderado: VARGAS LEPE JUAN. Datos registrales. T 4156 , F 78, S 8, H Z 3265, I/A 61 ( 9.10.19).

14 de Octubre de 2019
Nombramientos. Apoderado: VARGAS LEPE JUAN. Datos registrales. T 4156 , F 77, S 8, H Z 3265, I/A 60 ( 7.10.19).

20 de Agosto de 2019
Nombramientos. Apoderado: BARROSO DORADO ANDRES. Datos registrales. T 4156 , F 76, S 8, H Z 3265, I/A 57 ( 9.08.19).

Revocaciones. Apoderado: CALDERERO SUAREZ DANIEL;ALBANO MAESTRE JORGE. Datos registrales. T 4156 , F 76, S 8, HZ 3265, I/A 58 ( 9.08.19).

Nombramientos. Apoderado: VARGAS LEPE JUAN. Datos registrales. T 4156 , F 77, S 8, H Z 3265, I/A 59 ( 9.08.19).

18 de Junio de 2019
Revocaciones. Apoderado: GERSOL PEREZ-ANGULO JOSE-MANUEL;GERSOL PEREZ-ANGULO JOSE-MANUEL. Datosregistrales. T 4156 , F 74, S 8, H Z 3265, I/A 54 (11.06.19).

Nombramientos. Apoderado: PAUL BRUNED MIGUEL. Datos registrales. T 4156 , F 74, S 8, H Z 3265, I/A 55 (11.06.19).

Nombramientos. Apoderado: GAMIZ MARTINEZ JUAN BAUTISTA. Datos registrales. T 4156 , F 75, S 8, H Z 3265, I/A 56(11.06.19).

24 de Enero de 2018
Nombramientos. Apo.D.Gral.: RITUERTO GOMEZ JUAN-CARLOS. Datos registrales. T 4156 , F 72, S 8, H Z 3265, I/A 52(17.01.18).

Revocaciones. Apo.D.Gral.: RITUERTO GOMEZ JUAN-CARLOS. Datos registrales. T 4156 , F 74, S 8, H Z 3265, I/A 53(17.01.18).

08 de Febrero de 2017
Revocaciones. Apoderado: IRACHE PASAMAR VICTOR;CARRACEDO TORRES CARLOS;VILLARIG TOMAS PABLO;LABRADORMARTIN MANUEL-JUSTO. Datos registrales. T 4156 , F 72, S 8, H Z 3265, I/A 51 (26.01.17).

30 de Enero de 2017
Nombramientos. Apoderado: GERSOL PEREZ-ANGULO JOSE-MANUEL. Datos registrales. T 4156 , F 70, S 8, H Z 3265, I/A 48(23.01.17).

Nombramientos. Apoderado: CALDERERO SUAREZ DANIEL. Datos registrales. T 4156 , F 71, S 8, H Z 3265, I/A 49 (23.01.17).

Nombramientos. Apoderado: ALBANO MAESTRE JORGE. Datos registrales. T 4156 , F 71, S 8, H Z 3265, I/A 50 (23.01.17).

26 de Febrero de 2016
Nombramientos. Apo.D.Gral.: RIVERA BELLOC ALFONSO. Datos registrales. T 4156 , F 69, S 8, H Z 3265, I/A 46 (18.02.16).

Nombramientos. Apoderado: FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 4156 , F 70, S 8, H Z 3265, I/A 47 (18.02.16).

23 de Febrero de 2016
Revocaciones. Apoderado: LIZARRAGA CORTES FERNANDO;GONZALEZ CASBAS FERNANDO-JAVIER;LABRADOR MARTINMANUEL-JUSTO;GONZALEZ LAMANA PABLO-CRUZ;LORES LACAMBRA JESUS;FERNANDO ARA ISMAEL;HERRANDO PE脩AFERNANDO. Apo.Man.Soli: DEL ORDEN OLASAGASTI JORGE;RIVERA BELLOCH ALFONSO;RITUERTO GOMEZ JUAN-CARLOS.Apoderado: HERRANDO PE脩A FERNANDO. Datos registrales. T 3962 , F 20, S 8, H Z 3265, I/A 37 (15.02.16).

Nombramientos. Apoderado: LABRADOR MARTIN MANUEL-JUSTO. Datos registrales. T 3962 , F 21, S 8, H Z 3265, I/A 38(15.02.16).

Nombramientos. Apoderado: VILLARIG TOMAS PABLO. Datos registrales. T 3962 , F 21, S 8, H Z 3265, I/A 39 (15.02.16).

Nombramientos. Apoderado: HERRANDO PE脩A FERNANDO. Datos registrales. T 3962 , F 22, S 8, H Z 3265, I/A 40 (15.02.16).

Nombramientos. Apoderado: GAMIZ MARTINEZ JUAN. Datos registrales. T 3962 , F 22, S 8, H Z 3265, I/A 41 (16.02.16).

Nombramientos. Apoderado: CARRACEDO TORRES CARLOS. Datos registrales. T 3962 , F 23, S 8, H Z 3265, I/A 42 (16.02.16).

Nombramientos. Apoderado: IRACHE PASAMAR VICTOR. Datos registrales. T 3962 , F 23, S 8, H Z 3265, I/A 43 (16.02.16).

Nombramientos. Apoderado: GERSOL PEREZ-ANGULO JOSE-MANUEL. Datos registrales. T 3962 , F 24, S 8, H Z 3265, I/A 44(16.02.16).

Nombramientos. Apo.D.Gral.: RITUERTO GOMEZ JUAN-CARLOS. Datos registrales. T 4156 , F 68, S 8, H Z 3265, I/A 45(16.02.16).

28 de Enero de 2016
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 6.500.000,00 Euros. Desembolsado: 6.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 35.500.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 35.500.000,00 Euros. Datos registrales. T 3962 , F 20, S 8, H Z 3265, I/A 36 (20.01.16).

07 de Octubre de 2015
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: AGRICOLA DE FRUTOS DE EXPORTACION SA. FRUTOS DE ANDALUCIA SA.FRUTOS DEL GUADALQUIVIR SA. COMPA脩IA EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SOL SA. Datos registrales. T 3962 , F 20, S 8,H Z 3265, I/A 35 (30.09.15).

09 de Julio de 2015
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SA MINERA CATALANO ARAGONESA. Ceses/Dimisiones. Consejero: LUENGOMARTINEZ ANGEL. Presidente: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Cons.Del.Sol: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Consejero: SA MINERACATALANO ARAGONESA. Secretario: SA MINERA CATALANO ARAGONESA. Con.Delegado: SA MINERA CATALANOARAGONESA. Consejero: LUENGO EGIDO JAVIER. Cons.Del.Sol: LUENGO EGIDO JAVIER. Nombramientos. Consejero:LUENGO MARTINEZ ANGEL. Presidente: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Consejero: LUENGO EGIDO JAVIER. Secretario: LUENGOEGIDO JAVIER. Con.Delegado: LUENGO EGIDO JAVIER. Consejero: SA MINERA CATALANO ARAGONESA. Otros conceptos:Se nombra como representante de SA MINERA CATALANO ARAGONESA a Don Miguel Angel Fraj Gasc贸n en sustituco de DonGregorio Luengo Sanz. Datos registrales. T 3962 , F 19, S 8, H Z 3265, I/A 34 ( 1.07.15).

25 de Febrero de 2014
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DEL ORDEN OLASAGASTI JORGE;RIVERA BELLOCH ALFONSO;RITUERTO GOMEZ JUAN-CARLOS. Datos registrales. T 2663 , F 39, S 8, H Z 3265, I/A 32 (17.02.14).

Nombramientos. Apoderado: HERRANDO PE脩A FERNANDO. Datos registrales. T 3962 , F 19, S 8, H Z 3265, I/A 33 (17.02.14).

14 de Febrero de 2014
Nombramientos. Apoderado: HERRANDO PE脩A FERNANDO. Datos registrales. T 2663 , F 39, S 8, H Z 3265, I/A 31 ( 6.02.14).

27 de Enero de 2014
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 147,70 Euros. Desembolsado: 147,70 Euros. Resultante Suscrito: 92.000,00 Euros. ResultanteDesembolsado: 92.000,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 28.908.000,00 Euros. Desembolsado: 28.908.000,00 Euros.Resultante Suscrito: 29.000.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 29.000.000,00 Euros. Otros conceptos: Se modifica eln煤mero de acciones nominativas en que se divide el capital social (que pasa de 920.000 a 920) y el valor nominal de dichas acciones(que pasa de 0,10 euros a 100 euros); con la consiguiente modificaci贸n del Art铆culo Quinto de los Estatutos Sociales. Datosregistrales. T 2663 , F 38, S 8, H Z 3265, I/A 30 (17.01.14).

22 de Enero de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: LIZARRAGA CORTES FERNANDO. Vicepresid.: LIZARRAGA CORTES FERNANDO. Cons.Del.Sol:LIZARRAGA CORTES FERNANDO. Nombramientos. Consejero: LUENGO EGIDO JAVIER. Cons.Del.Sol: LUENGO EGIDOJAVIER. Datos registrales. T 2663 , F 38, S 8, H Z 3265, I/A 29 (14.01.14).

20 de Noviembre de 2012
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 2.691.486,00 Euros. Desembolsado: 2.691.486,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.755.569,00 Euros.Resultante Desembolsado: 2.755.569,00 Euros. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.663.716,70 Euros. Resultante Suscrito:91.852,30 Euros. Datos registrales. T 2663 , F 38, S 8, H Z 3265, I/A 28 ( 6.11.12).

21 de Febrero de 2012
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: LUENGO SANZ GREGORIO. Secretario: LUENGO SANZ GREGORIO. Consejero: LUENGOSANZ GREGORIO. Nombramientos. Consejero: SA MINERA CATALANO ARAGONESA. Secretario: SA MINERA CATALANOARAGONESA. Con.Delegado: SA MINERA CATALANO ARAGONESA. Datos registrales. T 2663 , F 38, S 8, H Z 3265, I/A 27 (9.02.12).

24 de Noviembre de 2011
Nombramientos. Auditor: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA P. Datos registrales. T 2663 , F 37, S 8, H Z3265, I/A 26 (11.11.11).

14 de Septiembre de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: LORES LACAMBRA JESUS. Vicesecret.: LORES LACAMBRA JESUS. Nombramientos.Cons.Del.Sol: LIZARRAGA CORTES FERNANDO;LUENGO MARTINEZ ANGEL;LUENGO SANZ GREGORIO. Reelecciones.Consejero: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Presidente: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Consejero: LUENGO SANZ GREGORIO.Secretario: LUENGO SANZ GREGORIO. Consejero: LIZARRAGA CORTES FERNANDO. Vicepresid.: LIZARRAGA CORTESFERNANDO. Modificaciones estatutarias. ""ARTICULO 12.-" La Administraci贸n de la sociedad se conf铆a al Consejo deAdministraci贸n, que estar谩 integrado por tres miembros como m铆nimo y siete como m谩ximo. Corresponde a laJunta General ladeterminaci贸n del n煤mero de Consejeros, as铆 como su nombramiento y separaci贸n. El cargo de Consejero es. Datos registrales. T2663 , F 37, S 8, H Z 3265, I/A 25 ( 3.09.10).

25 de Noviembre de 2009
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 576.747,00 Euros. Resultante Suscrito: 64.083,00 Euros. Datos registrales. T 2663 , F 37,S 8, H Z 3265, I/A 24 (16.11.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n