Actos BORME de Agroalimentaria Musa Sl
28 de Diciembre de 2022Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 2277 , F 224, S 8, H CO 32019, I/A 20 (20.12.22).
25 de Marzo de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: VIGUERA PINO FRANCISCO ASIS;MEDINA GALLEGO FERNANDO;GALLEGO MARTINEZ DIEGO.Datos registrales. T 2277 , F 223, S 8, H CO 32019, I/A 19 (17.03.22).
23 de Diciembre de 2021Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 2277 , F 223, S 8, H CO 32019, I/A 18 (16.12.21).
24 de Marzo de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: HERMOSO GONZALEZ IVAN. Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANTIAGO HURTADO JAVIER.Datos registrales. T 2277 , F 220, S 8, H CO 32019, I/A 17 (12.03.21).
31 de Diciembre de 2020Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 2277 , F 225, S 8, H CO 32019, I/A 16 (23.12.20).
24 de Abril de 2020Revocaciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2277 , F 225, S 8, H CO 32019, I/A15 (16.04.20).
07 de Febrero de 2018Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: GRUPO YBARRA ALIMENTACION SL. Ceses/Dimisiones. Adm.Mancom.: ROSA LUQUE ENRIQUE;SANCHEZ PUERTA DIAZ RAFAEL. Nombramientos. Adm. Mancom.: VIGUERA PINOFRANCISCO ASIS;MEDINA GALLEGO FERNANDO. Datos registrales. T 2277 , F 222, S 8, H CO 32019, I/A 13 (31.01.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MEDINA GALLEGO FERNANDO;GALLEGO MARTINEZ DIEGO;GALLEGO JURADOANTONIO;AFAN RIVERA YBARRA I脩IGO;VIGUERA PINO FRANCISCO ASIS;HERMOSO GONZALEZ IVAN;RODRIGUEZGONCALVEZ MARIA CARMEN. Datos registrales. T 2277 , F 222, S 8, H CO 32019, I/A 14 (31.01.18).
22 de Febrero de 2017Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Nombramientos. Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2277 , F 222, S 8, H CO 32019, I/A 12 (16.02.17).
17 de Agosto de 2016Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2277 , F 221, S 8, H CO 32019, I/A 11 ( 9.08.16).
25 de Enero de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 639.550,00 Euros. Resultante Suscrito: 110.450,00 Euros. Ampliaci贸n de capital.Capital: 639.550,00 Euros. Resultante Suscrito: 750.000,00 Euros. Datos registrales. T 2277 , F 220, S 8, H CO 32019, I/A 10(18.01.16).
26 de Junio de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 44.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 750.000,00 Euros. Datos registrales. T 2277 , F 220, S 8, HCO 32019, I/A 9 (19.06.15).
04 de Mayo de 2015Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: DCOOP SCA. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 706.000,00 Euros.Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital: 706.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 706.000,00 Euros. Datosregistrales. T 2277 , F 160, S 8, H CO 32019, I/A 8 (24.04.15).
02 de Febrero de 2015Revocaciones. Apo.Man.Soli: MORENO MANTECON MIGUEL;PARDO RUIZ MIGUEL;MORENO MENDEZ MIGUELANGEL;TORRES LEIVA JOSE LUIS ALBERTO;MORA PEREZ FRANCISCO ASIS;ORTIZ ARJONA JOSE LUIS;VEGA CHACONJUAN CARLOS;MORENO TORIL CARMEN;OROZCO GONZALEZ PILAR;MORENO MORENO JOSE. Datos registrales. T 2277 , F159, S 8, H CO 32019, I/A 7 (27.01.15).
18 de Noviembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: MORENO MANTECON BALDOMERO. Presidente: MORENO MANTECON BALDOMERO. Consejero:MORENO MORENO JOSE. Vicepresid.: MORENO MORENO JOSE. Consejero: MORA PEREZ FRANCISCO ASIS. Secretario: MORAPEREZ FRANCISCO ASIS. Consejero: MORENO MANTECON MIGUEL;PARDO RUIZ MIGUEL;MORENO MENDEZ MIGUELANGEL;BERNAL LOPEZ JUAN RAMON. Cons.Del.Man: MORENO MANTECON BALDOMERO. Consejero: MORENO TORILCARMEN. Cons.Del.Man: MORENO TORIL CARMEN. Nombramientos. Adm. Mancom.: ROSA LUQUE ENRIQUE;SANCHEZPUERTA DIAZ RAFAEL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n aAdministradores mancomunados. Cambio de domicilio social. CTRA MADRID-CADIZ N-IV Km 389 - BARRIADA DE ALCOLE(CORDOBA). Datos registrales. T 2277 , F 159, S 8, H CO 32019, I/A 6 (11.11.14).
28 de Febrero de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: LUQUE LUQUE ANTONIO. Cons.Del.Man: LUQUE LUQUE ANTONIO. Nombramientos. Consejero:MORENO TORIL CARMEN. Cons.Del.Man: MORENO TORIL CARMEN. Datos registrales. T 2277 , F 158, S 8, H CO 32019, I/A 5(21.02.14).
24 de Septiembre de 2013Ampliaci贸n de capital. Capital: 700.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 706.000,00 Euros. Datos registrales. T 2277 , F 157, S 8, HCO 32019, I/A 4 (17.09.13).
07 de Mayo de 2013Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2277 , F 157, S 8, H CO 32019, I/A 3 (26.04.13).
16 de Mayo de 2012Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORENO MANTECON MIGUEL;PARDO RUIZ MIGUEL;MORENO MENDEZ MIGUELANGEL;TORRES LEIVA JOSE LUIS ALBERTO;MORA PEREZ FRANCISCO ASIS;ORTIZ ARJONA JOSE LUIS;VEGA CHACONJUAN CARLOS;MORENO TORIL CARMEN;OROZCO GONZALEZ PILAR;MORENO MORENO JOSE. Datos registrales. T 2277 , F154, S 8, H CO 32019, I/A 2 ( 4.05.12).
23 de Abril de 2012Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 23.03.12. Objeto social: Promoci贸n, fabricaci贸n, envasado y comercializaci贸n de productosalimenticios, cualquiera que sea el canal de distribuci贸n, as铆 como la importaci贸n yexportaci贸n de productos agroalimentarios decualquier tipo. Domicilio: C/ FUENTE DE LA SADUD 2 (CORDOBA). Capital: 6.000,00 Euros. Nombramientos. Consejero: MORENOMANTECON BALDOMERO. Presidente: MORENO MANTECON BALDOMERO. Consejero: MORENO MORENO JOSE. Vicepresid.:MORENO MORENO JOSE. Consejero: MORA PEREZ FRANCISCO ASIS. Secretario: MORA PEREZ FRANCISCO ASIS. Consejero:MORENO MANTECON MIGUEL;PARDO RUIZ MIGUEL;LUQUE LUQUE ANTONIO;MORENO MENDEZ MIGUEL ANGEL;BERNALLOPEZ JUAN RAMON. Cons.Del.Man: MORENO MANTECON BALDOMERO;LUQUE LUQUE ANTONIO. Datos registrales. T 2277, F 151, S 8, H CO 32019, I/A 1 (12.04.12).