Buscador CIF Logo

Actos BORME Agrocinegetica San Huberto Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Agrocinegetica San Huberto Sl

Actos BORME Agrocinegetica San Huberto Sl - B14013783

Tenemos registrados 14 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Agrocinegetica San Huberto Sl con CIF B14013783

馃敊 Perfil de Agrocinegetica San Huberto Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Agrocinegetica San Huberto Sl

06 de Mayo de 2022
Nombramientos. Apo.Man.Soli: RUBIO MERINO ANTONIO. Datos registrales. T 27691 , F 223, S 8, H M 395182, I/A 25 (28.04.22).

31 de Marzo de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANCHEZ RANERO JUAN CARLOS. Apoderado: SANCHEZ RANERO JUAN CARLOS. Apo.Man.Soli:SANCHEZ RANERO JUAN CARLOS. Apoderado: SANCHEZ RANERO JUAN CARLOS. Apo.Man.Soli: SANCHEZ RANERO JUANCARLOS. Datos registrales. T 27691 , F 222, S 8, H M 395182, I/A 23 (24.03.21).

Cambio de domicilio social. C/ SANTA SABINA 8 2陋 (MADRID). Datos registrales. T 27691 , F 223, S 8, H M 395182, I/A 24(24.03.21).

24 de Julio de 2017
Nombramientos. Apoderado: GUERRA GARCIA FRANCISCO JAVIER;FERNANDEZ ALONSO LORENZO. Datos registrales. T27691 , F 220, S 8, H M 395182, I/A 22 (17.07.17).

31 de Octubre de 2014
Otros conceptos: SUBSANACION DE LA INSCRIPCION 20&.- Datos registrales. T 27691 , F 216, S 8, H M 395182, I/A 21(24.10.14).

24 de Julio de 2014
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GIMENO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER;SANCHEZ RANERO JUAN CARLOS. Datosregistrales. T 27691 , F 213, S 8, H M 395182, I/A 20 (17.07.14).

21 de Enero de 2014
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 14.467.743,68 Euros. Resultante Suscrito: 4.548.810,24 Euros. Datos registrales. T27691 , F 213, S 8, H M 395182, I/A 19 (14.01.14).

24 de Diciembre de 2012
Nombramientos. Apoderado: DE BORBON DOS SICILIAS Y DE ORLEANS PEDRO JUAN. Datos registrales. T 27691 , F 212, S 8,H M 395182, I/A 17 (14.12.12).

Nombramientos. Apo.Manc.: DE BORBON DOS SICILIAS Y DE ORLEANS PEDRO JUAN;MORALES MORALES ALFONSO. Datosregistrales. T 27691 , F 212, S 8, H M 395182, I/A 18 (14.12.12).

19 de Diciembre de 2011
Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 140 11潞 B (MADRID). Datos registrales. T 27691 , F 212, S 8, H M395182, I/A 16 ( 2.12.11).

05 de Noviembre de 2010
Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA NUMERO 140, 10潞 B (MADRID). Datos registrales. T 27691 , F 211, S8, H M 395182, I/A 15 (25.10.10).

16 de Julio de 2010
Ampliaci贸n de capital. Capital: 15.000.003,90 Euros. Resultante Suscrito: 19.016.553,92 Euros. Datos registrales. T 22149 , F 59,S 8, H M 395182, I/A 14 ( 6.07.10).

24 de Marzo de 2010
Revocaciones. Apoderado: LOPEZ IBOR ALCOCER JAIME. Nombramientos. Apoderado: EGIDO VOLLANDT INES. Datosregistrales. T 22149 , F 55, S 8, H M 395182, I/A 13 (12.03.10).

27 de Enero de 2009
Cambio de domicilio social. PLAZA MARQUES DE SALAMANCA 10 - BAJO IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 22149 ,F 55, S 8, H M 395182, I/A 12 (15.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n