Buscador CIF Logo

Actos BORME Agropecuaria Obanos Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Agropecuaria Obanos Sa

Actos BORME Agropecuaria Obanos Sa - A31424468

Tenemos registrados 21 Actos BORME del Registro Mercantil de Navarra para Agropecuaria Obanos Sa con CIF A31424468

馃敊 Perfil de Agropecuaria Obanos Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Navarra

Actos BORME de Agropecuaria Obanos Sa

24 de Enero de 2023
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: AGROPECUARIA ALESVES SL. Datos registrales. T 791 , F 146, S 8, H NA 5894,I/A 54 (16.01.23).

05 de Agosto de 2022
Reelecciones. Auditor: OYON CONSULTORES-AUDITORES SLP. Datos registrales. T 791 , F 146, S 8, H NA 5894, I/A 53(28.07.22).

10 de Febrero de 2022
Nombramientos. Apoderado: TELLEZ MORENO ALFONSO CARLOS. Datos registrales. T 791 , F 145, S 8, H NA 5894, I/A 52 (1.02.22).

07 de Febrero de 2022
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SIGMA KREAS SL. Datos registrales. T 791 , F 143, S 8, H NA 5894, I/A 48(27.01.22).

Ceses/Dimisiones. Consejero: URDANOZ ERVITI MARTIN;TARRAFETA RUBIO LUIS ANTONIO;TARRAFETA SAYASPEDRO;SARRIES ULZURRUN JOSE JAVIER;PEREZ GUZMAN ISIDORO. Presidente: TARRAFETA SAYAS PEDRO. Con.Delegado:URDANOZ ERVITI MARTIN. Consejero: ERVITI RUIZ ANA MARIA. SecreNoConsj: LARRAYOZ MAQUIRRIAIN ALBERTO.Nombramientos. Adm. Unico: SIGMA KREAS SL. Modificaciones estatutarias. Modificado el art铆culo 12潞 de los estatutos socialesrelativo al funcionamiento del 贸rgano de administraci贸n. Otros conceptos: RATIFICAR todos los actos realizados por el 贸rgano deadministraci贸n cesado Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. La sociedad "SIGMAKREAS SL" DESIGNO persona f铆sica representante para el ejercicio del cargo a DON PEDRO MANUEL TARRAFETA SAYAS. Datosregistrales. T 791 , F 143, S 8, H NA 5894, I/A 49 (27.01.22).

Revocaciones. Apoderado: PEREZ GUZMAN ISIDORO;TARRAFETA RUBIO LUIS;URDANOZ OYARZUN JAVIER. Datosregistrales. T 791 , F 144, S 8, H NA 5894, I/A 50 (27.01.22).

Nombramientos. Apoderado: ORONSOSPE BARBARIN JESUS FELIPE. Datos registrales. T 791 , F 144, S 8, H NA 5894, I/A 51(27.01.22).

30 de Diciembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Auditor: AMATRIAIN ARRULA JOSE MANUEL. Nombramientos. Auditor: OYON CONSULTORES-AUDITORES SLP. Datos registrales. T 791 , F 143, S 8, H NA 5894, I/A 47 (19.12.19).

23 de Noviembre de 2018
Reelecciones. Auditor: AMATRIAIN ARRULA JOSE MANUEL. Aud.Supl.: FERNANDEZ OYON I脩AKI. Datos registrales. T 791 , F143, S 8, H NA 5894, I/A 46 ( 8.11.18).

17 de Agosto de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: URDANOZ OYARZUN FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Consejero: ERVITI RUIZ ANAMARIA. Datos registrales. T 791 , F 142, S 8, H NA 5894, I/A 45 ( 8.08.17).

16 de Noviembre de 2016
Nombramientos. Con.Delegado: URDANOZ ERVITI MARTIN. Datos registrales. T 791 , F 142, S 8, H NA 5894, I/A 44 ( 7.11.16).

25 de Octubre de 2016
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: URDANOZ ERVITI MARTIN. SecreNoConsj: LARRAYOZ MAQUIRRIAIN ALBERTO.Nombramientos. SecreNoConsj: LARRAYOZ MAQUIRRIAIN ALBERTO. Reelecciones. Consejero: URDANOZ OYARZUNFRANCISCO JAVIER;URDANOZ ERVITI MARTIN;TARRAFETA RUBIO LUIS ANTONIO;TARRAFETA SAYAS PEDRO;SARRIESULZURRUN JOSE JAVIER;PEREZ GUZMAN ISIDORO. Presidente: TARRAFETA SAYAS PEDRO. Datos registrales. T 791 , F 142,S 8, H NA 5894, I/A 43 (17.10.16).

23 de Noviembre de 2015
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 380.251,42 Euros. Desembolsado: 380.251,42 Euros. Resultante Suscrito: 953.040,00 Euros.Resultante Desembolsado: 953.040,00 Euros. Datos registrales. T 272 , F 13, S 8, H NA 5894, I/A 41 (12.11.15).

Ceses/Dimisiones. Aud.Supl.: INDURAIN ARRUE JESUS MARIA. Nombramientos. Aud.Supl.: FERNANDEZ OYON I脩AKI.Reelecciones. Auditor: AMATRIAIN ARRULA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 791 , F 142, S 8, H NA 5894, I/A 42 (12.11.15).

21 de Mayo de 2015
Ceses/Dimisiones. Presidente: URDANOZ OYARZUN FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Presidente: TARRAFETA SAYASPEDRO. Datos registrales. T 272 , F 13, S 8, H NA 5894, I/A 40 ( 5.05.15).

18 de Marzo de 2015
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 34.365,87 Euros. Datos registrales. T 272 , F 13, S 8, H NA 5894, I/A 39 (3.03.15).

05 de Noviembre de 2012
Reelecciones. Auditor: AMATRIAIN ARRULA JOSE MANUEL. Aud.Supl.: INDURAIN ARRUE JESUS MARIA. Datos registrales. T272 , F 13, S 8, H NA 5894, I/A 38 (13.10.12).

05 de Septiembre de 2011
Reelecciones. Auditor: AMATRIAIN ARRULA JOSE MANUEL. Aud.Supl.: INDURAIN ARRUE JESUS MARIA. Datos registrales. T272 , F 13, S 8, H NA 5894, I/A 37 (23.08.11).

13 de Diciembre de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: TARRAFETA RUBIO LUIS ANTONIO. Presidente: TARRAFETA RUBIO LUIS ANTONIO. Consejero:TARRAFETA SAYAS PEDRO;URDANOZ ERVITI MARTIN. Secretario: URDANOZ ERVITI MARTIN. Consejero: URDANOZOYARZUN FRANCISCO JAVIER. Cons.Delegad: URDANOZ OYARZUN FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Consejero:URDANOZ OYARZUN FRANCISCO JAVIER;URDANOZ ERVITI MARTIN;TARRAFETA RUBIO LUIS ANTONIO;TARRAFETA SAYASPEDRO;SARRIES ULZURRUN JOSE JAVIER;PEREZ GUZMAN ISIDORO. Presidente: URDANOZ OYARZUN FRANCISCO JAVIER.Scr:no.Cons: LARRAYOZ MAQUIRRIAIN ALBERTO. Cons.Delegad: URDANOZ ERVITI MARTIN. Datos registrales. T 272 , F 12, S8, H NA005894, I/A00036 (26.11.10).

29 de Julio de 2010
Reelecciones. Auditor Titu: AMATRIAIN ARRULA JOSE MANUEL. Auditor Sup.: INDURAIN ARRUE JESUS MARIA. Datosregistrales. T 272 , F 12, S 8, H NA005894, I/A00035 (17.07.10).

27 de Octubre de 2009
Reelecciones. Auditor Titu: AMATRIAIN ARRULA JOSE MANUEL. Auditor Sup.: INDURAIN ARRUE JESUS MARIA. Datosregistrales. T 272 , F 12, S 8, H NA005894, I/A00034 (16.10.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n