Actos BORME de Agrupacion Prensa Independiente Y Libre April Sa
04 de Noviembre de 2019Reelecciones. Adm. Unico: ALDEA GARCIA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 29272 , F 14, S 8, H M 208816, I/A 21(25.10.19).
11 de Marzo de 2014Reelecciones. Adm. Unico: ALDEA GARCIA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 29272 , F 13, S 8, H M 208816, I/A 20(28.02.14).
02 de Noviembre de 2011Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 6.554.198,56 Euros. Resultante Suscrito: 3.122.096,29 Euros. Ampliaci贸n de capital.Suscrito: 3.606.072,80 Euros. Desembolsado: 3.606.072,80 Euros. Resultante Suscrito: 6.728.169,09 Euros. ResultanteDesembolsado: 6.728.169,09 Euros. Otros conceptos: SE MODIFICAN, PRORROGANDOLOS, LOS PLAZOS PARA EL
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 984.991,33 Euros. Desembolsado: 984.991,33 Euros. Resultante Suscrito: 7.713.160,42 Euros.Resultante Desembolsado: 7.713.160,42 Euros. Otros conceptos: SE CESA EL 2/1/2008, A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DEADMINISTRACION NOMBRADOS EN EL A脩O 2004: DO脩A ANA MARIA DE LAS MERCEDES CORT GOMEZ TORTOSA, DONJOSE LUIS BALBIN MEANA, DON LUISGONZALEZ SEARA, DON JOSE LUIS MERINO GARCIA CIA脩O, DO脩A LAURA ROIGSORO Y DON JOAQUIN RUIZ GIMENEZ AGUILAR.SE NOMBRA DESDE EL 2/1/2008, POR CINCO A脩OS, UN NUEVO CONSEJODE ADMINISTRACION: PRESIDENTE: DON JOSE LUIS BALBIN MEANA; SECRETARIO: DON JOAQUIN RUIZ GIMENEZ AGUILAR;VOCALES: DO脩A LAURA ROIG SORO y DON LUIS GONZALEZ SEARA. Y SE DESIGNA COMO CONSEJERO DELEGADO A DONJOAQUIN RUIZ GIMENEZ AGUILAR. Datos registrales. T 29272 , F 10, S 8, H M 208816, I/A 16 (20.10.11).
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 814.982,68 Euros. Desembolsado: 814.982,68 Euros. Resultante Suscrito: 8.528.143,10 Euros.Resultante Desembolsado: 8.528.143,10 Euros. Datos registrales. T 29272 , F 11, S 8, H M 208816, I/A 17 (21.10.11).
Cambio de domicilio social. C/ SANTISIMA TRINIDAD, NUMERO 22, 8潞 B (MADRID). Datos registrales. T 29272 , F 13, S 8, H M208816, I/A 18 (21.10.11).
Revocaciones. Apoderado: MESAS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 29272 , F 13, S 8, H M 208816, I/A 19(21.10.11).
31 de Octubre de 2011Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 2.704.554,45 Euros. Datos registrales. T 12961 , F 30, S 8, H M 208816, I/A14 (20.10.11).
26 de Noviembre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: CORT GOMEZ TORTOSA MERCEDES. Presidente: CORT GOMEZ TORTOSA MERCEDES.Consejero: BALBIN MEANA JOSE LUIS. Vicepresid.: BALBIN MEANA JOSE LUIS. Consejero: RUIZ-GIMENEZ AGUILAR JOAQUIN.Secretario: RUIZ-GIMENEZ AGUILAR JOAQUIN. Consejero: GONZALEZ SEARA LUIS;ROIG SORO LAURA;MERINO GARCIA-CIA脩O JOSE-LUIS. Cons.Del.Sol: RUIZ-GIMENEZ AGUILAR JOAQUIN. Nombramientos. Adm. Unico: ALDEA GARCIAFRANCISCO JAVIER. Modificaciones estatutarias. SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19 Y 20 DE LOSESTATUTOS SOCIALES..Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datosregistrales. T 12961 , F 30, S 8, H M 208816, I/A 13 (13.11.09).